A TO Z AUTOPARTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | A TO Z AUTOPARTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02504624 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di A TO Z AUTOPARTS LIMITED?
- Commercio all'ingrosso di parti e accessori per autoveicoli (45310) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova A TO Z AUTOPARTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | No 1 Colmore Square Birmingham B4 6AA |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di A TO Z AUTOPARTS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per A TO Z AUTOPARTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jean-Jacques Mathieu Lafont come amministratore in data 19 ott 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr John Frederick Coombes come amministratore in data 19 ott 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alistair Stuart Brown come amministratore in data 19 ott 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 31 dic 2017, non revisionato | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Alistair Stuart Brown il 02 lug 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 mag 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Notifica di Alliance Automotive Uk Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2013 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2012 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 mag 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2011 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 mag 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2010 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di John Coombes come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Jean-Jacques Mathieu Lafont come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di A TO Z AUTOPARTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOMBES, John Frederick | Segretario | Occupation Road Lindley HD3 3AZ Huddersfield 4 United Kingdom | British | 74985930001 | ||||||
| COOMBES, John Frederick | Amministratore | No 1 Colmore Square Birmingham B4 6AA | England | British | 74985930002 | |||||
| BENZIE, Shane | Segretario | No.4 Bridge Cottages RG8 7DE Whitchurch On Thames Reading | British | 172116460001 | ||||||
| HENRY, Caroline | Segretario | 25 Argood Close RG145BX Thatcham Berkshire | British | 38456980002 | ||||||
| BENZIE, Shane | Amministratore | No.4 Bridge Cottages RG8 7DE Whitchurch On Thames Reading | United Kingdom | British | 172116460001 | |||||
| BROWN, Alistair Stuart | Amministratore | No 1 Colmore Square Birmingham B4 6AA | Switzerland | New Zealander | 115184770002 | |||||
| COOMBES, John Frederick | Amministratore | Occupation Road Lindley HD3 3AZ Huddersfield 4 | England | British | 74985930002 | |||||
| HENRY, Caroline | Amministratore | 31 Mortons Lane RG7 6QQ Upper Bucklebury Berkshire | British | 60293710003 | ||||||
| HENRY, Stephen | Amministratore | 31 Mortons Lane RG7 6QQ Upper Bucklebury Berkshire | British | 71709180004 | ||||||
| HENRY, Stephen | Amministratore | 25 Argood Close RG145BX Thatcham Berkshire | British | 71709180001 | ||||||
| LAFONT, Jean-Jacques Mathieu | Amministratore | No 1 Colmore Square Birmingham B4 6AA | Switzerland | Belgian | 62978960003 | |||||
| STOUT, Paul Alexander | Amministratore | 28 Water Road RG30 2NN Reading Berkshire | British | 81644860001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di A TO Z AUTOPARTS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliance Automotive Uk Limited | 06 apr 2016 | Colmore Square B4 6AA Birmingham No.1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
A TO Z AUTOPARTS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 25 mar 2004 Consegnato il 01 apr 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The f/h properties k/a 16 station road thatcham RG13 4PR and 18 station road thatcham RG13 4PR. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 18 feb 2004 Consegnato il 25 feb 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 15 lug 2003 Consegnato il 17 lug 2003 | In corso | Importo garantito £4,500.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The sum of £4,500. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 25 mar 1997 Consegnato il 27 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Norfolk house 16-18 station road thatcham berkshire (freehold). With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property; any shares or membership rights in any management company for the property; any goodwill of any business from time to time carried on at the property; any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property; and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 01 ott 1996 Consegnato il 11 ott 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee whether under a supply agreement dated 29TH april 1991 or otherwise | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 23 mar 1995 Consegnato il 25 mar 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 13 nov 1990 Consegnato il 16 nov 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge over all book debts and other debts owing to the company floating charge over all undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital (excluding those mentioned above). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0