NEW MALDEN HOUSE LIMITED
Panoramica
Nome della società | NEW MALDEN HOUSE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02505599 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di NEW MALDEN HOUSE LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova NEW MALDEN HOUSE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 86 Bondway SW8 1SF London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di NEW MALDEN HOUSE LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
TILEPORT LIMITED | 24 mag 1990 | 24 mag 1990 |
Quali sono gli ultimi bilanci di NEW MALDEN HOUSE LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per NEW MALDEN HOUSE LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per NEW MALDEN HOUSE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Erik Henry Klotz il 01 ott 2015 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 dic 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Fredrik Jonas Widlund come amministratore in data 06 nov 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Simon Laborda Wigzell come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Tice come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 dic 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard James Sunley Tice il 14 ott 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 dic 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 dic 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard James Sunley Tice il 10 gen 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Erik Henry Klotz il 10 gen 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 dic 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Erik Henry Klotz il 29 set 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Tom Wills come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Richard James Sunley Tice come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di NEW MALDEN HOUSE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULLER, David Francis | Segretario | Bondway SW8 1SF London 86 United Kingdom | British | 136910120001 | ||||||
KLOTZ, Erik Henry | Amministratore | Bondway SW8 1SF London 86 | United Kingdom | Swedish | Executive Vice Chairman | 130193210006 | ||||
MILLET, Alain Gustave Paul | Amministratore | Bondway SW8 1SF London 86 United Kingdom | England | French | Group Treasurer | 126567290001 | ||||
WHITELEY, John Howard | Amministratore | Bondway SW8 1SF London 86 United Kingdom | England | British | Chief Financial Officer | 48980090003 | ||||
WIDLUND, Fredrik Jonas | Amministratore | Bondway SW8 1SF London 86 | United Kingdom | Swedish | Company Director | 166751920001 | ||||
WIGZELL, Simon Laborda | Amministratore | Bondway SW8 1SF London 86 United Kingdom | England | British | Company Director | 95788510001 | ||||
BOARD, Steven Francis | Segretario | Tawlbrook, Plaistow Road Loxwood RH14 0TY Billingshurst West Sussex | British | 17793520002 | ||||||
GHINN, Sarah | Segretario | 69 Thrale Road Streatham SW16 1NU London | British | Deputy Group Secretary | 82906760001 | |||||
THOMSON, Thomas John | Segretario | Pulridge Wood Nettleden Road HP4 1PP Little Gaddesden Hertfordshire | British | Company Secretary | 21940550003 | |||||
TAYLOR WALTON SOLICITORS | Segretario | 65 High Street AL5 2SW Harpenden Hertfordshire | 7587220002 | |||||||
BAVERSTAM, Dan Mikael | Amministratore | Apartment 50 Fountain House The Boulevard Imperial Wharf SW6 2TQ London | Swedish | Chief Financial Officer | 33932550003 | |||||
BOARD, Steven Francis | Amministratore | Tawlbrook, Plaistow Road Loxwood RH14 0TY Billingshurst West Sussex | England | British | Chief Operating Officer | 17793520002 | ||||
CHAPMAN, Kevin Edward | Amministratore | Fonthill House 21 Old Holt Road, Medbourne LE16 8DY Market Harborough Leicestershire | British | Property Director | 126351470001 | |||||
HIRSCH, Glyn Vincent | Amministratore | 15 Clare Lawn Avenue SW14 8BE London | England | British | Chief Executive | 48114050001 | ||||
LUNDQVIST, Hans Otto Thomas | Amministratore | 9 Spencer Gardens SW14 7AH London | Swedish | Director | 44013990001 | |||||
MORTSTEDT, Bengt Filip | Amministratore | 21 Mulberry Walk SW3 6DZ London | Swedish | Director | 2067060001 | |||||
SJOBERG, Per Henrik | Amministratore | 78 Madrid Road Barnes SW13 9PG London | Swedish | Chief Executive Officer | 103990330002 | |||||
THOMSON, Thomas John | Amministratore | Pulridge Wood Nettleden Road HP4 1PP Little Gaddesden Hertfordshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 21940550003 | ||||
THOMSON, Thomas John | Amministratore | Pulridge Wood Nettleden Road HP4 1PP Little Gaddesden Hertfordshire | United Kingdom | British | Solicitor | 21940550003 | ||||
TICE, Richard James Sunley | Amministratore | Bondway SW8 1SF London 86 United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 151240670006 | ||||
WILLS, Tom Julian Lynall | Amministratore | Bondway SW8 1SF London 86 United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 114288290001 |
NEW MALDEN HOUSE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and security interest agreement | Creato il 15 set 2006 Consegnato il 02 ott 2006 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The securities and the related rights, securities meaning, 4,001,583 ordinary shares of £1 each in the company, 84 non-voting shares of £1 each in the company. Related rights means assets or rights, monies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 08 lug 1994 Consegnato il 26 lug 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor (as defined therein) to the chargee on any account whatsoever under the terms of each finance document (as defined) | |
Brevi particolari F/H property k/a spiller's house, 120-130 (even numbers) high street, new malden and land at the rear of 132 high street, new malden t/no. SY251080. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture, as evidenced by a statutory declaration dated 28/1/93 | Creato il 11 gen 1993 Consegnato il 25 gen 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of each finance document to which the company is a party | |
Brevi particolari By way of a second legal mortgage all that f/h property k/a new malden house, 120-130 (even numbers) high street, new malden and land at the rear of 132 high street, new malden - title no. SY251080 (see form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 13 mar 1992 Consegnato il 18 mar 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 6/3/92 as amended from time to time and this charge and under the terms of the financing documents or the security documents (as therein defined)or any othr security | |
Brevi particolari F/H 120-130 (even) high street new malden surrey t/n sy 251080 all buildings fixtures and fittings plant and machinery (see form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 13 mar 1992 Consegnato il 18 mar 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from central london securities limited to the chargee under the terms of an undertaking dated 1/8/90 and the charge | |
Brevi particolari A second legal mortgage over f/h property k/a 120-130 (even )high street new malden and land at the rear of 132 high street aforesaid t/n SY251080 floating charge over the. Undertaking and all property and assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 05 nov 1990 Consegnato il 23 nov 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from samermon investments limited to the chargee under the terms of a facility letter dated 23/6/90 and a mortgage dated 28/6/89 | |
Brevi particolari L/H 120-130 (even nos) 124 (being shop & first front) 126-130 (being shop & first floor) high street new malden floating charge over the undertaking and all property and assets present and future (see form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0