NEW MALDEN HOUSE LIMITED

NEW MALDEN HOUSE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNEW MALDEN HOUSE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02505599
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NEW MALDEN HOUSE LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova NEW MALDEN HOUSE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    86 Bondway
    SW8 1SF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NEW MALDEN HOUSE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TILEPORT LIMITED24 mag 199024 mag 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di NEW MALDEN HOUSE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per NEW MALDEN HOUSE LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per NEW MALDEN HOUSE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 20 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 dic 2015

    Stato del capitale al 21 dic 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Erik Henry Klotz il 01 ott 2015

    3 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 dic 2014

    Stato del capitale al 22 dic 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Nomina di Mr Fredrik Jonas Widlund come amministratore in data 06 nov 2014

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    13 pagineAA

    Nomina di Simon Laborda Wigzell come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard Tice come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 20 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 dic 2013

    Stato del capitale al 31 dic 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard James Sunley Tice il 14 ott 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard James Sunley Tice il 10 gen 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Erik Henry Klotz il 10 gen 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Erik Henry Klotz il 29 set 2010

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Tom Wills come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Richard James Sunley Tice come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di NEW MALDEN HOUSE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FULLER, David Francis
    Bondway
    SW8 1SF London
    86
    United Kingdom
    Segretario
    Bondway
    SW8 1SF London
    86
    United Kingdom
    British136910120001
    KLOTZ, Erik Henry
    Bondway
    SW8 1SF London
    86
    Amministratore
    Bondway
    SW8 1SF London
    86
    United KingdomSwedishExecutive Vice Chairman130193210006
    MILLET, Alain Gustave Paul
    Bondway
    SW8 1SF London
    86
    United Kingdom
    Amministratore
    Bondway
    SW8 1SF London
    86
    United Kingdom
    EnglandFrenchGroup Treasurer126567290001
    WHITELEY, John Howard
    Bondway
    SW8 1SF London
    86
    United Kingdom
    Amministratore
    Bondway
    SW8 1SF London
    86
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Financial Officer48980090003
    WIDLUND, Fredrik Jonas
    Bondway
    SW8 1SF London
    86
    Amministratore
    Bondway
    SW8 1SF London
    86
    United KingdomSwedishCompany Director166751920001
    WIGZELL, Simon Laborda
    Bondway
    SW8 1SF London
    86
    United Kingdom
    Amministratore
    Bondway
    SW8 1SF London
    86
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director95788510001
    BOARD, Steven Francis
    Tawlbrook, Plaistow Road
    Loxwood
    RH14 0TY Billingshurst
    West Sussex
    Segretario
    Tawlbrook, Plaistow Road
    Loxwood
    RH14 0TY Billingshurst
    West Sussex
    British17793520002
    GHINN, Sarah
    69 Thrale Road
    Streatham
    SW16 1NU London
    Segretario
    69 Thrale Road
    Streatham
    SW16 1NU London
    BritishDeputy Group Secretary82906760001
    THOMSON, Thomas John
    Pulridge Wood
    Nettleden Road
    HP4 1PP Little Gaddesden
    Hertfordshire
    Segretario
    Pulridge Wood
    Nettleden Road
    HP4 1PP Little Gaddesden
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary21940550003
    TAYLOR WALTON SOLICITORS
    65 High Street
    AL5 2SW Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    65 High Street
    AL5 2SW Harpenden
    Hertfordshire
    7587220002
    BAVERSTAM, Dan Mikael
    Apartment 50 Fountain House
    The Boulevard Imperial Wharf
    SW6 2TQ London
    Amministratore
    Apartment 50 Fountain House
    The Boulevard Imperial Wharf
    SW6 2TQ London
    SwedishChief Financial Officer33932550003
    BOARD, Steven Francis
    Tawlbrook, Plaistow Road
    Loxwood
    RH14 0TY Billingshurst
    West Sussex
    Amministratore
    Tawlbrook, Plaistow Road
    Loxwood
    RH14 0TY Billingshurst
    West Sussex
    EnglandBritishChief Operating Officer17793520002
    CHAPMAN, Kevin Edward
    Fonthill House
    21 Old Holt Road, Medbourne
    LE16 8DY Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Fonthill House
    21 Old Holt Road, Medbourne
    LE16 8DY Market Harborough
    Leicestershire
    BritishProperty Director126351470001
    HIRSCH, Glyn Vincent
    15 Clare Lawn Avenue
    SW14 8BE London
    Amministratore
    15 Clare Lawn Avenue
    SW14 8BE London
    EnglandBritishChief Executive48114050001
    LUNDQVIST, Hans Otto Thomas
    9 Spencer Gardens
    SW14 7AH London
    Amministratore
    9 Spencer Gardens
    SW14 7AH London
    SwedishDirector44013990001
    MORTSTEDT, Bengt Filip
    21 Mulberry Walk
    SW3 6DZ London
    Amministratore
    21 Mulberry Walk
    SW3 6DZ London
    SwedishDirector2067060001
    SJOBERG, Per Henrik
    78 Madrid Road
    Barnes
    SW13 9PG London
    Amministratore
    78 Madrid Road
    Barnes
    SW13 9PG London
    SwedishChief Executive Officer103990330002
    THOMSON, Thomas John
    Pulridge Wood
    Nettleden Road
    HP4 1PP Little Gaddesden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Pulridge Wood
    Nettleden Road
    HP4 1PP Little Gaddesden
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChief Executive21940550003
    THOMSON, Thomas John
    Pulridge Wood
    Nettleden Road
    HP4 1PP Little Gaddesden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Pulridge Wood
    Nettleden Road
    HP4 1PP Little Gaddesden
    Hertfordshire
    United KingdomBritishSolicitor21940550003
    TICE, Richard James Sunley
    Bondway
    SW8 1SF London
    86
    United Kingdom
    Amministratore
    Bondway
    SW8 1SF London
    86
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive Officer151240670006
    WILLS, Tom Julian Lynall
    Bondway
    SW8 1SF London
    86
    United Kingdom
    Amministratore
    Bondway
    SW8 1SF London
    86
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant114288290001

    NEW MALDEN HOUSE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and security interest agreement
    Creato il 15 set 2006
    Consegnato il 02 ott 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The securities and the related rights, securities meaning, 4,001,583 ordinary shares of £1 each in the company, 84 non-voting shares of £1 each in the company. Related rights means assets or rights, monies. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 02 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 08 lug 1994
    Consegnato il 26 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (as defined therein) to the chargee on any account whatsoever under the terms of each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    F/H property k/a spiller's house, 120-130 (even numbers) high street, new malden and land at the rear of 132 high street, new malden t/no. SY251080. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft, London Branch
    Transazioni
    • 26 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture, as evidenced by a statutory declaration dated 28/1/93
    Creato il 11 gen 1993
    Consegnato il 25 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of each finance document to which the company is a party
    Brevi particolari
    By way of a second legal mortgage all that f/h property k/a new malden house, 120-130 (even numbers) high street, new malden and land at the rear of 132 high street, new malden - title no. SY251080 (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 13 mar 1992
    Consegnato il 18 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 6/3/92 as amended from time to time and this charge and under the terms of the financing documents or the security documents (as therein defined)or any othr security
    Brevi particolari
    F/H 120-130 (even) high street new malden surrey t/n sy 251080 all buildings fixtures and fittings plant and machinery (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Gota Bank
    Transazioni
    • 18 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 mar 1992
    Consegnato il 18 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from central london securities limited to the chargee under the terms of an undertaking dated 1/8/90 and the charge
    Brevi particolari
    A second legal mortgage over f/h property k/a 120-130 (even )high street new malden and land at the rear of 132 high street aforesaid t/n SY251080 floating charge over the. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Sparbankernas Bank
    Transazioni
    • 18 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 nov 1990
    Consegnato il 23 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from samermon investments limited to the chargee under the terms of a facility letter dated 23/6/90 and a mortgage dated 28/6/89
    Brevi particolari
    L/H 120-130 (even nos) 124 (being shop & first front) 126-130 (being shop & first floor) high street new malden floating charge over the undertaking and all property and assets present and future (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Gata Bank
    Transazioni
    • 23 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 14 ott 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0