THE INSTITUTE OF ENTERTAINMENT AND ARTS MANAGEMENT

THE INSTITUTE OF ENTERTAINMENT AND ARTS MANAGEMENT

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE INSTITUTE OF ENTERTAINMENT AND ARTS MANAGEMENT
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale, esenzione dall'uso di 'Limited'
    Numero di società 02506887
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE INSTITUTE OF ENTERTAINMENT AND ARTS MANAGEMENT?

    • Altra istruzione n.c.a. (85590) / Istruzione

    Dove si trova THE INSTITUTE OF ENTERTAINMENT AND ARTS MANAGEMENT?

    Indirizzo della sede legale
    72 Percheron Road
    WD6 2SR Borehamwood
    Hertfordshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE INSTITUTE OF ENTERTAINMENT AND ARTS MANAGEMENT?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE INSTITUTE OF ENTERTAINMENT AND ARTS PROFESSIONALS14 nov 200714 nov 2007
    THE INSTITUTE OF ENTERTAINMENT AND ARTS MANAGEMENT30 mag 199030 mag 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE INSTITUTE OF ENTERTAINMENT AND ARTS MANAGEMENT?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per THE INSTITUTE OF ENTERTAINMENT AND ARTS MANAGEMENT?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per THE INSTITUTE OF ENTERTAINMENT AND ARTS MANAGEMENT?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2014

    2 pagineAA

    Bilancio modificato di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2013

    1 pagineAAMD

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O the Administrator 5 Sussex Place Slough Berkshire SL1 1NH a 72 Percheron Road Borehamwood Hertfordshire WD6 2SR in data 28 lug 2014

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Richard Hayward Bradshaw come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2013

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2014, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di Brian Goddard come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2013, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2012

    3 pagineAA

    Nomina di Mr Brian Goddard come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2012, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    3 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 17 Drake Close Horsham West Sussex RH12 5UB England

    1 pagineAD02

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2011

    3 pagineAA

    Nomina di Mr Michael John Anderson come amministratore

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 17 Drake Close Horsham West Sussex RH12 5UB* in data 30 gen 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2010

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2011, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    3 pagineAR01

    Cessazione della carica di Charles Shaw come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2010, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    4 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    Dettagli del segretario cambiati per Raymond Daynes il 04 gen 2010

    1 pagineCH03

    Chi sono gli amministratori di THE INSTITUTE OF ENTERTAINMENT AND ARTS MANAGEMENT?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAYNES, Raymond
    Percheron Road
    WD6 2SR Borehamwood
    72
    Hertfordshire
    England
    Segretario
    Percheron Road
    WD6 2SR Borehamwood
    72
    Hertfordshire
    England
    British48023900001
    ANDERSON, Michael John
    Appledore Road
    Twydall
    ME8 6AA Gillingham
    19
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Appledore Road
    Twydall
    ME8 6AA Gillingham
    19
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish167897710001
    BRADSHAW, Richard Hayward
    Hunter Close
    Balham
    SW12 8EQ London
    19
    England
    Amministratore
    Hunter Close
    Balham
    SW12 8EQ London
    19
    England
    United KingdomBritish186758260001
    DAYNES, Raymond
    72 Percheron Road
    WD6 2SR Borehamwood
    Hertfordshire
    Amministratore
    72 Percheron Road
    WD6 2SR Borehamwood
    Hertfordshire
    Great BritainBritish48023900001
    DAYNES, Raymond
    72 Percheron Road
    WD6 2SR Borehamwood
    Hertfordshire
    Segretario
    72 Percheron Road
    WD6 2SR Borehamwood
    Hertfordshire
    British48023900001
    EVANS, Elaine
    6 Mayford Close
    Mayford
    GU22 9QS Woking
    Surrey
    Segretario
    6 Mayford Close
    Mayford
    GU22 9QS Woking
    Surrey
    British112366600001
    WASHER, Patricia Louise
    11 Mobbsbury Way
    SG2 0HL Stevenage
    Hertfordshire
    Segretario
    11 Mobbsbury Way
    SG2 0HL Stevenage
    Hertfordshire
    British125866480001
    WATSON, Frank Ian
    3 Trinity Road
    YO11 2TD Scarborough
    North Yorkshire
    Segretario
    3 Trinity Road
    YO11 2TD Scarborough
    North Yorkshire
    British23782830001
    ARNOTT, Gail Elizabeth
    The Old Rectory
    Church Street North Luffenham
    LE9 4FG Oakham
    Leicestershire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Church Street North Luffenham
    LE9 4FG Oakham
    Leicestershire
    EnglandBritish177809520001
    BAILEY, Peter John
    27 Ophir Road
    BN11 2SS Worthing
    West Sussex
    Amministratore
    27 Ophir Road
    BN11 2SS Worthing
    West Sussex
    British38304370001
    BAILEY, Peter John
    27 Ophir Road
    BN11 2SS Worthing
    West Sussex
    Amministratore
    27 Ophir Road
    BN11 2SS Worthing
    West Sussex
    British38304370001
    BLOSSE, Andrew John Oliver
    136 Timber Mill
    Southwater
    RH13 7SR Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    136 Timber Mill
    Southwater
    RH13 7SR Horsham
    West Sussex
    British27870990001
    BOWLER, Alan Peter
    23 Puttingthorpe Drive
    BS22 8LE Weston Super Mare
    North Somerset
    Amministratore
    23 Puttingthorpe Drive
    BS22 8LE Weston Super Mare
    North Somerset
    British48023960001
    BUSTANCE, Robert William
    5 New Road
    Clifton
    SG17 5JH Shefford
    Bedfordshire
    Amministratore
    5 New Road
    Clifton
    SG17 5JH Shefford
    Bedfordshire
    EnglandBritish71584250001
    CANDLER, George
    5 Ewood Cottages
    Midgley Road
    HX7 5QU Hebden Bridge
    West Yorkshire
    Amministratore
    5 Ewood Cottages
    Midgley Road
    HX7 5QU Hebden Bridge
    West Yorkshire
    British84529630001
    CRESSWELL, Peter Frank
    1 Troutbeck Avenue
    CV32 6NE Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    1 Troutbeck Avenue
    CV32 6NE Leamington Spa
    Warwickshire
    British27870980001
    DAVIES, Russell Frank
    Chess Lodge 63 Amersham Road
    Little Chalfont
    HP6 6SW Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Chess Lodge 63 Amersham Road
    Little Chalfont
    HP6 6SW Amersham
    Buckinghamshire
    British48023980002
    DAYNES, Raymond
    72 Percheron Road
    WD6 2SR Borehamwood
    Hertfordshire
    Amministratore
    72 Percheron Road
    WD6 2SR Borehamwood
    Hertfordshire
    Great BritainBritish48023900001
    GILL, Glenys Anne
    20 Fair View
    Colerne
    SN14 8BS Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    20 Fair View
    Colerne
    SN14 8BS Chippenham
    Wiltshire
    EnglandBritish64754490001
    GODDARD, Brian
    Llandyssil
    SY15 6LG Montgomery
    Oak House
    Powys
    Wales
    Amministratore
    Llandyssil
    SY15 6LG Montgomery
    Oak House
    Powys
    Wales
    WalesBritish172259880001
    GODDARD, Brian
    The Covert 30 Reynards Coppice
    Great Hay Park Great Hay
    TF7 4NJ Telford
    Salop
    Amministratore
    The Covert 30 Reynards Coppice
    Great Hay Park Great Hay
    TF7 4NJ Telford
    Salop
    British49944130001
    GOLD, Stephen
    The Barn
    216 Thames Side
    TW18 1UQ Staines
    Middlesex
    Amministratore
    The Barn
    216 Thames Side
    TW18 1UQ Staines
    Middlesex
    British66452880004
    GRAY, David
    24 Huddersfield Road
    OL3 5EG Delph
    Lancashire
    Amministratore
    24 Huddersfield Road
    OL3 5EG Delph
    Lancashire
    British100318660001
    HART, Vanessa
    The Boardwalk 6 Marine View
    St. Marys Island
    ME4 3LA Chatham
    Kent
    Amministratore
    The Boardwalk 6 Marine View
    St. Marys Island
    ME4 3LA Chatham
    Kent
    British68200140001
    HAYLETT, Christopher Mark
    1 Mellings Wood
    FY8 3DW St Annes
    Lancashire
    Amministratore
    1 Mellings Wood
    FY8 3DW St Annes
    Lancashire
    British110943410001
    JENKINS, Angela
    185 Syon Lane
    TW7 5PU Isleworth
    Middlesex
    Amministratore
    185 Syon Lane
    TW7 5PU Isleworth
    Middlesex
    British50742260001
    PRIDMORE, Brian
    59 St Christopher Avenue
    Penkhull
    ST4 5NA Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    59 St Christopher Avenue
    Penkhull
    ST4 5NA Stoke On Trent
    Staffordshire
    British27870950001
    ROBERTS, John Francis
    14 Rosemount Drive
    NN15 6EU Kettering
    Northamptonshire
    Amministratore
    14 Rosemount Drive
    NN15 6EU Kettering
    Northamptonshire
    United KingdomBritish16941730003
    SHAW, Charles William, Prof.
    Roman End
    Severn Street
    LN1 1SJ Lincoln
    Lincolnshire
    Amministratore
    Roman End
    Severn Street
    LN1 1SJ Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritish29401400002
    SHROUDER, Samuel John
    Lower Furlong
    Ilbert Road
    TQ7 3NY Thurlestone
    Devon
    Amministratore
    Lower Furlong
    Ilbert Road
    TQ7 3NY Thurlestone
    Devon
    British110117070001
    STEWART, Nigel Howard
    16 Link Way
    TN2 3HE Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    16 Link Way
    TN2 3HE Tunbridge Wells
    Kent
    British27870970001
    TOLLIDAY, Margaret Joan
    1 Charity Cottages
    Lower Weald Calverton
    MK19 Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    1 Charity Cottages
    Lower Weald Calverton
    MK19 Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British12737430001
    TOWLER, Adrian Craig
    28 Gardner Road
    Portslade
    BN41 1PL Brighton
    East Sussex
    Amministratore
    28 Gardner Road
    Portslade
    BN41 1PL Brighton
    East Sussex
    British46639620002
    WELHAM, John David
    54 Beacon Way
    WD3 7PE Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    54 Beacon Way
    WD3 7PE Rickmansworth
    Hertfordshire
    British87560830001
    WYATT-GOLD, Robin Stephen
    25a High Street
    TW17 9AJ Shepperton
    Middlesex
    Amministratore
    25a High Street
    TW17 9AJ Shepperton
    Middlesex
    British66452880003

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0