INTERBUSINESS GROUP LIMITED

INTERBUSINESS GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàINTERBUSINESS GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale, esenzione dall'uso di 'Limited'
    Numero di società 02508309
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di INTERBUSINESS GROUP LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova INTERBUSINESS GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hart House Business Centre
    Kimpton Road
    LU2 0LB Luton
    Bedfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di INTERBUSINESS GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE BEDFORDSHIRE AND LUTON CHAMBER OF COMMERCE TRAINING AND ENTERPRISE LIMITED20 lug 199820 lug 1998
    BEDFORDSHIRE TRAINING AND ENTERPRISE COUNCIL04 giu 199004 giu 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di INTERBUSINESS GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per INTERBUSINESS GROUP LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per INTERBUSINESS GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Judy Oliver come amministratore in data 18 mar 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark West come amministratore in data 18 mar 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Keren Wilkins come amministratore in data 18 mar 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Richard Lewis Cooper come amministratore in data 18 mar 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Rodney John Calvert come amministratore in data 18 mar 2015

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2014

    20 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrew Robert Gilson come amministratore in data 02 ott 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Elliot Paul Renton come amministratore in data 02 ott 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 03 giu 2014, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    7 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * the Business Competitiveness Centre Kimpton Road Luton Bedfordshire LU2 0SX* in data 30 giu 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2013

    21 pagineAA

    Nomina di Mrs Judy Oliver come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Pauline Stewart come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 03 giu 2013, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    8 pagineAR01

    Cessazione della carica di David Eales come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2012

    21 pagineAA

    Nomina di Mrs Keren Wilkins come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Richard Lewis Cooper come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Andrew Robert Gilson come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Mark West come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Judith Oliver come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di INTERBUSINESS GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RICHARDSON, Justin Roger
    9 Brook View
    Grange Park
    NN4 5DR Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    9 Brook View
    Grange Park
    NN4 5DR Northampton
    Northamptonshire
    British101016920001
    BROCKIS, Jeremy Neil
    Kimpton Road
    LU2 0LB Luton
    Hart House Business Centre
    Bedfordshire
    England
    Amministratore
    Kimpton Road
    LU2 0LB Luton
    Hart House Business Centre
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish142191560001
    ELLINOR, David Robert
    Hanworth Close
    LU2 7ED Luton
    6
    England
    Amministratore
    Hanworth Close
    LU2 7ED Luton
    6
    England
    United KingdomBritish54832450001
    FLACK, Ivan Raymond
    Gobion House
    Godfrey Lane
    MK44 1PS Sharnbrook
    Bedfordshire
    Segretario
    Gobion House
    Godfrey Lane
    MK44 1PS Sharnbrook
    Bedfordshire
    British76058380001
    SMYTHE, Joanne
    1 Mill Cottage
    Bridge Street
    MK43 8ER Turvey
    Bedfordshire
    Segretario
    1 Mill Cottage
    Bridge Street
    MK43 8ER Turvey
    Bedfordshire
    British80512510002
    WEE, Stephen
    17 Tibbett Close
    LU6 3TT Dunstable
    Bedfordshire
    Segretario
    17 Tibbett Close
    LU6 3TT Dunstable
    Bedfordshire
    British73684580001
    WHITE, Nicholas John
    8 High Street
    Souldrop
    MK44 1EY Bedford
    Bedfordshire
    Segretario
    8 High Street
    Souldrop
    MK44 1EY Bedford
    Bedfordshire
    British65139630001
    ABRUZESSE, Maria
    Flat 4 De Parys Lodge
    De Parys Avenue
    MK40 2TZ Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    Flat 4 De Parys Lodge
    De Parys Avenue
    MK40 2TZ Bedford
    Bedfordshire
    Italian47263720001
    ARNOLD, Thomas Edward
    April Rise
    11 Rotten Row
    MK44 1EJ Riseley
    Bedfordshire
    Amministratore
    April Rise
    11 Rotten Row
    MK44 1EJ Riseley
    Bedfordshire
    British67992960001
    ASHDOWN, Nigel Stanley
    303 Norton Way South
    SG6 1SU Letchworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    303 Norton Way South
    SG6 1SU Letchworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish2554530001
    BAGGOTT, David Richard
    4 Chantry Close
    Woburn Sands
    MK17 8UB Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    4 Chantry Close
    Woburn Sands
    MK17 8UB Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British61564350002
    BARBER, John Christopher
    46 The Bury
    Pavenham
    MK43 7PY Bedford
    Amministratore
    46 The Bury
    Pavenham
    MK43 7PY Bedford
    British25870870003
    BARRINGTON, Phillip
    3 Grovesbrook
    Bow Brickhill
    MK17 9JF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    3 Grovesbrook
    Bow Brickhill
    MK17 9JF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British28514120001
    BISCHOF, Robert Alfons Teja
    10 Carrwood Avenue
    Bramhall
    SK7 2PX Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    10 Carrwood Avenue
    Bramhall
    SK7 2PX Stockport
    Cheshire
    United KingdomGerman/British30373650001
    BURGESS, Keith
    27 High Street
    Wilden
    MK44 2PB Bedford
    Amministratore
    27 High Street
    Wilden
    MK44 2PB Bedford
    United KingdomBritish42601150001
    BURNIP, Anthony Roger
    Lilac Cottage 63 Newport Road
    Woburn Sands
    MK17 8UQ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Lilac Cottage 63 Newport Road
    Woburn Sands
    MK17 8UQ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish18783570001
    CALVERT, Rodney John
    Kimpton Road
    LU2 0LB Luton
    Hart House Business Centre
    Bedfordshire
    England
    Amministratore
    Kimpton Road
    LU2 0LB Luton
    Hart House Business Centre
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish65812620001
    CALVERT, Rodney John
    Sails Cottage 7 Windmill Hill
    Biddenham
    MK40 4AG Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    Sails Cottage 7 Windmill Hill
    Biddenham
    MK40 4AG Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritish65812620001
    CLARK, Stephen Robert
    114 Hillesden Avenue
    Elstow
    MK42 9AJ Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    114 Hillesden Avenue
    Elstow
    MK42 9AJ Bedford
    Bedfordshire
    British60851690002
    CLEGGETT, Denis
    Rivendell
    West End
    NN6 7AY West Haddon
    Northamptonshire
    Amministratore
    Rivendell
    West End
    NN6 7AY West Haddon
    Northamptonshire
    British36687060001
    COATES, Stephen William
    Duck End
    Silver Road
    MK43 7QW Stevington
    Bedfordshire
    Amministratore
    Duck End
    Silver Road
    MK43 7QW Stevington
    Bedfordshire
    EnglandBritish18043650003
    COMBES, Richard George
    The Grange Church Road
    Westoning
    MK45 5JW Bedford
    Amministratore
    The Grange Church Road
    Westoning
    MK45 5JW Bedford
    United KingdomBritish39280640001
    COOPER, Richard Lewis
    Kimpton Road
    LU2 0LB Luton
    Hart House Business Centre
    Bedfordshire
    England
    Amministratore
    Kimpton Road
    LU2 0LB Luton
    Hart House Business Centre
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish154035330001
    CUMMING, Graham Jackson
    Tudor House 19 Ashpole Furlong
    Loughton
    MK5 8EA Milton Keynes
    Amministratore
    Tudor House 19 Ashpole Furlong
    Loughton
    MK5 8EA Milton Keynes
    British22410440002
    DAVIES, Lawrence Frederick
    29 Derwent Road
    AL5 3PA Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    29 Derwent Road
    AL5 3PA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish73002440001
    DE LA SALLE, Brian John
    5 Beech Ridge Kinsbourne Green Lane
    AL5 3NS Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    5 Beech Ridge Kinsbourne Green Lane
    AL5 3NS Harpenden
    Hertfordshire
    British28514140002
    EALES, David Murray
    5 Rothsay Gardens
    MK40 3QA Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    5 Rothsay Gardens
    MK40 3QA Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritish124941810001
    EARLEY, Stuart Douglas
    Woodedge
    Dalefords Lane
    CW8 2BN Whitegate
    Cheshire
    Amministratore
    Woodedge
    Dalefords Lane
    CW8 2BN Whitegate
    Cheshire
    British121358110001
    FELLOWS, John William
    Blackberry House Berghers Hill
    Wooburn Green
    HP10 0JP High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Blackberry House Berghers Hill
    Wooburn Green
    HP10 0JP High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritish20018280001
    FOUNTAIN, Eric Dudley
    41 Church Road
    Westoning
    MK45 5LP Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    41 Church Road
    Westoning
    MK45 5LP Bedford
    Bedfordshire
    British11809990001
    FRASER, Peter
    34 Blakeney Drive
    LU2 7AL Luton
    Bedfordshire
    Amministratore
    34 Blakeney Drive
    LU2 7AL Luton
    Bedfordshire
    British48133930002
    GILDEA, John Francis
    St Julian's Place
    Haynes West End
    MK45 3QU Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    St Julian's Place
    Haynes West End
    MK45 3QU Bedford
    Bedfordshire
    Irish58592680001
    GILSON, Andrew Robert
    Kimpton Road
    LU2 0LB Luton
    Hart House Business Centre
    Bedfordshire
    England
    Amministratore
    Kimpton Road
    LU2 0LB Luton
    Hart House Business Centre
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish153325350001
    GOOSE, Margaret Elizabeth
    24 Upper Shelton Road
    MK43 0LT Marston Moretaine
    Bedfordshire
    Amministratore
    24 Upper Shelton Road
    MK43 0LT Marston Moretaine
    Bedfordshire
    United KingdomBritish118321370001
    HALHEAD, Robert
    Red Roke
    Roke
    OX10 6JD Wallingford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Red Roke
    Roke
    OX10 6JD Wallingford
    Oxfordshire
    British67071180002

    INTERBUSINESS GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 20 ott 2011
    Consegnato il 22 ott 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 14 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 16 apr 1991
    Consegnato il 20 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and/or the facility letters
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Secretary of State for Employment Training Enterprise and Education Directstate
    Transazioni
    • 20 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 23 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0