BELMONT CARE LIMITED

BELMONT CARE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBELMONT CARE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02509860
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BELMONT CARE LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova BELMONT CARE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Angel Court
    EC2R 7HJ London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di BELMONT CARE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per BELMONT CARE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    5 pagineAA

    Nomina di Mr Michael Harrison come amministratore in data 27 apr 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jonathan Stephen Picken come amministratore in data 27 apr 2018

    1 pagineTM01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata 1 Angel Court London EC2R 7HJ

    1 pagineAD04

    Modifica dei dettagli di Bupa Finance Plc come persona con controllo significativo il 08 dic 2017

    2 paginePSC05

    Dettagli del direttore cambiati per Bupa Secretaries Limited il 08 dic 2017

    1 pagineCH02

    Dettagli del segretario cambiati per Bupa Secretaries Limited il 08 dic 2017

    1 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jonathan Stephen Picken il 08 dic 2017

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Bridge House Outwood Lane Horsforth Leeds West Yorkshire LS18 4UP a 1 Angel Court London EC2R 7HJ in data 08 dic 2017

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Bupa House 15-19 Bloomsbury Way London WC1A 2BA

    1 pagineAD03

    Notifica di Bupa Finance Plc come persona con controllo significativo il 22 giu 2016

    2 paginePSC02

    Cessazione di Bupa Care Homes (Ans) Limited come persona con controllo significativo il 22 giu 2016

    1 paginePSC07

    Notifica di Bupa Care Homes (Ans) Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di BELMONT CARE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    107319700001
    HARRISON, Michael
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector241166230001
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione3155937
    162768400001
    KANE, John Harper, Squadron Leader
    49 Cambridge Road
    BS21 7HB Clevedon
    Somerset
    Segretario
    49 Cambridge Road
    BS21 7HB Clevedon
    Somerset
    British24861250002
    TLT SECRETARIES LIMITED
    One Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    Segretario
    One Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    77278550001
    BEAZLEY, Nicholas Tetley
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Amministratore
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritishDirector105797560001
    CANNON, Andrew John
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Amministratore
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    EnglandBritishCompany Director200461360001
    DAVIES, Julian Peter
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritishDirector29367700001
    ELLERBY, Mark
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector40582650004
    GREGORY, Fraser David
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    Amministratore
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector107664270003
    GRIFFITHS, Charles Alexander
    Scool House
    Clevedon Road, Weston-In-Gordano
    BS20 8PZ Bristol
    Amministratore
    Scool House
    Clevedon Road, Weston-In-Gordano
    BS20 8PZ Bristol
    United KingdomBritishChartered Accountant15570420003
    GRIFFITHS, Vanessa Mary
    23 Dial Hill Road
    BS21 7HL Clevedon
    Somerset
    Amministratore
    23 Dial Hill Road
    BS21 7HL Clevedon
    Somerset
    BritishDirector27369120001
    IRVING, Carolyn Margaret
    13 Dial Hill Road
    BS21 7HJ Clevedon
    Somerset
    Amministratore
    13 Dial Hill Road
    BS21 7HJ Clevedon
    Somerset
    BritishDirector24861270002
    IRVING, David Kenneth Stewart, Dr
    13 Dial Hill
    BS21 7HJ Clevedon
    North Somerset
    Amministratore
    13 Dial Hill
    BS21 7HJ Clevedon
    North Somerset
    BritishGeneral Practitioner73177620001
    KANE, John Harper, Squadron Leader
    49 Cambridge Road
    BS21 7HB Clevedon
    Somerset
    Amministratore
    49 Cambridge Road
    BS21 7HB Clevedon
    Somerset
    United KingdomBritishNursing Home Proprietor24861250002
    KANE, Keren Elizabeth
    Mulberry Lodge
    49 Cambridge Road
    BS21 7HB Clevedon
    Somerset
    Amministratore
    Mulberry Lodge
    49 Cambridge Road
    BS21 7HB Clevedon
    Somerset
    EnglandBritishDirector39841770001
    LOS, Steven Michael
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Amministratore
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritishCompany Director116895800001
    MERCHANT, Mahboob Ali
    28 Denham Road
    KT17 3AA Epsom
    Surrey
    Amministratore
    28 Denham Road
    KT17 3AA Epsom
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant56732410001
    MOORE, Keith
    Outwood Lane
    Horsforth
    LS18 4UP Leeds
    Bridge House
    United Kingdom
    Amministratore
    Outwood Lane
    Horsforth
    LS18 4UP Leeds
    Bridge House
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant49217290002
    PICKEN, Jonathan Stephen
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director189611450001
    REITER, Simon Philip
    Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House 15-19
    England
    Amministratore
    Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House 15-19
    England
    United KingdomBritishFinance Director135845570001
    RUSSELL, Christopher Ian Fraser, Dr
    Symondsdown House
    Woodbury Lane
    EX13 5TL Axminster
    Devon
    Amministratore
    Symondsdown House
    Woodbury Lane
    EX13 5TL Axminster
    Devon
    BritishMedical Practitioner24861280002
    RUSSELL, Prudence
    Symondsdown House
    Woodbury Lane
    EX13 5TL Axminster
    Devon
    Amministratore
    Symondsdown House
    Woodbury Lane
    EX13 5TL Axminster
    Devon
    BritishState Registered Nurse24861260002
    TAYLOR, Neil Robert
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    Amministratore
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    United KingdomBritishChartered Accountant62846800003
    THOMAS, Oliver Henry Dixon
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Amministratore
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritishRegional Director256549290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BELMONT CARE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    22 giu 2016
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2779134
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Outwood Lane
    Horsforth
    LS18 4UP Leeds
    Bridge House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Outwood Lane
    Horsforth
    LS18 4UP Leeds
    Bridge House
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione1960990
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    BELMONT CARE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 31 mag 2007
    Consegnato il 01 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 15 linden road clevedon avon t/n AV133571.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 dic 2004
    Consegnato il 23 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 22 riverleaze portishead bristol t/no ST15041.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 nov 1998
    Consegnato il 24 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Elm view,off moor lane,clevedon,bath and north east,somerset.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 nov 1998
    Consegnato il 11 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    72,76,78,80 nore road portishead bristol and land lying to the north of nore road portishead north somerset t/n AV125142.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 nov 1998
    Consegnato il 11 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The belmont chapel hill clevedon north somerset t/no: AV232200.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 ott 1998
    Consegnato il 06 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 nov 1994
    Consegnato il 16 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land being 72 76 78 and 80 nore road and land lying to the north of nore road portishead t/n AV125142 and the goodwill of the business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 16 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 07 nov 1994
    Consegnato il 16 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    An agreement in writing dated 18TH august 1994 relating to the purchase of land lying to the north of nore road. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 16 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral charge and assignment
    Creato il 07 nov 1994
    Consegnato il 16 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the companies rights title and interest in and to the building contract made the 27TH october 1994 and all monies payable thereunder.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 16 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 nov 1994
    Consegnato il 12 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land k/a the belmont chapel hill clevedon avon also k/a belmont house nursing home t/n av 232200. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 nov 1994
    Consegnato il 12 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 set 1993
    Consegnato il 16 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & premises situate & k/a belmont house chapel hill clevedon avon with the goodwill of the business & the benefit of all licences fixtures & fittings. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 set 1993
    Consegnato il 11 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 lug 1993
    Consegnato il 23 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 mar 1993
    Consegnato il 17 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See form 395 for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 giu 1992
    Consegnato il 12 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 lug 1990
    Consegnato il 14 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Belmont nursing home, chapel hill, clevedon, avon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 30 giu 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0