ENGLASS GROUP LIMITED

ENGLASS GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàENGLASS GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02518215
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ENGLASS GROUP LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova ENGLASS GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Fifth Floor
    9-10 Market Place
    W1W 8AQ London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ENGLASS GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE ENGLISH GLASS GROUP LIMITED 25 feb 199125 feb 1991
    VIEWBONUS LIMITED04 lug 199004 lug 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di ENGLASS GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per ENGLASS GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    3 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Divided shares 31/07/2012
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 04 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Stato del capitale al 03 ago 2012

    • Capitale: USD 1.63
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineSH20

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    3 pagineAA

    Nomina di Mr Joshua Alan Sherbin come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ernest Layland come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    3 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    3 pagineAA

    legacy

    8 pagine363s

    Chi sono gli amministratori di ENGLASS GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BIGNALL, John
    Coombe Lane
    HP14 4QR Naphill
    Coombe Farm
    Bucks
    Segretario
    Coombe Lane
    HP14 4QR Naphill
    Coombe Farm
    Bucks
    British907580004
    BIGNALL, John
    Coombe Lane
    HP14 4QR Naphill
    Coombe Farm
    Bucks
    Amministratore
    Coombe Lane
    HP14 4QR Naphill
    Coombe Farm
    Bucks
    EnglandBritish907580004
    BROOKS, Lynn Allen
    814 Columbine Cir
    Auburn
    46706 Indiana
    Amministratore
    814 Columbine Cir
    Auburn
    46706 Indiana
    UsaUs84330980001
    SHERBIN, Joshua Alan
    Brightmore Road
    Bloomfield Hills
    4548
    Michigan 48304
    Usa
    Amministratore
    Brightmore Road
    Bloomfield Hills
    4548
    Michigan 48304
    Usa
    United StatesAmerican111716850001
    BARRON, Kevin Thomas
    12 Rockingham Hills
    Oundle
    PE8 4QA Peterborough
    Northamptonshire
    Segretario
    12 Rockingham Hills
    Oundle
    PE8 4QA Peterborough
    Northamptonshire
    British22171890001
    CASE, Stephen Edward
    116 High Lane East
    West Hallam
    DE7 6HY Ilkeston
    Derbyshire
    Segretario
    116 High Lane East
    West Hallam
    DE7 6HY Ilkeston
    Derbyshire
    British16701190001
    CASE, Stephen Edward
    116 High Lane East
    West Hallam
    DE7 6HY Ilkeston
    Derbyshire
    Segretario
    116 High Lane East
    West Hallam
    DE7 6HY Ilkeston
    Derbyshire
    British16701190001
    ALDERMAN, Nicholas Guy
    14 Brook Lane
    LE11 3RA Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    14 Brook Lane
    LE11 3RA Loughborough
    Leicestershire
    British64639120002
    BINNIE, Stewart John
    36 Glebe Road
    Barnes
    SW13 0EA London
    Amministratore
    36 Glebe Road
    Barnes
    SW13 0EA London
    EnglandBritish131771340001
    CARPENTER, John David
    Ashlea Farm Hardstoft
    Pilsley
    S45 8AE Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    Ashlea Farm Hardstoft
    Pilsley
    S45 8AE Chesterfield
    Derbyshire
    United KingdomBritish16664780002
    DECHANTS, Peter Charles
    2054 Chaucer Drive
    Ann Arbor 48103
    FOREIGN Michigan Usa
    Amministratore
    2054 Chaucer Drive
    Ann Arbor 48103
    FOREIGN Michigan Usa
    Usa51846720001
    HALE, Michael
    Lower House 57a Norton Road
    DY8 2TB Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    Lower House 57a Norton Road
    DY8 2TB Stourbridge
    West Midlands
    British47186960001
    LAWSON, Thomas John
    10 Powys Avenue
    LE2 2DP Leicester
    Amministratore
    10 Powys Avenue
    LE2 2DP Leicester
    British7145030001
    LAYLAND, Ernest James
    21 Lawnlea Close
    Sunnyhill
    DE23 1XQ Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    21 Lawnlea Close
    Sunnyhill
    DE23 1XQ Derby
    Derbyshire
    EnglandBritish89514470001
    PETERS, Todd
    3606 Lakeshore Drive
    IRISH Waterford
    48329 Michigan
    Usa
    Amministratore
    3606 Lakeshore Drive
    IRISH Waterford
    48329 Michigan
    Usa
    American84330570001
    PIASECKI, Rysiek Jan
    5 Shepherds Close
    Leicester Forest East
    LE3 3HX Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    5 Shepherds Close
    Leicester Forest East
    LE3 3HX Leicester
    Leicestershire
    British7144990001
    POPPLETON, David Martin
    The Old Vicarage
    ST18 0BW Salt
    Staffordshire
    Amministratore
    The Old Vicarage
    ST18 0BW Salt
    Staffordshire
    British1541590001
    SHERWOOD, Charles Nigel Cross
    Cavewood
    Rectory Lane
    SG3 6RD Datchworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Cavewood
    Rectory Lane
    SG3 6RD Datchworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish142567110001
    TAYLOR, Paul Christopher
    10 Wentworth Green
    Kirby Muxloe
    LE9 2EQ Leicester
    Amministratore
    10 Wentworth Green
    Kirby Muxloe
    LE9 2EQ Leicester
    EnglandBritish46254910001
    TOWE, Michael William
    The Orchards
    7 Lychgate Lane Burbage
    LE10 2DR Hinckley
    Leicestershire
    Amministratore
    The Orchards
    7 Lychgate Lane Burbage
    LE10 2DR Hinckley
    Leicestershire
    British40429160001

    ENGLASS GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 04 ago 1995
    Consegnato il 17 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of each or any of the finance documents (as defined in the debenture)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Grenfell & Co.Limitedthe "Security Agent"
    Transazioni
    • 17 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 23 ott 1990
    Consegnato il 08 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 08 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 27 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Equitable mortgage
    Creato il 23 ott 1990
    Consegnato il 08 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the credit facilities agreement and or this charge
    Brevi particolari
    All the companys shares in the english glass company limited with all rights title interest in and to all dividends, bonus shares rights issues securities see form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Continental Bank Na
    Transazioni
    • 08 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 27 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 ott 1990
    Consegnato il 08 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the credit facilities agreement and or this charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Continental Bank Na
    Transazioni
    • 08 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 27 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 ott 1990
    Consegnato il 08 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and or the english glass company limited under the terms of a credit facilities agreement and or this charge to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Account no 0367749 and all sums to be deposited of the company with lloyds bank PLC.
    Persone aventi diritto
    • Continental Bank Na
    Transazioni
    • 08 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 27 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0