CHESHIRE MOTOR COMPANY LIMITED

CHESHIRE MOTOR COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCHESHIRE MOTOR COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02521793
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CHESHIRE MOTOR COMPANY LIMITED?

    • (5010) /
    • (5020) /
    • (5030) /

    Dove si trova CHESHIRE MOTOR COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    12 Wilberforce Road
    CB3 0EQ Cambridge
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CHESHIRE MOTOR COMPANY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    16TH MARBICK LIMITED13 lug 199013 lug 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di CHESHIRE MOTOR COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al

    Quali sono le ultime deposizioni per CHESHIRE MOTOR COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    4 pagineRM02

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Baker Tilly 6th Floor 25 Farringdon Street London EC4A 4AB a 12 Wilberforce Road Cambridge CB3 0EQ in data 02 feb 2017

    2 pagineAD01

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 31 ago 2016

    2 pagine3.6

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    8 pagineRM02

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 03 lug 2015

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 04 dic 2015

    1 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 04 dic 2015

    1 pagine3.6

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    4 pagineRM02

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    4 pagineRM02

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    4 pagineRM02

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    4 pagineRM02

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 02 ott 2015

    3 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 13 ott 2015

    1 pagine3.6

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    4 pagineRM02

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 03 lug 2015

    2 pagine3.6

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    4 pagineRM02

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 09 apr 2015

    2 pagine3.6

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    5 pagineRM02

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    6 pagineRM02

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 13 ott 2014

    1 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 02 ott 2014

    2 pagine3.6

    Chi sono gli amministratori di CHESHIRE MOTOR COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRIGGS, John Philip
    South Cottage
    Church Lane, Debden
    CB11 3LD Saffron Walden
    Segretario
    South Cottage
    Church Lane, Debden
    CB11 3LD Saffron Walden
    BritishAccountant37238960003
    BRIGGS, John Philip
    South Cottage
    Church Lane, Debden
    CB11 3LD Saffron Walden
    Amministratore
    South Cottage
    Church Lane, Debden
    CB11 3LD Saffron Walden
    BritishDirector37238960003
    PATEL, Amrat Ravlabhai
    22 Tewkesbury Road
    Longford
    GL2 9DT Gloucester
    Amministratore
    22 Tewkesbury Road
    Longford
    GL2 9DT Gloucester
    EnglandBritishDirector27005280002
    PENNEY, Robert
    12 The Hamlet
    Nailsea
    BS19 1BY Bristol
    Avon
    Amministratore
    12 The Hamlet
    Nailsea
    BS19 1BY Bristol
    Avon
    BritishDirector27005270001
    QUIRK, Robert
    The Old Orchard
    Main Road
    CW4 8LL Goostrey
    Cheshire
    Amministratore
    The Old Orchard
    Main Road
    CW4 8LL Goostrey
    Cheshire
    BritishDirector50582720002
    STEVENS, Roy
    321 Stockport Road
    Mossley
    OL6 0RJ Manchester
    Amministratore
    321 Stockport Road
    Mossley
    OL6 0RJ Manchester
    BritishDirector51395230001
    BICKLE, Roger Thomas Alexander
    Huccaby House 130 Nevendon Road
    SS12 0NS Wickford
    Essex
    Segretario
    Huccaby House 130 Nevendon Road
    SS12 0NS Wickford
    Essex
    British184560001
    MORAN, John Patrick
    12 Glanvor Road
    Edgeley
    SK3 9PF Stockport
    Cheshire
    Segretario
    12 Glanvor Road
    Edgeley
    SK3 9PF Stockport
    Cheshire
    British41814320001
    VACY ASH, Charles Gilbert
    686 Kenilworth Road
    CV7 7HD Balsall Common
    Warwickshire
    Segretario
    686 Kenilworth Road
    CV7 7HD Balsall Common
    Warwickshire
    British90121810001
    ASHWORTH, Geoffrey Ernest, Assistant Secretary
    53 Grand Parade
    SS9 1DT Leigh On Sea
    Essex
    Amministratore
    53 Grand Parade
    SS9 1DT Leigh On Sea
    Essex
    BritishSolicitor34496760002
    BICKLE, Roger Thomas Alexander
    Huccaby House 130 Nevendon Road
    SS12 0NS Wickford
    Essex
    Amministratore
    Huccaby House 130 Nevendon Road
    SS12 0NS Wickford
    Essex
    BritishLegal Executive184560001
    BRIGGS, John Philip
    Hollybush
    The Street Bradwell Village
    CM7 8EL Braintree
    Essex
    Amministratore
    Hollybush
    The Street Bradwell Village
    CM7 8EL Braintree
    Essex
    BritishAccountant37238960001
    CROSS, William Thomas
    200 Stock Road
    CM12 0SH Billericay
    Essex
    Amministratore
    200 Stock Road
    CM12 0SH Billericay
    Essex
    BritishManager Market Replenation37532620001
    JOBLING, Natalie Helen
    5 Highgrove House
    Regency Court
    CM14 4FH Brentwood
    Essex
    Amministratore
    5 Highgrove House
    Regency Court
    CM14 4FH Brentwood
    Essex
    EnglandBritishSolicitor95179250001
    VACY ASH, Charles Gilbert
    686 Kenilworth Road
    CV7 7HD Balsall Common
    Warwickshire
    Amministratore
    686 Kenilworth Road
    CV7 7HD Balsall Common
    Warwickshire
    EnglandBritishBarrister90121810001

    CHESHIRE MOTOR COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 08 set 2000
    Consegnato il 19 set 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capital Bank PLC
    Transazioni
    • 19 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 2002Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
    • 09 lug 2005Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
    • 09 lug 2005Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (405 (2))
    • 121 lug 2015Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
    • 121 lug 2015Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
    • 406 apr 2017Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
      • Numero di pratica 1
      • Numero di pratica 4
    Legal charge
    Creato il 05 gen 1999
    Consegnato il 12 gen 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Cheshire accident repair centre london road poynton macclesfield cheshire t/n CH393575.
    Persone aventi diritto
    • Shell UK Limited
    Transazioni
    • 12 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 24 gen 1997
    Consegnato il 07 feb 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ott 2002Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
    • 25 ott 2005Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
    • 05 apr 2006Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (405 (2))
    • 522 feb 2014Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
    • 315 dic 2014Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
    • 307 dic 2015Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
    • 307 dic 2015Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
    • 514 set 2016Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
      • Numero di pratica 3
      • Numero di pratica 5
    Legal mortgage
    Creato il 24 gen 1997
    Consegnato il 07 feb 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land k/a accident and repair centre london road south poynton cheshir e t/no CH393575 and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 24 gen 1997
    Consegnato il 30 gen 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ford Credit Europe PLC
    Transazioni
    • 30 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 2002Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
    • 05 apr 2006Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (405 (2))
    • 221 dic 2010Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (LQ02)
    • 202 set 2014Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
    • 218 dic 2014Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
    • 207 dic 2015Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
    • 207 dic 2015Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
      • Numero di pratica 2
    Charge over bulk deposit and other receivables
    Creato il 27 lug 1994
    Consegnato il 28 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies deposited from time to time by the company with the charge pursuant to the terms of a sale or return agreement dated 14 april 1994 and all other claims falling due to the company by the chargee under the dealer agreement or the sale or return agreement.
    Persone aventi diritto
    • Ford Credit Europe PLC
    Transazioni
    • 28 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mar 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge on vehicle stocks
    Creato il 01 giu 1994
    Consegnato il 03 giu 1994
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All new & used motor vehicles passenger cars commercial vehicles tractors trailers caravans & all motor parts spares & accessories. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ford Credit Europe PLC
    Transazioni
    • 03 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)

    CHESHIRE MOTOR COMPANY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 set 2000Data dello strumento
    Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robert Jonathan Hunt
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Am Grove
    Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    2
    DataTipo
    24 gen 1997Data dello strumento
    Ricevitore amministrativo nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Martin Sheridan
    Baker Tilly
    2 Bloomsbury Street
    WC1B 3ST London
    Praticante
    Baker Tilly
    2 Bloomsbury Street
    WC1B 3ST London
    Richard Paul Rendle
    2 Bloomsbury Street,
    London.
    WC15 3ST
    Praticante
    2 Bloomsbury Street,
    London.
    WC15 3ST
    Ian Best
    Ernst & Young Llp
    One Colmore Square
    B3 2DB Birmingham
    Praticante
    Ernst & Young Llp
    One Colmore Square
    B3 2DB Birmingham
    Bruce Alexander Mackay
    Baker Tilly
    2 Bloomsbury Street
    WC1B 2ST London
    Praticante
    Baker Tilly
    2 Bloomsbury Street
    WC1B 2ST London
    David Kenneth Duggins
    Ernst & Young Llp
    One Colmore Square
    B3 2DB Birmingham
    Praticante
    Ernst & Young Llp
    One Colmore Square
    B3 2DB Birmingham
    Stephen Mark Quinn
    Baker Tilly
    2 Bloomsbury Street
    WC1B 3ST London
    Praticante
    Baker Tilly
    2 Bloomsbury Street
    WC1B 3ST London
    3
    DataTipo
    24 gen 1997Data dello strumento
    Ricevitore amministrativo nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Martin Sheridan
    Baker Tilly
    2 Bloomsbury Street
    WC1B 3ST London
    Praticante
    Baker Tilly
    2 Bloomsbury Street
    WC1B 3ST London
    Bruce Alexander Mackay
    Baker Tilly
    2 Bloomsbury Street
    WC1B 2ST London
    Praticante
    Baker Tilly
    2 Bloomsbury Street
    WC1B 2ST London
    Stephen Mark Quinn
    Baker Tilly
    2 Bloomsbury Street
    WC1B 3ST London
    Praticante
    Baker Tilly
    2 Bloomsbury Street
    WC1B 3ST London
    Richard Paul Rendle
    2 Bloomsbury Street,
    London.
    WC15 3ST
    Praticante
    2 Bloomsbury Street,
    London.
    WC15 3ST
    4
    DataTipo
    08 set 2000Data dello strumento
    Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Ricevitore/gestore
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    5Ricevitore amministrativo nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Angela Swarbrick
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Ricevitore/gestore
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Tomislav Lukic
    Ernst & Young
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Ricevitore/gestore
    Ernst & Young
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0