BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED

BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02524595
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED?

    • Trasporto aereo passeggeri programmato (51101) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Waterside
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LONDON AIRTOURS LIMITED23 lug 199023 lug 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Stato del capitale al 15 apr 2024

    • Capitale: GBP 0.20
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    1 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Indirizzo della sede legale modificato da Waterside PO Box 365 Speedbird Way Harmondsworth UB7 0GB a Waterside Speedbird Way Harmondsworth UB7 0GB in data 04 mar 2024

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2021

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2020

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2019

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2018

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Miss Sian Louise Davies il 01 gen 2019

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    16 pagineAA

    Cessazione della carica di Clifton Denley come amministratore in data 24 mag 2017

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FLEMING, Andrew Ian
    PO BOX 365
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    United Kingdom
    Segretario
    PO BOX 365
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    United Kingdom
    182733770001
    DAVIES, Sian Louise
    P O Box 365, Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    West Drayton
    United Kingdom
    Amministratore
    P O Box 365, Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    West Drayton
    United Kingdom
    EnglandBritish210550320001
    BYE, Timothy John
    1 Duke William Mount
    The Park
    NG7 1BH Nottingham
    Segretario
    1 Duke William Mount
    The Park
    NG7 1BH Nottingham
    British59160780002
    DOSANJH, Kulbinder Kaur
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside PO BOX 365
    United Kingdom
    Segretario
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside PO BOX 365
    United Kingdom
    British168619310001
    ECKERT, Sabine
    44 Somervell Road
    South Harrow
    HA2 8TT Harrow
    Middlesex
    Segretario
    44 Somervell Road
    South Harrow
    HA2 8TT Harrow
    Middlesex
    British16543120002
    PALMER, David
    Guggenbuhl 11
    Tegerfelden
    5306
    Switzerland
    Segretario
    Guggenbuhl 11
    Tegerfelden
    5306
    Switzerland
    British50471070002
    RICHER, Charles Martin
    Brickyards
    Lyewood Common
    TN7 4DD Withyham
    East Sussex
    Segretario
    Brickyards
    Lyewood Common
    TN7 4DD Withyham
    East Sussex
    British2121130001
    SAUNDERS, Angus Charles
    Parklands
    SO21 3RH Barton Stacey
    Hampshire
    Segretario
    Parklands
    SO21 3RH Barton Stacey
    Hampshire
    British65848250002
    BISHOP, Michael David, Lord Glendonbrook Cbe
    52 Egerton Crescent
    SW3 2ED London
    Amministratore
    52 Egerton Crescent
    SW3 2ED London
    EnglandBritish100128510001
    BURNSIDE, David Wilson Boyd
    18 Ebury Street
    SW1W 0LU London
    Amministratore
    18 Ebury Street
    SW1W 0LU London
    EnglandBritish27423800001
    BYE, Timothy John
    1 Duke William Mount
    The Park
    NG7 1BH Nottingham
    Amministratore
    1 Duke William Mount
    The Park
    NG7 1BH Nottingham
    United KingdomBritish59160780002
    CALDWELL, Wilfrid Moores
    The Grange
    Fittleworth
    RH20 1EW Pulborough
    West Sussex
    Amministratore
    The Grange
    Fittleworth
    RH20 1EW Pulborough
    West Sussex
    United KingdomBritish36127970001
    DENLEY, Clifton
    PO BOX 365
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    United Kingdom
    Amministratore
    PO BOX 365
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    United Kingdom
    United KingdomAmerican169829760001
    ELLIOT, Simon John
    Stourpaine House
    Stourpaine
    DT11 8TQ Blandford
    Dorset
    Amministratore
    Stourpaine House
    Stourpaine
    DT11 8TQ Blandford
    Dorset
    United KingdomBritish29996230001
    ELLIOTT, Grahame Nicholas
    Highbury 26 Harrop Road
    Hale
    WA15 9DQ Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Highbury 26 Harrop Road
    Hale
    WA15 9DQ Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish75330500001
    HEARD, William John
    43 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Amministratore
    43 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    British63720880001
    HENNEMANN, Jorg Otto Gerhard
    Donington Hall
    Castle Donington
    DE74 2SB Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    Donington Hall
    Castle Donington
    DE74 2SB Derby
    Derbyshire
    German139365650001
    HESKETH, Thomas Alexander, Lord
    Easton Neston
    NN12 8TN Towcester
    Northamptonshire
    Amministratore
    Easton Neston
    NN12 8TN Towcester
    Northamptonshire
    British40855800001
    HETHERINGTON, Desmond Brian
    Amcotts 214 Bassett Green Road
    Bassett
    SO16 3NF Southampton
    Amministratore
    Amcotts 214 Bassett Green Road
    Bassett
    SO16 3NF Southampton
    British44904000001
    KAMAL, Farouk
    53 Mount Street
    W1K 2SG London
    Amministratore
    53 Mount Street
    W1K 2SG London
    Swedish18497530002
    LAKEMAN, Ceri Boon
    Hedgelands House Royce Way
    West Wittering
    PO20 8LN Chichester
    West Sussex
    Amministratore
    Hedgelands House Royce Way
    West Wittering
    PO20 8LN Chichester
    West Sussex
    British13736440001
    MASTIN, Collin
    Southview
    Brent Pelham
    SG9 0HQ Buntingford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Southview
    Brent Pelham
    SG9 0HQ Buntingford
    Hertfordshire
    British16543130001
    MENNE, Simone
    Donington Hall
    Castle Donington
    DE74 2SB Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    Donington Hall
    Castle Donington
    DE74 2SB Derby
    Derbyshire
    United KingdomGerman153979390002
    MOHTARAM, Kaddouro
    Via A Cadlolo 90
    Rome 00136
    FOREIGN Italy
    Amministratore
    Via A Cadlolo 90
    Rome 00136
    FOREIGN Italy
    Lebanese41519830001
    PALMER, Robert Michael
    Donington Hall
    Castle Donington
    DE74 2SB Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    Donington Hall
    Castle Donington
    DE74 2SB Derby
    Derbyshire
    EnglandBritish125916090003
    PARRY, Hugh Archibald Pryce
    Bookham Lodge
    KT11 3QJ Stoke D'Abernon
    Surrey
    Amministratore
    Bookham Lodge
    KT11 3QJ Stoke D'Abernon
    Surrey
    EnglandBritish6992430001
    POWELL OF BAYSWATER, Charles, Lord
    1 Caroline Close
    W2 4RW London
    Amministratore
    1 Caroline Close
    W2 4RW London
    EnglandBritish69244580004
    PROCK-SCHAUER, Wolfgang
    Donington Hall
    Castle Donington
    DE74 2SB Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    Donington Hall
    Castle Donington
    DE74 2SB Derby
    Derbyshire
    AustriaAustrian146958160001
    RICE, William Anthony
    Briarfields Cranleigh Chase
    The Common
    GU6 8SH Cranleigh
    Surrey
    Amministratore
    Briarfields Cranleigh Chase
    The Common
    GU6 8SH Cranleigh
    Surrey
    United KingdomBritish55752930001
    RICHARDSON, David Gordon
    Water Lane
    Radwinter
    CB10 2TX Saffron Walden
    Haselbury House
    Essex
    Amministratore
    Water Lane
    Radwinter
    CB10 2TX Saffron Walden
    Haselbury House
    Essex
    British50331150002
    ROMERO, Yacoub
    3 Gloucester Court
    Headstone Drive
    HA1 4UE Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    3 Gloucester Court
    Headstone Drive
    HA1 4UE Harrow
    Middlesex
    British74964500003
    SAFADI, Mohammad Ahmed
    Queen Anne House
    Queens Drive
    KT22 0PB Oxshott
    Surrey
    Amministratore
    Queen Anne House
    Queens Drive
    KT22 0PB Oxshott
    Surrey
    British36079770001
    SAID, Khaled Rida
    14 Quai Du Seujet
    Geneva
    Ch1201
    Switzerland
    Amministratore
    14 Quai Du Seujet
    Geneva
    Ch1201
    Switzerland
    British101793620001
    SAUNDERS, Angus Charles
    Parklands
    SO21 3RH Barton Stacey
    Hampshire
    Amministratore
    Parklands
    SO21 3RH Barton Stacey
    Hampshire
    United KingdomBritish65848250002
    SIMPSON, Peter Anthony
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside PO BOX 365
    United Kingdom
    Amministratore
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside PO BOX 365
    United Kingdom
    EnglandBritish195560780001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    PO BOX 365
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    United Kingdom
    06 apr 2016
    PO BOX 365
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02107441
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over proceeds of aircraft slot dealing
    Creato il 04 gen 2007
    Consegnato il 10 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to the receivables. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • M1 Travel Limited
    Transazioni
    • 10 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over proceeds of aircraft slot dealing
    Creato il 06 ott 2006
    Consegnato il 20 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right, title and interest in and to the receivables; and any money at any time standing to the credit of the collection account specifically relating to the receivables. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Al Shams Holdings Limited
    Transazioni
    • 20 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of insurances
    Creato il 22 lug 2005
    Consegnato il 05 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the company's right, title and interest in and to the assignor's right to receive proceeds of the insurances and any and all requisition compensation. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Als Irish Aircraft Leasing Msn 1690 Limited
    Transazioni
    • 05 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Engine assignment agreement
    Creato il 28 apr 2005
    Consegnato il 16 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (the assignor) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title interest in and to the service policies. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsh Nordbank Ag (The Assignee)
    Transazioni
    • 16 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ott 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assignment
    Creato il 28 apr 2005
    Consegnato il 16 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (the assignor) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title interest in to under and in respect of the "assigned rights". See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsh Nordbank Ag (The Assignee)
    Transazioni
    • 16 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ott 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of mortgage
    Creato il 22 mar 2005
    Consegnato il 31 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any one or more of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's right,title and interest,present and future,in the engine. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 31 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An assignment of insurance proceeds
    Creato il 22 mar 2005
    Consegnato il 31 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any one or more of the assignee,the facility agent,the security trustee,the lenders or any other person on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the rights,title and interest of the company in and to the assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 31 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of insurances
    Creato il 24 set 2003
    Consegnato il 10 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the assignors right title and interest in and to the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Debis Aircraft Leasing Viii B.V.
    Transazioni
    • 10 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of insurances
    Creato il 06 mar 2003
    Consegnato il 12 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the assignor's right to receive proceeds of the insurances and any and all requisition compensation. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Singapore Aircraft Leasing Enterprise Pte. LTD
    Transazioni
    • 12 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An assignment of insurances
    Creato il 26 feb 2003
    Consegnato il 17 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company's right, title, benefit and interest in and to the insurances and any requisition compensation relating to the aircraft including, but not limited to, all moneys, proceeds and payments in connection with any of the same including the right to sue for damages and any returned premiums.
    Persone aventi diritto
    • Malc Lease Three LTD (The Lessor)
    Transazioni
    • 17 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of insurances relating to one airbus A320-200 aircraft with manufacturer's serial number 1194
    Creato il 25 apr 2000
    Consegnato il 28 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to various agreements (as defined)
    Brevi particolari
    All rights,title,benefit and interest in all contracts or policies of insurance and all moneys/other benefits thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Singapore Aircraft Leasing Enterprise Pte LTD
    Transazioni
    • 28 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 lug 1998
    Consegnato il 31 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 30 dic 1997
    Consegnato il 16 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under and in accordance with the aircraft lease agreement (as defined)
    Brevi particolari
    By way of floating charge all undertaking property and assets rights and income of the company.
    Persone aventi diritto
    • Debis Aircraft Leasing Vii B.V.
    Transazioni
    • 16 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 02 apr 1997
    Consegnato il 10 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The secured obligations and liabilities now due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the aircraft lease agreements (as defined)
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Airbus Industrie Financial Services Limited
    Transazioni
    • 10 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 gen 1997
    Consegnato il 12 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement dated 30TH january 1997 and/or the debenture
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Guernroy Limited
    Transazioni
    • 12 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 dic 1996
    Consegnato il 07 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the facility agreement dated 18 december 1996 and the debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Guernroy Limited
    Transazioni
    • 07 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 nov 1996
    Consegnato il 23 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreenment dated 7TH november 1996
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Guernroy Limited
    Transazioni
    • 23 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 14 ago 1996
    Consegnato il 23 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All sums of money paid by the chargor to the bank pursuant to the deposit contra. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 07 giu 1996
    Consegnato il 17 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A fixed charge over all the "deposit(s)" referred to in the schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 23 apr 1996
    Consegnato il 08 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of an agreement dated 19/6/95 between the company and the parties (as defined)
    Brevi particolari
    The sum of £80,000 together with interest accrued now or to be held by natonal westminster bank PLC on an account numbered 06291325 and earmarked or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 21 lug 1995
    Consegnato il 01 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over the deposit(s) being all sums of money in any currency deposited with the bank or held by the bank pursuant to the deposit being... Barclays bank PLC re british mediterranean airways limited gts bid deposit bid number 6119996. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 26 giu 1995
    Consegnato il 30 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all the deposit(s) being all sums of money in any currency (a) deposited or paid by the company with or to the bank or held by the bank on behalf of the company pursuant to the deposit contract(s) re: british mediterranean airways limited currency fixed term deposit deal no. 6119996 (b) deposited or paid by the company with or to the bank or held by the bank on behalf of the company and (c) representing the renewal or replacement of or for any sums deposited or paid or held as aforesaid, together with all interest accruing thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 28 dic 1994
    Consegnato il 10 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all the "deposit(s)" referred to in the schedule together with all interest from time to time accruing thereon ....... details of charged account :- barclays bank re mediterranean airways limited business premium account number 60742716. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Aircraft lease agreement
    Creato il 09 ago 1994
    Consegnato il 26 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the company`s obligations to orix aviation systems limited under the lessee documents (as defined in the lease agreement) or under any other agreement entered into, between orix aviation systems limited and the company or any of its associated or affiliated companies
    Brevi particolari
    The "deposit" defined in the lease agreement as such sums as shall be paid to orix pursuant to clause 7.4 (a), (b) and (c) and where the context so permits,shall include the letter of credit,which is defined in the lease agreement as asny leter of credit,or,as the case may be,bank guarantee,provided by thecompany pursuant to and in accordance with cluse 7.4 including any extension`s or renewals thereof and any substitute or replacement therefor,in each case in form substance reasonably acceptable to orix.
    Persone aventi diritto
    • Orix Aviation Systems Limited
    Transazioni
    • 26 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0