BLISSCORP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBLISSCORP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02525196
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BLISSCORP LIMITED?

    • Attività delle agenzie di lavoro interinale (78200) / Attività amministrative e di supporto
    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova BLISSCORP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Sterling Ford Centurion Court
    83 Camp Road
    AL1 5JN St Albans
    Herts
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BLISSCORP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    REDWOOD PROFESSIONALS LIMITED07 mag 200907 mag 2009
    REDWOOD ENGINEERING RECRUITMENT LIMITED05 feb 200405 feb 2004
    REDWOOD CONTRACTS LIMITED25 lug 199025 lug 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di BLISSCORP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per BLISSCORP LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per BLISSCORP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    8 pagine4.72

    Cessazione della carica di Whale Rock Secretaries Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O C/O Cardale Investments Llp Greener House 66-68 Haymarket London SW1Y 4RF England* in data 02 ago 2013

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    6 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 25 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 ago 2012

    Stato del capitale al 29 ago 2012

    • Capitale: GBP 2,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Whale Rock Secretaries Limited il 25 lug 2011

    2 pagineCH04

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata

    1 pagineAD04

    Indirizzo della sede legale modificato da * 54 Clarendon Road Watford WD17 1DU England* in data 15 ago 2011

    1 pagineAD01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    9 pagineMG02

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed redwood professionals LIMITED\certificate issued on 13/05/11
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name13 mag 2011

    Risoluzione di cambio di nome della società il 13 mag 2011

    RES15
    change-of-name13 mag 2011

    Cambio di nome" per delibera

    NM01

    legacy

    5 pagineMG01

    Dettagli del segretario cambiati per Whale Rock Secretaries Limited il 14 giu 2010

    2 pagineCH04

    Dettagli del segretario cambiati per Whale Rock Secretaries Limited il 14 giu 2010

    2 pagineCH04

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    21 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * 12-13 Beaumont Gate Shenley Hill Radlett Hertfordshire WD7 7AR United Kingdom* in data 07 set 2010

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 25 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di BLISSCORP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CARISS, John Stuart
    The Cedars 3 Telegraph Cottage
    Warren Road
    KT2 7HU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    The Cedars 3 Telegraph Cottage
    Warren Road
    KT2 7HU Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritish69554890001
    CHARLES, Peter Royston
    7 Antrobus Road
    W4 5HY London
    Segretario
    7 Antrobus Road
    W4 5HY London
    British59245270002
    MORGAN, John
    129 Hollywood Lane
    Wainscott
    ME3 8AS Rochester
    Kent
    Segretario
    129 Hollywood Lane
    Wainscott
    ME3 8AS Rochester
    Kent
    British107813300002
    ROBERTSON, Andrew Gordon
    5 Newland Close
    AL1 1TE St Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    5 Newland Close
    AL1 1TE St Albans
    Hertfordshire
    British37684480002
    ROBERTSON, Andrew Gordon
    34 Abbots Park
    London Road
    AL1 1TW St Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    34 Abbots Park
    London Road
    AL1 1TW St Albans
    Hertfordshire
    British37684480001
    ROBERTSON, Carolyn Jill
    Clarkhill Bank
    Askham
    CA10 2PG Penrith
    Cumbria
    Segretario
    Clarkhill Bank
    Askham
    CA10 2PG Penrith
    Cumbria
    British37684470002
    WHALE ROCK SECRETARIES LIMITED
    Floor 15 Basinghall Street
    EC2V 5BR London
    4th
    England
    Segretario
    Floor 15 Basinghall Street
    EC2V 5BR London
    4th
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02260552
    121859090002
    HARLING, Derek John
    25 Harrow Road
    West Bridgford
    NG2 7DW Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    25 Harrow Road
    West Bridgford
    NG2 7DW Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish86888780001
    MARCINOWICZ, Leszek Andrzej
    55 Nascot Wood Road
    WD17 4SJ Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    55 Nascot Wood Road
    WD17 4SJ Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritish98072770001
    MORGAN, John
    129 Hollywood Lane
    Wainscott
    ME3 8AS Rochester
    Kent
    Amministratore
    129 Hollywood Lane
    Wainscott
    ME3 8AS Rochester
    Kent
    British107813300002
    ROBERTSON, Andrew Gordon
    5 Newland Close
    AL1 1TE St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    5 Newland Close
    AL1 1TE St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish37684480002
    ROBERTSON, Carolyn Jill
    14 Coopers Close
    Askham
    CA10 2PN Penrith
    Cumbria
    Amministratore
    14 Coopers Close
    Askham
    CA10 2PN Penrith
    Cumbria
    British37684470001
    SMITH, Gary Vernon
    57 Marconi Way
    Hill End Lane
    AL4 0JG St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    57 Marconi Way
    Hill End Lane
    AL4 0JG St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish59129400002

    BLISSCORP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over receivables
    Creato il 18 mar 2011
    Consegnato il 30 mar 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all non-vesting receivables all other receivables and by way of floating charge the floating charge property.
    Persone aventi diritto
    • Ifg Network UK Limited T/as the Interface Financial Group
    Transazioni
    • 30 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 14 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 22 apr 2009
    Consegnato il 24 apr 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transazioni
    • 24 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 22 apr 2009
    Consegnato il 24 apr 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the junior finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Cardale Investments LLP
    Transazioni
    • 24 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession and charge
    Creato il 30 nov 2007
    Consegnato il 12 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and all the other companies to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 05 ott 2006
    Consegnato il 10 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 10 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 28 feb 2002
    Consegnato il 12 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Invoice Discounting Limited (The Securityholder)
    Transazioni
    • 12 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 mar 2001
    Consegnato il 09 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as 12 and 13 beaumont gate shenley hill redlett hertfordshire title number HD284467. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 07 feb 2001
    Consegnato il 15 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 31 mag 1996
    Consegnato il 20 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BLISSCORP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    18 lug 2013Inizio della liquidazione
    29 nov 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Phillip Anthony Roberts
    Centurion Court, 83 Camp Road
    AL1 5JN St Albans
    Hertfordshire
    Praticante
    Centurion Court, 83 Camp Road
    AL1 5JN St Albans
    Hertfordshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0