JACOBS ENGINEERING UK LIMITED
Panoramica
| Nome della società | JACOBS ENGINEERING UK LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02527622 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di JACOBS ENGINEERING UK LIMITED?
- Estrazione di petrolio greggio (06100) / Attività estrattive
- Attività di supporto per l'estrazione di petrolio e gas naturale (09100) / Attività estrattive
Dove si trova JACOBS ENGINEERING UK LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Cottons Centre Cottons Lane SE1 2QG London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di JACOBS ENGINEERING UK LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| JACOBS INDUSTRIAL SERVICES U.K. LIMITED | 10 mag 2007 | 10 mag 2007 |
| JACOBS CATALYTIC (UK) LIMITED | 24 dic 2001 | 24 dic 2001 |
| DELTA CATALYTIC (UK) LIMITED | 14 dic 1992 | 14 dic 1992 |
| CATALYTIC SEAFORTH LIMITED | 05 set 1990 | 05 set 1990 |
| HEATGUARD LIMITED | 03 ago 1990 | 03 ago 1990 |
Quali sono gli ultimi bilanci di JACOBS ENGINEERING UK LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 01 ott 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per JACOBS ENGINEERING UK LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Nomina di Mr Geoffrey Roberts come segretario in data 21 ago 2023 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Rhona Mary Holman come segretario in data 21 ago 2023 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 ago 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Seconda presentazione di uno stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 22 giu 2023
| 4 pagine | RP04SH01 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 22 giu 2023
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 22 giu 2023
| 4 pagine | SH01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di Tejender Singh Chaudhary come segretario in data 10 feb 2023 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Nomina di Rhona Mary Holman come segretario in data 10 feb 2023 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 ago 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 01 ott 2021 | 23 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 02 ott 2020 | 27 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Mrs Sally Miles come amministratore in data 11 ago 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Guy Douglas come amministratore in data 11 ago 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 ago 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Modifica dei dettagli di Jacobs Uk Limited come persona con controllo significativo il 03 nov 2020 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2019 | 27 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Mr Alexander James Lane come amministratore in data 30 nov 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan R. Shattock come amministratore in data 30 nov 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Guy Douglas il 17 dic 2020 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di JACOBS ENGINEERING UK LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTS, Geoffrey | Segretario | Cottons Lane SE1 2QG London Cottons Centre United Kingdom | 312725650001 | |||||||
| LANE, Alexander James | Amministratore | Cottons Lane SE1 2QG London Cottons Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 244468210002 | |||||
| MILES, Sally Linda Joyce | Amministratore | Cottons Lane SE1 2QG London Cottons Centre United Kingdom | England | British | 161125950001 | |||||
| CHAUDHARY, Tejender Singh | Segretario | Cottons Lane SE1 2QG London Cottons Centre United Kingdom | 246699140001 | |||||||
| HOLMAN, Rhona Mary | Segretario | Cottons Lane SE1 2QG London Cottons Centre United Kingdom | 305629350001 | |||||||
| MACRAE, Anne Glover | Segretario | 32 Thornhill Square N1 1BQ London | British | 22068660001 | ||||||
| MARKLEY, William Clyde | Segretario | 2105 Sunnybank Drive La Canada 91011 Flintridge California United States Of America | American | 57955380001 | ||||||
| NORRIS, Michael | Segretario | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | 148525420001 | |||||||
| PRICE, John Leslie | Segretario | 536 Coach Grove Road Sw FOREIGN Calgary Alberta T3h 1j4 Canada | Canadian | 14302230001 | ||||||
| THURGOOD, Brian Frederick | Segretario | 5828 Dalkeith Hill Nw T3A 1G4 Calgary Alberta Canada | Canadian | 49550720001 | ||||||
| UDOVIC, Michael | Segretario | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | 162669840001 | |||||||
| COADY, Arthur Bernard | Amministratore | 79 Bel Air Place Sw FOREIGN Calgary Alberta T2z 2c3 Canada | Canadian | 14302210001 | ||||||
| CODY, William Wesley | Amministratore | Apartment 3 Building 226 Village Terrace Sw Calgary Alberta T3h 2l1 | American | 30681950001 | ||||||
| DOUGLAS, Guy | Amministratore | Cottons Lane SE1 2QG London Cottons Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 258025190001 | |||||
| DOYLE, John Conor | Amministratore | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | England | Irish | 78009780001 | |||||
| DUFF, Robert Shepherd | Amministratore | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | Scotland | British | 165632810001 | |||||
| HOPKINSON, Dennis Ian | Amministratore | 18 Pasture Drive LN11 8XA Louth Lincolnshire | British | 24328510003 | ||||||
| IRVIN, Robert Anthony Michael | Amministratore | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | England | British | 161055320001 | |||||
| JONES, Graham Roger | Amministratore | Coningsby 81 The Rise TN13 1RN Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 42069750001 | |||||
| MCLACHLAN, John | Amministratore | 12 Kensington Gate W8 5NA London | British | 61996190001 | ||||||
| MCNAMARA, Michael | Amministratore | Briar Farm Cheapside DN37 0JA Waltham North East Lincolnshire | England | British | 151846040001 | |||||
| PENNER, Henry David | Amministratore | 47 Woodgreen Place Sw FOREIGN Calgary Alberta T2w 4a3 Canada | Canadian | 24328500001 | ||||||
| PRICE, John Leslie | Amministratore | 536 Coach Grove Road Sw FOREIGN Calgary Alberta T3h 1j4 Canada | Canadian | 14302230001 | ||||||
| PROSSER, John Warren | Amministratore | 3323 Castera Avenue 91208 Glendale California Usa | Usa | American | 57955140001 | |||||
| RALSTON, Paul Eric | Amministratore | 828 Sunset Crescent S E Calgary T2x 3eb FOREIGN Alberta Canada | American | 54423010001 | ||||||
| SEATON, Paul | Amministratore | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire | England | British | 204466160001 | |||||
| SHATTOCK, Jonathan R. | Amministratore | Cottons Lane SE1 2QG London Cottons Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 259549880001 | |||||
| STASSI, Philip John | Amministratore | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | Usa | United States | 133430050001 | |||||
| TAYLOR, Allyn Byram | Amministratore | Mill Lane Cookham SL6 9QT Maidenhead Formosa Court House Berkshire United Kingdom | England | United States | 124922150002 | |||||
| THIBEAULT, Rejean Joseph | Amministratore | Site 40 PO BOX 13 Rr Number 4 T2M 4L4 Calgary Alberta Canada | Canadian | 49550530001 | ||||||
| THURGOOD, Brian Frederick | Amministratore | 5828 Dalkeith Hill Nw T3A 1G4 Calgary Alberta Canada | Canadian | 49550720001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di JACOBS ENGINEERING UK LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacobs Uk Limited | 06 apr 2016 | Cottons Lane SE1 2QG London Cottons Centre United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
JACOBS ENGINEERING UK LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Creato il 15 giu 1992 Consegnato il 01 lug 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 15/06/92 | |
Brevi particolari £6,249.00 deposited as security with royal bank of scotland PLC park row leeds. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 02 apr 1991 Consegnato il 15 apr 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease | |
Brevi particolari £4,250. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 15 mar 1991 Consegnato il 20 mar 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A fixed charge on all book & other debts owing to the company. Floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0