LTC RESIDENTIAL LIMITED

LTC RESIDENTIAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLTC RESIDENTIAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02534762
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LTC RESIDENTIAL LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova LTC RESIDENTIAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    28 Old Church Street
    London
    SW3 5BY
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LTC RESIDENTIAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PREDATOR ONE LIMITED24 ago 199024 ago 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di LTC RESIDENTIAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per LTC RESIDENTIAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    15 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 ago 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2015

    17 pagineAA

    legacy

    38 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Bilancio annuale redatto al 24 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 ago 2015

    Stato del capitale al 26 ago 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Gwynne Smith il 01 ago 2015

    2 pagineCH01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 05 gen 2015

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share premium account 16/12/2014
    RES13

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2014

    17 pagineAA

    legacy

    34 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Bilancio annuale redatto al 24 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 set 2014

    Stato del capitale al 03 set 2014

    • Capitale: GBP 2,500,011
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Gwynne Smith il 01 set 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Geoffrey John Griggs il 01 set 2014

    1 pagineCH03

    Soddisfazione dell'onere 23 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 025347620030 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2013

    17 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di LTC RESIDENTIAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GRIGGS, Geoffrey John
    28 Old Church Street
    London
    SW3 5BY
    Segretario
    28 Old Church Street
    London
    SW3 5BY
    British16580510001
    MATTHEWS, Timothy Ian
    28 Old Church Street
    London
    SW3 5BY
    Amministratore
    28 Old Church Street
    London
    SW3 5BY
    EnglandBritish108845860001
    SMITH, Richard Gwynne
    28 Old Church Street
    London
    SW3 5BY
    Amministratore
    28 Old Church Street
    London
    SW3 5BY
    United KingdomBritish168772030001
    DEARLING, Lynne Joyce
    55 Huntingdon Road
    N2 9DX London
    Segretario
    55 Huntingdon Road
    N2 9DX London
    Welsh60000900001
    DIMENT, Peter Charles Michael
    4 Westfield Close
    CM23 2RD Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Segretario
    4 Westfield Close
    CM23 2RD Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British32770400001
    DOWDESWELL, Jacqueline Anne
    54
    Lower Westwood
    BA15 2AE Bradford On Avon
    Wiltshire
    Segretario
    54
    Lower Westwood
    BA15 2AE Bradford On Avon
    Wiltshire
    British50592080001
    GULHANE, Angeli Asha
    Flat 4
    3 Lansdown Crescent
    BA1 5EX Bath
    Avon
    Segretario
    Flat 4
    3 Lansdown Crescent
    BA1 5EX Bath
    Avon
    British38173040001
    SWEETLAND, Duncan Barrington John
    Periwinkle Cottage
    Perry Hill, Worplesdon
    GU3 3RG Guildford
    Surrey
    Segretario
    Periwinkle Cottage
    Perry Hill, Worplesdon
    GU3 3RG Guildford
    Surrey
    British46467820005
    WILKES, Rupert Thomas James
    4 The Crescent
    PE13 1EH Wisbech
    Cambridgeshire
    Segretario
    4 The Crescent
    PE13 1EH Wisbech
    Cambridgeshire
    British71363620004
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    HARE, Nicholas Patrick
    Manor Farm
    Culkerton
    GL8 8SS Tetbury
    Gloucestershire
    Amministratore
    Manor Farm
    Culkerton
    GL8 8SS Tetbury
    Gloucestershire
    British34878680001
    HAWKINS, Christopher James
    20 Northweald Lane
    KT2 5GW Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    20 Northweald Lane
    KT2 5GW Kingston Upon Thames
    Surrey
    British50135940001
    LO, Robert Anthony
    113 Arthur Road
    Wimbledon
    SW19 7DR London
    Amministratore delegato nominato
    113 Arthur Road
    Wimbledon
    SW19 7DR London
    British900005400001
    SAUNDERS, Timothy, Mr.
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    Amministratore
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    EnglandBritish47952140001
    WEBB, Maurice Clifford
    32b Argyle Street
    WC1H 8EN London
    Amministratore
    32b Argyle Street
    WC1H 8EN London
    British2664040002
    WILKES, Rupert Thomas James
    4 The Crescent
    PE13 1EH Wisbech
    Cambridgeshire
    Amministratore
    4 The Crescent
    PE13 1EH Wisbech
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish71363620004

    Chi sono le persone con controllo significativo di LTC RESIDENTIAL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Old Church Street
    SW3 5BY London
    28
    England
    01 ago 2016
    Old Church Street
    SW3 5BY London
    28
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneUnited Kingdom
    Numero di registrazione02570517
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    LTC RESIDENTIAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 08 mag 2013
    Consegnato il 13 mag 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Cutty sark house, undine road, millwall, london E14 9UW (registered at the land registry with title number EGL456067). Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The LLP Property Pcc Limited on Behalf of Eaton Active Special Opportunity Property Fund
    Transazioni
    • 13 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 29 giu 2007
    Consegnato il 05 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a 20 vale court mallord street london t/n NGL321315. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 29 giu 2007
    Consegnato il 05 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a oakview apartments 10-12 benhill road sutton t/n SGL622410 and SY258250. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 29 giu 2007
    Consegnato il 05 lug 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a gwynn house 94 lower sloane street london t/n NGL247144. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 29 giu 2007
    Consegnato il 05 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H flat 39 daver court chelsea manor street london t/n NGL343575. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 29 giu 2007
    Consegnato il 05 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a 34 daver court chelsea manor street london t/NNGL190033. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 29 giu 2007
    Consegnato il 05 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a flat 2 14 finborough road london t/n NGL381483. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 giu 2007
    Consegnato il 05 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a cutty sark house undine road london t/n EGL456067 l/h first floor flat 4 and parking space cutty sark house t/n EGL256120 l/h ground floor flat 1 and parking space cutty sark house t/n EGL256550 for further details of the properties charged please refer to form 395. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 11 mag 2007
    Consegnato il 31 mag 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 31 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Assignment of rental income
    Creato il 01 ago 2003
    Consegnato il 20 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All its right title benefit and interest in and to the rental income.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 ago 2003
    Consegnato il 20 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property 5 terrace road maidstone kent t/no K235446; 60 allen street maidstone kent K347662; 62 allen street maidstone kent t/no K209446 (for further property charged refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 mag 2003
    Consegnato il 16 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    29 wolverton avenue kingston-upon-thames surrey KT2 7QF t/no SGL626239.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 mar 2003
    Consegnato il 18 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £56,191.38 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The property k/a 22 kershaw crescent halifax.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 gen 2003
    Consegnato il 10 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £46,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    58 darley road,liversedge,bradford WF15 6QB.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 gen 2003
    Consegnato il 10 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £41,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    65 chapel street,eccleshill,bradford BD2 2DA.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed
    Creato il 28 nov 2002
    Consegnato il 11 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £81,000.00 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    40 christie close walderslade chatham kent ME5 7NG.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 28 nov 2002
    Consegnato il 04 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £160,599.90
    Brevi particolari
    29 bishops road london.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 28 nov 2002
    Consegnato il 04 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £80,500 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    79 ashfields pitsea essex.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 feb 2001
    Consegnato il 28 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property with title no.LN59231,kensington and chelsea,gt.london. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 gen 2001
    Consegnato il 24 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental account charge
    Creato il 12 gen 2001
    Consegnato il 24 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the charged accounts being:caledonian 00698665 (bank of scotland) and the secured amounts and all the entitlements to interest and the other rights and benefits in the connection with the secured amounts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of rental income
    Creato il 30 mar 2000
    Consegnato il 06 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The company full title guarantee all its right title benefit and interest all rent or other sums of money. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 06 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mar 2000
    Consegnato il 06 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property known as 14 finborough road london SW10 title number NGL381483, 1 cutty sark house, london E14 title number EGL256550, 2 cutty sark house, london E14 title number EGL273580 for further property details see ch microfiche,.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 06 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Account charge
    Creato il 30 mar 2000
    Consegnato il 06 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a facilities agreement dated 10 july 1998
    Brevi particolari
    Full title guarantee and as a continuing security for the payment and discharge of the secured obligations. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 06 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 lug 1998
    Consegnato il 22 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 22 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0