PHOENIX (GLASGOW) LIMITED

PHOENIX (GLASGOW) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPHOENIX (GLASGOW) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02536540
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PHOENIX (GLASGOW) LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova PHOENIX (GLASGOW) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    One St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PHOENIX (GLASGOW) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NPL PHOENIX LIMITED03 apr 200203 apr 2002
    TILBURY PHOENIX LIMITED29 mag 199129 mag 1991
    INTERCEDE 875 LIMITED04 set 199004 set 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di PHOENIX (GLASGOW) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per PHOENIX (GLASGOW) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Eric Raymond Taylor come amministratore in data 06 dic 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michelle Lappin come amministratore in data 26 nov 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione di Michelle Lappin come persona con controllo significativo il 26 nov 2018

    1 paginePSC07

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2017

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 set 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 set 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016

    6 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Addleshaw Booth & Co 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB a One St Peter's Square Manchester M2 3DE in data 20 feb 2017

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 ott 2016 con aggiornamenti

    7 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 set 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015

    6 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 set 2015

    Stato del capitale al 07 set 2015

    • Capitale: GBP 113
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 04 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 set 2014

    Stato del capitale al 09 set 2014

    • Capitale: GBP 113
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013

    3 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 set 2013

    Stato del capitale al 13 set 2013

    • Capitale: GBP 113
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 04 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2011

    5 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 04 set 2010

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2009

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di PHOENIX (GLASGOW) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRADBURY, Trevor
    22 East Park Farm Drive
    Charvil
    RG10 9UL Reading
    Berkshire
    Segretario
    22 East Park Farm Drive
    Charvil
    RG10 9UL Reading
    Berkshire
    British47884750003
    CLITHEROE, David Maurice
    3 Norman Court
    Oadby
    LE2 4UD Leicester
    Segretario
    3 Norman Court
    Oadby
    LE2 4UD Leicester
    BritishChartered Accountant49800090001
    SILBER, Adrian Giles
    Two Oaks 18 Barlows Road
    Edgbaston
    B15 2PL Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    Two Oaks 18 Barlows Road
    Edgbaston
    B15 2PL Birmingham
    West Midlands
    British10161590001
    BRODIES SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    15 Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    15 Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    Midlothian
    79799970001
    ASTHEIMER, Horst, Dipl-Kfm
    Taubenberg 77
    Idstein
    65510 Germany
    Germany
    Amministratore
    Taubenberg 77
    Idstein
    65510 Germany
    Germany
    GermanEngineer60804880001
    BEITZ, Frank Michael
    Amalien Str 75-2-113
    A 1130 Vienna
    Austria
    Amministratore
    Amalien Str 75-2-113
    A 1130 Vienna
    Austria
    AustrianSenior Bank Manager45351890001
    CLITHEROE, David Maurice
    3 Norman Court
    Oadby
    LE2 4UD Leicester
    Amministratore
    3 Norman Court
    Oadby
    LE2 4UD Leicester
    BritishChartered Accountant49800090001
    CLITHEROE, David Maurice
    3 Norman Court
    Oadby
    LE2 4UD Leicester
    Amministratore
    3 Norman Court
    Oadby
    LE2 4UD Leicester
    BritishChartered Accountant49800090001
    FUNK, Maximilian, Dr
    Sossenheimerweg 69
    Sulzbach
    Hessen D-6231
    Germany
    Amministratore
    Sossenheimerweg 69
    Sulzbach
    Hessen D-6231
    Germany
    GermanManaging Director16501260001
    HERON, Andrew Barnetson
    4 Holmwood Court
    KA30 8RT Largs
    Ayrshire
    Amministratore
    4 Holmwood Court
    KA30 8RT Largs
    Ayrshire
    BritishDevelopment Manager45567270001
    KAROLYI, Kurt, Dr
    Heinrich-Albrechtgasse 27
    FOREIGN Brunn/Gebirge
    Austria
    Amministratore
    Heinrich-Albrechtgasse 27
    FOREIGN Brunn/Gebirge
    Austria
    AustrianManaging Director30845850001
    LAPPIN, Michelle
    16 Knights Gate
    Bothwell
    G71 8SS Glasgow
    Amministratore
    16 Knights Gate
    Bothwell
    G71 8SS Glasgow
    ScotlandBritishDirector87722880002
    LEE, Malcolm Stuart
    Orchard Gate, Ashley Hill Place
    Cockpole Green
    RG10 8NL Wargrave
    Berkshire
    Amministratore
    Orchard Gate, Ashley Hill Place
    Cockpole Green
    RG10 8NL Wargrave
    Berkshire
    BritishGroup Finance Director12264540006
    MASON JONES, William Nicholas
    Pump House
    White Pump Lane, Ullenhall
    B95 5RL Henley In Arden
    West Midlands
    Amministratore
    Pump House
    White Pump Lane, Ullenhall
    B95 5RL Henley In Arden
    West Midlands
    BritishChartered Surveyor1749380004
    NICOLL, David Malcolm
    Barn House
    6 Oakfield Lane
    BR2 6BY Keston
    Kent
    Amministratore
    Barn House
    6 Oakfield Lane
    BR2 6BY Keston
    Kent
    BritishCompany Director1975880001
    PANNELL, Stephen James
    Suncroft
    Back Hill
    OX17 1HU Shotteswell
    Warwickshire
    England
    Amministratore
    Suncroft
    Back Hill
    OX17 1HU Shotteswell
    Warwickshire
    England
    BritishChartered Surveyor83986410001
    SILBER, Adrian Giles
    Two Oaks 18 Barlows Road
    Edgbaston
    B15 2PL Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    Two Oaks 18 Barlows Road
    Edgbaston
    B15 2PL Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritishChartered Accountant10161590001
    SLATER, Trevor
    17 Yewdale
    196 Harborne Park Road Harborne
    B17 0BP Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    17 Yewdale
    196 Harborne Park Road Harborne
    B17 0BP Birmingham
    West Midlands
    BritishCompany Director39823150001
    TAYLOR, Eric Raymond
    11 Burnside Road
    Whitecraigs
    G73 4RF Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    11 Burnside Road
    Whitecraigs
    G73 4RF Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritishDirector68612520001
    WENTZELL, Graham John
    1 Tithe Court
    Glebelands Road
    RG40 1DS Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    1 Tithe Court
    Glebelands Road
    RG40 1DS Wokingham
    Berkshire
    BritishCivil Engineer64466870001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PHOENIX (GLASGOW) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Ms Michelle Lappin
    Knights Gate
    Bothwell
    G71 8SS Glasgow
    16
    Scotland
    01 set 2016
    Knights Gate
    Bothwell
    G71 8SS Glasgow
    16
    Scotland
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: Scotland
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    Mr Robert Mcfarlane
    St. Vincent Street
    G2 5QD Glasgow
    1st Floor, 183
    Scotland
    01 set 2016
    St. Vincent Street
    G2 5QD Glasgow
    1st Floor, 183
    Scotland
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: Scotland
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Mr Eric Raymond Taylor
    Burnside Road
    Rutherglen
    G73 4RF Glasgow
    11
    Scotland
    01 set 2016
    Burnside Road
    Rutherglen
    G73 4RF Glasgow
    11
    Scotland
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: Scotland
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.

    PHOENIX (GLASGOW) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security which was presented for registration in scotland on 26 march 2002 and
    Creato il 21 mar 2002
    Consegnato il 04 apr 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as tilbury phoenix limited) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    (1) all and whole the subjects k/a phoenix business park, linwood t/no. REN55134 and (2) all and whole the area of ground at the said phoenix business park t/no. REN97541.
    Persone aventi diritto
    • Interserve PLC
    Transazioni
    • 04 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 6TH august 1999 and
    Creato il 27 lug 1999
    Consegnato il 13 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £620,000 and all other sums and obligations due or to become due from the company to the chargee constituted by formal letters between maclay murray and spens and mcclure and partners dated 20 and 21 july 1999
    Brevi particolari
    The property paisley retail park, linwood road, paisley.
    Persone aventi diritto
    • Bondflair Limited
    Transazioni
    • 13 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Sandard security which was presented for registration in scotland 22ND december 1998
    Creato il 21 dic 1998
    Consegnato il 06 gen 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of a contribution agreement constituted bt formal letters dated 9TH,14TH and 15TH december 1998 ("the agreement") including any formal variation thereof and any deed supplemental thereto and in security of all other obligations due by the company to the chargee in terms of the agreement
    Brevi particolari
    All and whole the subjects comprising that area of ground with the office pavillions thereon k/a and forming chiron house,trojan house and phoenix house at the phoenix business park paisley together with the car parking and other areas pertaining thereto and all and whole those subjects lying on the north side of linwood road t/n REN55134 together with all buildings and erections thereon for full details please refer to form 395.
    Persone aventi diritto
    • Renfrewshire Enterprise
    Transazioni
    • 06 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0