CASHEW CHILDRENS NURSERIES LIMITED

CASHEW CHILDRENS NURSERIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCASHEW CHILDRENS NURSERIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02538184
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CASHEW CHILDRENS NURSERIES LIMITED?

    • Istruzione prescolare (85100) / Istruzione

    Dove si trova CASHEW CHILDRENS NURSERIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o C/O TREETOPS NURSERIES LIMITED
    1 St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CASHEW CHILDRENS NURSERIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DUNMAR (NURSERIES) LIMITED07 set 199007 set 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di CASHEW CHILDRENS NURSERIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CASHEW CHILDRENS NURSERIES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CASHEW CHILDRENS NURSERIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 07 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 ott 2014

    Stato del capitale al 06 ott 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 07 ago 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 30 set 2013

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Nomina di Mr Charles Edmund Patrick Eggleston come amministratore in data 11 set 2013

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Hancock come amministratore in data 10 mag 2013

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 set 2012

    3 pagineAA

    Dimissioni di un revisore

    2 pagineAA03

    Cessazione della carica di Alan James Proto come amministratore in data 18 set 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 07 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 set 2011

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Clare Elizabeth Wilson come amministratore in data 05 apr 2012

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Clare Elizabeth Wilson come amministratore in data 29 mar 2012

    2 pagineAP01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Amendment and restatement agmnt 29/02/2012
    RES13

    legacy

    3 pagineMG02

    Nomina di Mrs Clare Elizabeth Wilson come amministratore in data 17 gen 2012

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr David Hancock come amministratore in data 17 gen 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nexus Management Services Limited come segretario in data 09 gen 2012

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O C/O Nexus Management Services Ltd 2nd Floor Griffin House West Street Woking Surrey GU21 6BS United Kingdom in data 11 gen 2012

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di CASHEW CHILDRENS NURSERIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILSON, Clare Elizabeth
    c/o C/O Treetops Nurseries Limited
    St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    1
    United Kingdom
    Segretario
    c/o C/O Treetops Nurseries Limited
    St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    1
    United Kingdom
    165810620001
    EGGLESTON, Charles Edmund Patrick
    c/o C/O Treetops Nurseries Limited
    St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o C/O Treetops Nurseries Limited
    St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish88878580004
    WILSON, Clare Elizabeth
    c/o C/O Treetops Nurseries Limited
    St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o C/O Treetops Nurseries Limited
    St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish148642230002
    DUCKITT, David Nicholas
    12 Earls Crescent
    Oakwood
    DE21 2QB Derby
    Derbyshire
    Segretario
    12 Earls Crescent
    Oakwood
    DE21 2QB Derby
    Derbyshire
    British39020250001
    FINNITY, Janet Elizabeth
    Chestnut House
    Hollington Ashbourne
    DE6 3GB Derby
    Segretario
    Chestnut House
    Hollington Ashbourne
    DE6 3GB Derby
    British90883620001
    FOSTER, Caroline Ann
    Little Knowle
    Nether Lane
    DE56 4AP Hazelwood
    Derbyshire
    Segretario
    Little Knowle
    Nether Lane
    DE56 4AP Hazelwood
    Derbyshire
    British55169500001
    FOSTER, Paul Martin
    12 Earls Crescent
    Oakwood
    DE21 2QB Derby
    Segretario
    12 Earls Crescent
    Oakwood
    DE21 2QB Derby
    British39471300001
    FOSTER, Paul Martin
    Dunmar House
    Cloves Hill
    DE7 6DH Morley
    Derbyshire
    Segretario
    Dunmar House
    Cloves Hill
    DE7 6DH Morley
    Derbyshire
    British16609250002
    NEXUS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Floor Griffin House
    West Street
    GU21 6BS Woking
    2nd
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Floor Griffin House
    West Street
    GU21 6BS Woking
    2nd
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4187765
    57253330002
    TLT SECRETARIES LIMITED
    One Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    Segretario
    One Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    77278550001
    FOSTER, Jacqueline
    Dunmar House
    Cloves Hill
    DE7 6DH Morley
    Derbyshire
    Amministratore
    Dunmar House
    Cloves Hill
    DE7 6DH Morley
    Derbyshire
    British19372380001
    FOSTER, Paul Martin
    Little Knowle
    Nether Lane
    DE56 4AP Hazelwood
    Derbyshire
    Amministratore
    Little Knowle
    Nether Lane
    DE56 4AP Hazelwood
    Derbyshire
    EnglandBritish16609250003
    HANCOCK, David
    c/o C/O Treetops Nurseries Limited
    St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o C/O Treetops Nurseries Limited
    St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish166213530001
    PROTO, Alan James
    c/o C/O Treetops Nurseries Limited
    St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o C/O Treetops Nurseries Limited
    St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish41906780005
    WILSON, Clare Elizabeth
    c/o C/O Treetops Nurseries Limited
    St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o C/O Treetops Nurseries Limited
    St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish148642230002
    WINTERBOTHAM, David Mark
    1 Mulberries Court
    Allestree
    DE22 2HL Derby
    Amministratore
    1 Mulberries Court
    Allestree
    DE22 2HL Derby
    EnglandBritish47185690001

    CASHEW CHILDRENS NURSERIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of debenture
    Creato il 28 dic 2007
    Consegnato il 08 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 08 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 02 set 2003
    Consegnato il 06 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Littlemoor house littlemoor road pudsey t/n WYK723357 and WYK730712. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 ago 2003
    Consegnato il 30 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 mag 2002
    Consegnato il 04 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a littlemoor house littlemoor road pudsey leeds. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 ott 2001
    Consegnato il 06 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage over all that l/h property k/a treetops day nursery and kindergarten, chapel lane, wythall, worcestershire B47 6AJ.. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 ott 2001
    Consegnato il 06 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage over all that l/h property k/a treetops day nursery and kindergarten, chesterfield road, matlock t/n DY310406.. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 ott 2001
    Consegnato il 06 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 ago 1998
    Consegnato il 04 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0