ATKINS ADVANTAGE SYSTEM SOLUTIONS LIMITED

ATKINS ADVANTAGE SYSTEM SOLUTIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàATKINS ADVANTAGE SYSTEM SOLUTIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02541313
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ATKINS ADVANTAGE SYSTEM SOLUTIONS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ATKINS ADVANTAGE SYSTEM SOLUTIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ATKINS ADVANTAGE SYSTEM SOLUTIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ATKINS ADVANTAGE SYSTEMS SOLUTIONS LIMITED20 mar 200720 mar 2007
    ADVANTAGE SYSTEM SOLUTIONS LIMITED05 gen 200505 gen 2005
    TA GROUP LIMITED15 mar 199115 mar 1991
    STEVTON (NO. 22) LIMITED19 set 199019 set 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di ATKINS ADVANTAGE SYSTEM SOLUTIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ATKINS ADVANTAGE SYSTEM SOLUTIONS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ATKINS ADVANTAGE SYSTEM SOLUTIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Re dividend 11/12/2014
    RES13

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 05 gen 2015

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 20 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Alun Hughes Griffiths come amministratore in data 30 lug 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Alan James Cullens come amministratore in data 01 lug 2014

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Heath Stewart Drewett il 08 ago 2012

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Richard Webster come amministratore in data 01 gen 2012

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Steven Johnson come amministratore in data 30 nov 2011

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 20 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Steven Johnson come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ian Purser come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    11 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ATKINS ADVANTAGE SYSTEM SOLUTIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BAKER, Helen Alice
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Segretario
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    British108742050002
    WEBSTER, Richard
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Segretario
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    British85595860003
    CULLENS, Alan James
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Amministratore
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish189297280001
    DREWETT, Heath Stewart
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Amministratore
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish167727030003
    WEBSTER, Richard
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Amministratore
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish85595860003
    DAVIS, Philip Stephen James
    Hartland
    Woodside Drive
    RG18 9QD Hermitage
    Berkshire
    Segretario
    Hartland
    Woodside Drive
    RG18 9QD Hermitage
    Berkshire
    British71932630003
    MCMICHAEL, Peter John James
    99 Crookham Road
    Church Crookham
    GU51 5NP Fleet
    Hampshire
    Segretario
    99 Crookham Road
    Church Crookham
    GU51 5NP Fleet
    Hampshire
    British61866370001
    NICHOLLS, Michael Charles
    Dene Lodge
    63 The Street
    GU10 4QS Wrecclesham
    Surrey
    Segretario
    Dene Lodge
    63 The Street
    GU10 4QS Wrecclesham
    Surrey
    British82034810001
    STRUKELJ, Mark
    Glasnor Charters Road
    Sunningdale
    SL5 9QF Ascot
    Berkshire
    Segretario
    Glasnor Charters Road
    Sunningdale
    SL5 9QF Ascot
    Berkshire
    American41928460001
    THOMAS, Brian
    Camellia Lodge Longdown Road
    Lower Bourne
    GU10 3JU Farnham
    Surrey
    Segretario
    Camellia Lodge Longdown Road
    Lower Bourne
    GU10 3JU Farnham
    Surrey
    British7880860003
    WROE, Nigel Robert
    132 Henley Drive
    Frimley Green
    GU16 6JT Camberley
    Surrey
    Segretario
    132 Henley Drive
    Frimley Green
    GU16 6JT Camberley
    Surrey
    British38568880001
    BELL, Malcolm
    46 Beckside Gardens
    Chapel House
    NE5 1BQ Newcastle Upon Tyne
    Northumberland
    Amministratore
    46 Beckside Gardens
    Chapel House
    NE5 1BQ Newcastle Upon Tyne
    Northumberland
    United KingdomBritish54168450001
    BRISTOW, Robert Philip, Dr
    86 Westfield Road
    GU22 9QA Woking
    Surrey
    Amministratore
    86 Westfield Road
    GU22 9QA Woking
    Surrey
    EnglandBritish94953340001
    EARL, John Gilbert George
    7 Forest Crescent
    KT21 1JU Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    7 Forest Crescent
    KT21 1JU Ashtead
    Surrey
    British7880890001
    ENGLISH, Colin Nigel
    97 Clarence Road
    GU51 3RS Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    97 Clarence Road
    GU51 3RS Fleet
    Hampshire
    British54168540002
    GORMAN, Keith Michael Robert
    22 Haywarden Place
    Hartley Wintney
    RG27 8UA Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    22 Haywarden Place
    Hartley Wintney
    RG27 8UA Basingstoke
    Hampshire
    British47319860001
    GRIFFITHS, Alun Hughes
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Amministratore
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    EnglandBritish47764900002
    GRINSTED, Noel William Marcus
    Tamarind House
    29 The Square
    PO14 4RT Titchfield
    Hampshire
    Amministratore
    Tamarind House
    29 The Square
    PO14 4RT Titchfield
    Hampshire
    British18312850003
    ISOM, Byrd
    584 Parks Cross Roads
    Ch Rd
    27316 Ramseur Nc
    America
    Amministratore
    584 Parks Cross Roads
    Ch Rd
    27316 Ramseur Nc
    America
    American69290680001
    JOHNSON, Steven
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Amministratore
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish161365240001
    MACDONALD, John Malcolm Kenneth
    Ensor
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Amministratore
    Ensor
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    British33673310001
    MACLEOD, Robert James
    Guildford Road
    GU6 8LT Cranleigh
    Norther Farm
    Surrey
    Amministratore
    Guildford Road
    GU6 8LT Cranleigh
    Norther Farm
    Surrey
    United KingdomBritish90186680002
    MATHEW, Andrew Edwin
    1 Clare Mead
    Rowledge
    GU10 4BJ Farnham
    Surrey
    Amministratore
    1 Clare Mead
    Rowledge
    GU10 4BJ Farnham
    Surrey
    British6661010001
    MCFALL, Godfrey
    Aspen Lodge
    78 Aldershot Road
    GU51 3FT Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    Aspen Lodge
    78 Aldershot Road
    GU51 3FT Fleet
    Hampshire
    British107285880001
    MCINNES, Alexander
    16 Brent Field Circle
    AB41 9DD Ellon
    Aberdeenshire
    Amministratore
    16 Brent Field Circle
    AB41 9DD Ellon
    Aberdeenshire
    British6661020002
    MCMICHAEL, Peter John James
    99 Crookham Road
    Church Crookham
    GU51 5NP Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    99 Crookham Road
    Church Crookham
    GU51 5NP Fleet
    Hampshire
    British61866370001
    OGBORN, Alan Frederick
    22 Station Road
    NR34 9QJ Beccles
    Suffolk
    Amministratore
    22 Station Road
    NR34 9QJ Beccles
    Suffolk
    British790970001
    PERCIVAL, David Robin
    11 Lamborne Close
    GU47 8JL Sandhurst
    Berkshire
    Amministratore
    11 Lamborne Close
    GU47 8JL Sandhurst
    Berkshire
    EnglandBritish64840320001
    PURSER, Ian Robert
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Amministratore
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish61343830005
    ROBINS, Geoffrey Alan, Dr
    Oakland House Oakland Road
    RG28 7HB Whitchurch
    Hampshire
    Amministratore
    Oakland House Oakland Road
    RG28 7HB Whitchurch
    Hampshire
    United KingdomBritish54321770001
    ROBINS, Geoffrey Alan, Dr
    Oakland House Oakland Road
    RG28 7HB Whitchurch
    Hampshire
    Amministratore
    Oakland House Oakland Road
    RG28 7HB Whitchurch
    Hampshire
    United KingdomBritish54321770001
    STRUKELJ, Mark
    Glasnor Charters Road
    Sunningdale
    SL5 9QF Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Glasnor Charters Road
    Sunningdale
    SL5 9QF Ascot
    Berkshire
    American41928460001
    THOMAS, Brian
    Camellia Lodge Longdown Road
    Lower Bourne
    GU10 3JU Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Camellia Lodge Longdown Road
    Lower Bourne
    GU10 3JU Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish7880860003
    WHITE, Alan Alfred
    Craig Eunan House
    St Eunan's Road
    AB34 5HH Aboyne
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Craig Eunan House
    St Eunan's Road
    AB34 5HH Aboyne
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish1376100002
    WIGET, Paul
    Hirschistrasse 21
    6430 Schwyz
    Kt Schwyz
    Switzerland
    Amministratore
    Hirschistrasse 21
    6430 Schwyz
    Kt Schwyz
    Switzerland
    Swiss41928420001

    ATKINS ADVANTAGE SYSTEM SOLUTIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture granted by the company,advantage business group limited and business mapping limited,now known as advantage business solutions limited, (together the "chargors")
    Creato il 15 feb 2001
    Consegnato il 02 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness of the chargors (as defined) to the chargee on any account whatsoever under this debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fluor International Limited
    Transazioni
    • 02 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 feb 2001
    Consegnato il 27 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all book and other debts both present and future and the benefit of all contracts policies of insurance in relation to such book and other debts by way of first floating charge the undertaking and all property assets and rights of the company whatsoever and wheresoever.
    Persone aventi diritto
    • Euro Sales Finance PLC
    Transazioni
    • 27 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 feb 2001
    Consegnato il 23 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Euro Sales Finance PLC
    Transazioni
    • 23 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 01 feb 1991
    Consegnato il 13 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 03 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 feb 1991
    Consegnato il 07 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 07 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 19 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0