SACOL 2010 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSACOL 2010 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02542477
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SACOL 2010 LIMITED?

    • (7415) /
    • (7499) /

    Dove si trova SACOL 2010 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    800 Field End Road
    South Ruislip
    HA4 0QH Middlesex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SACOL 2010 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LEFTFIELD SUPPORT SERVICES LIMITED13 mag 200913 mag 2009
    SACOL GROUP 1990 LIMITED07 nov 199007 nov 1990
    TARGETINDEX LIMITED24 set 199024 set 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di SACOL 2010 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per SACOL 2010 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 24 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 ott 2010

    Stato del capitale al 04 ott 2010

    • Capitale: GBP 255,500
    SH01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed leftfield support services LIMITED\certificate issued on 01/06/10
    2 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 28 apr 2010

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    1 pagineCONNOT

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 set 2009 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed sacol group 1990 LIMITED\certificate issued on 13/05/09
    2 pagineCERTNM

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    4 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    4 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 mar 2006

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di SACOL 2010 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LAVENDER, Michael David
    Forty Hill House
    EN2 9EU Forty Hill
    Middlesex
    Segretario
    Forty Hill House
    EN2 9EU Forty Hill
    Middlesex
    British149181030001
    FLYNN, Raymond Francis
    66 Kiln Park
    BT39 0BB Templepatrick
    County Antrim
    Northern Ireland
    Amministratore
    66 Kiln Park
    BT39 0BB Templepatrick
    County Antrim
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish119131330001
    SHANNON, Marcus John
    48 Loughanmore Road
    BT41 2HN Dunadry
    County Antrim
    N Ireland
    Amministratore
    48 Loughanmore Road
    BT41 2HN Dunadry
    County Antrim
    N Ireland
    United KingdomBritish108366960001
    COLLINS, Andrew John
    84 Stanlake Road
    W12 7HJ London
    Segretario
    84 Stanlake Road
    W12 7HJ London
    British4006390001
    JONES, Michael Adrian
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    Segretario
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    British77984700001
    O'CONNOR, Timothy Paul
    69 Andover Road
    SO22 6AU Winchester
    Hampshire
    Segretario
    69 Andover Road
    SO22 6AU Winchester
    Hampshire
    British80032590002
    RAWORTH, Paul John Basil
    1 Brandy Mount
    Cheriton
    SO24 0QQ Alresford
    Hampshire
    Segretario
    1 Brandy Mount
    Cheriton
    SO24 0QQ Alresford
    Hampshire
    British3381910002
    RAWORTH, Paul John Basil
    19 Campion Way
    Kings Worthy
    SO23 7QP Winchester
    Hampshire
    Segretario
    19 Campion Way
    Kings Worthy
    SO23 7QP Winchester
    Hampshire
    British3381910001
    WILLS, Simon
    Manor House
    Walton In Gordano
    BS21 7AN Clevedon
    Avon
    Segretario
    Manor House
    Walton In Gordano
    BS21 7AN Clevedon
    Avon
    British4183340001
    BRADMOUNT INVESTMENTS LIMITED
    25 Upper Brook Street
    Mayfair
    W1K 7QD London
    Segretario
    25 Upper Brook Street
    Mayfair
    W1K 7QD London
    95190940001
    BRADSHAW, Adrian Effland
    1 Lion Gate Gardens
    TW9 2DF Richmond
    Surrey
    Amministratore
    1 Lion Gate Gardens
    TW9 2DF Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish74991310001
    BROWN, Donald Harding
    Palliate House
    Alresford Road
    SO21 1HB Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    Palliate House
    Alresford Road
    SO21 1HB Winchester
    Hampshire
    British34201230001
    CHISNALL OBE, David Peter
    3 Langley Lodge Gardens
    Blackfield
    SO45 1FZ Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    3 Langley Lodge Gardens
    Blackfield
    SO45 1FZ Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritish173112920001
    JONES, Michael Adrian
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish77984700001
    O'CONNOR, Timothy Paul
    69 Andover Road
    SO22 6AU Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    69 Andover Road
    SO22 6AU Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish80032590002
    RAWORTH, Paul John Basil
    1 Brandy Mount
    Cheriton
    SO24 0QQ Alresford
    Hampshire
    Amministratore
    1 Brandy Mount
    Cheriton
    SO24 0QQ Alresford
    Hampshire
    British3381910002
    RAWORTH, Paul John Basil
    19 Campion Way
    Kings Worthy
    SO23 7QP Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    19 Campion Way
    Kings Worthy
    SO23 7QP Winchester
    Hampshire
    British3381910001
    STANCOMB, Arthur John Winterstoke
    Higher Berry Court
    Donhead St Mary
    SP7 0EP Shaftesbury
    Dorset
    Amministratore
    Higher Berry Court
    Donhead St Mary
    SP7 0EP Shaftesbury
    Dorset
    British4424500001
    WIGHTMAN, Timothy Redmayne
    Arden House 7 Rowley Crescent
    CV37 6UT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Arden House 7 Rowley Crescent
    CV37 6UT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritish8610650001
    WILLS, Simon
    Manor House
    Walton In Gordano
    BS21 7AN Clevedon
    Avon
    Amministratore
    Manor House
    Walton In Gordano
    BS21 7AN Clevedon
    Avon
    British4183340001

    SACOL 2010 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Collateral debenture
    Creato il 13 lug 1995
    Consegnato il 20 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from speed 5019 limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that piece or parcel of land off station road totton hampshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 20 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 lug 1995
    Consegnato il 17 lug 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land off station road totton hampshire. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 17 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed and floating charge
    Creato il 13 lug 1995
    Consegnato il 15 lug 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge
    Creato il 21 nov 1990
    Consegnato il 26 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land lying to the south of commercial road, totton, southampton, hampshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 26 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 13 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 21 nov 1990
    Consegnato il 26 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H properties situate at mell road commercial road, totton, southampton hampshire t/n hp 234203.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 26 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 13 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 21 nov 1990
    Consegnato il 26 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 26 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 13 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0