I.E. GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàI.E. GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02542977
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di I.E. GROUP LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova I.E. GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    48 Broadway
    PE1 1YW Peterborough
    Cambridgeshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di I.E. GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SEC GROUP PLC29 mar 199929 mar 1999
    SECURITISED ENDOWMENT CONTRACTS PLC22 nov 199022 nov 1990
    REALBOND PLC25 set 199025 set 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di I.E. GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per I.E. GROUP LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per I.E. GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 ott 2014

    Stato del capitale al 09 ott 2014

    • Capitale: GBP 2,264,402
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 ott 2013

    Stato del capitale al 18 ott 2013

    • Capitale: GBP 2,264,402
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2011 al 31 mar 2012

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 25 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    15 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr. Michael Alastair Couzens il 05 giu 2011

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Paul Hooper come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Couzens come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Marie Fiona Fisher come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Diana Monger come segretario

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da * Pixham End Dorking Surrey RH4 1QA* in data 20 mag 2011

    2 pagineAD01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio annuale redatto al 25 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Varie

    Section 519
    4 pagineMISC

    Cessazione della carica di Mark Wadelin come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Paul Hooper come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    13 pagineAA

    Nomina di Mrs Diana Monger come segretario

    1 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di I.E. GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FISHER, Marie Fiona
    Broadway
    PE1 1YW Peterborough
    48
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Broadway
    PE1 1YW Peterborough
    48
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish157495860001
    DRAIN, Antony Peter
    10 Eglington Road
    E4 7AN London
    Segretario
    10 Eglington Road
    E4 7AN London
    British60698090001
    ELLIS, Robert Gordon
    Severals
    Oakwood
    PO18 9AL Chichester
    West Sussex
    Segretario
    Severals
    Oakwood
    PO18 9AL Chichester
    West Sussex
    British33165610001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Segretario
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Segretario
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    MONGER, Diana
    Verdley Place
    Fernhurst
    GU27 3ER Haslemere
    Oefield House
    Surrey
    Segretario
    Verdley Place
    Fernhurst
    GU27 3ER Haslemere
    Oefield House
    Surrey
    148091340001
    PINNICK, Jeffrey
    34 Barnet Gate Lane
    EN5 2AB Barnet
    Hertfordshire
    Segretario
    34 Barnet Gate Lane
    EN5 2AB Barnet
    Hertfordshire
    British8659220002
    RENNIE, Kim Michelle
    58 Oxhey Avenue
    WD1 4HA Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    58 Oxhey Avenue
    WD1 4HA Watford
    Hertfordshire
    British65899240002
    TRUEMAN, Paul Roland
    71 Park Road
    CM14 4TU Brentwood
    Essex
    Segretario
    71 Park Road
    CM14 4TU Brentwood
    Essex
    British9145660001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Segretario
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    WILKINSON, Alan Steven
    11 Copthall Drive
    NW7 2ND London
    Segretario
    11 Copthall Drive
    NW7 2ND London
    British61982590001
    S F (FINANCIAL AND MANAGEMENT) SERVICES LIMITED
    23-25 Eastcastle Street
    W1N 8AE London
    Segretario
    23-25 Eastcastle Street
    W1N 8AE London
    16340140001
    ANSELL, Nicholas Paul
    Hetlee Farm Leigh Road
    SK9 6DS Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    Hetlee Farm Leigh Road
    SK9 6DS Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritish48033090001
    ATTWOOD, Thomas Roger
    Manor House
    Gills Green
    TN18 5AE Cranbrook Hawkshurst
    Kent
    Amministratore
    Manor House
    Gills Green
    TN18 5AE Cranbrook Hawkshurst
    Kent
    United KingdomBritish50051050001
    BARNARD, Nigel Parry
    19 Roehampton Court
    Queens Ride Barnes
    SW13 0HU London
    Amministratore
    19 Roehampton Court
    Queens Ride Barnes
    SW13 0HU London
    DenmarkBritish48030310001
    COLLINS, Adrian John Reginald
    4 Campden Hill Square
    W8 7LB London
    Amministratore
    4 Campden Hill Square
    W8 7LB London
    EnglandBritish465730003
    COUZENS, Michael Alastair
    Nell Hill
    Hannington
    SN6 7RU Wilstshire
    Nell House
    England
    England
    Amministratore
    Nell Hill
    Hannington
    SN6 7RU Wilstshire
    Nell House
    England
    England
    United KingdomBritish75553130006
    DRAIN, Antony Peter
    10 Eglington Road
    E4 7AN London
    Amministratore
    10 Eglington Road
    E4 7AN London
    United KingdomBritish60698090001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Amministratore
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    GREENWOOD, Timothy Sandiford
    Herons Brook
    Chelford Road Prestbury
    SK10 4AW Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    Herons Brook
    Chelford Road Prestbury
    SK10 4AW Macclesfield
    Cheshire
    United KingdomBritish101284380001
    HOOPER, Paul
    London Road
    Charlton Kings
    GL52 6UY Cheltenham
    Little Shipton
    Gloucester
    United Kingdom
    Amministratore
    London Road
    Charlton Kings
    GL52 6UY Cheltenham
    Little Shipton
    Gloucester
    United Kingdom
    United KingdomBritish152500600001
    KALISH, Geoffrey
    780 Third Avenue Ninth Floor
    Newyork
    Usa
    Amministratore
    780 Third Avenue Ninth Floor
    Newyork
    Usa
    American64379780001
    KLUG, Bernard Philip
    57 Sheldon Avenue
    N6 4NH London
    Amministratore
    57 Sheldon Avenue
    N6 4NH London
    British15387060001
    MARTIN, Ivan
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    Amministratore
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    EnglandBritish123233030001
    PINNICK, Jeffrey
    34 Barnet Gate Lane
    EN5 2AB Barnet
    Hertfordshire
    Amministratore
    34 Barnet Gate Lane
    EN5 2AB Barnet
    Hertfordshire
    EnglandBritish8659220002
    RADCLIFFE, Mark Hugh Joseph
    The Malt House
    Upton, Nr Andover
    SP11 0JS Andover
    Hampshire
    Amministratore
    The Malt House
    Upton, Nr Andover
    SP11 0JS Andover
    Hampshire
    British33402910003
    ROBSON, Rupert Hugo Wynne
    2 Carlyle Mansions
    Cheyne Walk
    SW3 5LS London
    Amministratore
    2 Carlyle Mansions
    Cheyne Walk
    SW3 5LS London
    British9727390002
    ROSENZWEIG, Max
    7 Williams Way
    WD7 7EZ Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    7 Williams Way
    WD7 7EZ Radlett
    Hertfordshire
    British74961040001
    TRUEMAN, Paul Roland
    71 Park Road
    CM14 4TU Brentwood
    Essex
    Amministratore
    71 Park Road
    CM14 4TU Brentwood
    Essex
    United KingdomBritish9145660001
    WADELIN, Mark Thomas
    26 Kings Coughton Lane
    Kings Coughton
    B49 5QE Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    26 Kings Coughton Lane
    Kings Coughton
    B49 5QE Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritish70575020005
    WADELIN, Mark Thomas
    26 Kings Coughton Lane
    Kings Coughton
    B49 5QE Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    26 Kings Coughton Lane
    Kings Coughton
    B49 5QE Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritish70575020005
    WEBSTER, John Dudley
    10 Merrydown Way
    BR7 5RS Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    10 Merrydown Way
    BR7 5RS Chislehurst
    Kent
    British457110001
    WILKINSON, Alan Steven
    11 Copthall Drive
    NW7 2ND London
    Amministratore
    11 Copthall Drive
    NW7 2ND London
    British61982590001
    MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Burleigh House
    Chapel Oak Salford Priors
    WR11 8SP Evesham
    Amministratore
    Burleigh House
    Chapel Oak Salford Priors
    WR11 8SP Evesham
    82547250002

    I.E. GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995
    Creato il 19 dic 2006
    Consegnato il 29 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    Creato il 17 set 2003
    Consegnato il 01 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    Creato il 11 set 2003
    Consegnato il 24 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 31 dic 1997
    Consegnato il 19 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all "deposits" in and to the charged account with barclays bank PLC re;-sec group PLC business premium account no;-00928852. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 dic 1997
    Consegnato il 15 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 apr 1997
    Consegnato il 18 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the counter-indemnity of even date
    Brevi particolari
    First fixed charge all its right title and interest in respect of:- the account held by the company with the bank at 38 mosley street manchester designated "the royal bank of scotland PLC - cash deposit be sec group PLC to support guarantee liability" under account number 20122924 (or such other replacement (account(s) in which the new deposit is held (the "new account")) and amount from time to time standing to the credit of the account and all rights accruing in respect of the new account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge over cash deposit
    Creato il 20 mag 1996
    Consegnato il 03 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a counter-indemnity of even date
    Brevi particolari
    All its right, title and interest in:- the account held by the company with the bank designated "rbs : re- sec group PLC" under account number:20078186 (the "account"). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage and assignment
    Creato il 28 nov 1991
    Consegnato il 11 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All policies of insurance and all moneys payable thereunder please see doc M200C for details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 set 1991
    Consegnato il 20 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (For further details see doc 396 tc ref M339C). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 21 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0