AEROFONE (UK) LIMITED
Panoramica
Nome della società | AEROFONE (UK) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02544334 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di AEROFONE (UK) LIMITED?
- Altre attività di telecomunicazioni (61900) / Informazione e comunicazione
Dove si trova AEROFONE (UK) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Daisy House Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Lancashire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di AEROFONE (UK) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2012 |
Quali sono le ultime deposizioni per AEROFONE (UK) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni | 2 pagine | SH08 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 28 mar 2013
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012 | 9 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 set 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Gareth Robert Kirkwood come amministratore in data 12 apr 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2011 | 17 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 set 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Peter Adam Daiches Dubens come amministratore in data 20 ott 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Stephen Alan Smith come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Anthony Riley come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Gareth Robert Kirkwood come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2010 | 20 pagine | AA | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter Adam Daiches Dubens il 04 nov 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 set 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Neil Gething come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 46 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di AEROFONE (UK) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGLENNON, David Lewis | Segretario | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire | 149405880001 | |||||||
RILEY, Matthew Robinson | Amministratore | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 178585250001 | ||||
SMITH, Stephen Alan | Amministratore | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire | United Kingdom | British | Company Director | 161471940001 | ||||
JONES, Jonathan Foster | Segretario | Lucks Farm Barn Greenwoods Lane Punnetts Town TN21 9HU Heathfield East Sussex | British | Director | 12127750001 | |||||
MARKS, David Alex | Segretario | Tinkers Hoe Queens Road Colmworth MK44 2LA Bedford Bedfordshire | British | Engineer | 6143510001 | |||||
MARKS, David Alex | Segretario | Tinkers Hoe Queens Road Colmworth MK44 2LA Bedford Bedfordshire | British | Engineer | 6143510001 | |||||
MARKS, Johanna Kesmin | Segretario | Wood End House Bedford Road, Pertenhall MK44 2AL Bedford Bedfordshire | British | Company Director | 86707150003 | |||||
MARKS, Johanna Kesmin | Segretario | Wood End House Bedford Road, Pertenhall MK44 2AL Bedford Bedfordshire | British | Company Director | 86707150003 | |||||
MARKS, Johanna Kesmin | Segretario | Tinkers Hoe Queens Road MK44 2LA Colmworth Bedfordshire | British | 86707150001 | ||||||
PRENTY, Kenneth James | Segretario | 4 Black Hat Close MK45 3HE Wilstead Bedfordshire | British | 20476800004 | ||||||
TINNER, Richard | Segretario | 6 Pearman Drive SG12 0LW Dane End Hertfordshire | British | 51011370001 | ||||||
TRYGGVASON, Asmunder | Segretario | Flat 4 Lancaster Gate W2 3NH London | Icelandic | Company Director | 120782700001 | |||||
BORNEO, Kenneth Allan | Amministratore | 26 Kimbolton Road MK40 2NR Bedford Bedfordshire | England | British | Solicitor | 51321580001 | ||||
DUBENS, Peter Adam Daiches | Amministratore | c/o C/O Oakley Capital Limited Cadogan Gate SW1X 0AS London 3 England | Switzerland | British | Company Director | 153016810001 | ||||
GETHING, Neil David | Amministratore | Owl End Willow Lane RG10 8LG Wargrave Berks | England | British | Company Director | 159025370001 | ||||
HILL, Simon John Crassweller | Amministratore | 7 Cortayne Road SW6 3QA London | United Kingdom | British | Company Director | 74099040002 | ||||
JOHANNESDOTTIR, Katrin Olga | Amministratore | Kvistaland 22 108 Reykjavik Kvistaland 22 Iceland | Icelandic | Director | 130129840001 | |||||
JONES, Jonathan Foster | Amministratore | Lucks Farm Barn Greenwoods Lane Punnetts Town TN21 9HU Heathfield East Sussex | England | British | Director | 12127750001 | ||||
KIRKWOOD, Gareth Robert | Amministratore | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire | England | British | Company Director | 174056480001 | ||||
MARKS, David Alex | Amministratore | Tinkers Hoe Queens Road Colmworth MK44 2LA Bedford Bedfordshire | United Kingdom | British | Engineering | 6143510001 | ||||
MARKS, Johanna Kesmin | Amministratore | Wood End House Bedford Road, Pertenhall MK44 2AL Bedford Bedfordshire | United Kingdom | British | Director | 86707150003 | ||||
MARKS, Johanna Kesmin | Amministratore | Wood End House Bedford Road, Pertenhall MK44 2AL Bedford Bedfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 86707150003 | ||||
PORISSON, Por Jes | Amministratore | 114 Langageroi Reykjavik 108 Iceland | Icelandic | Company Director | 124929830001 | |||||
RILEY, Anthony John | Amministratore | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire | England | British | Finance Director | 89230160001 | ||||
THOMPSON, Richard | Amministratore | The Walled Manor Hertingfordbury Park SG14 2LX Hertingfordbury Hertfordshire | England | British | Company Director | 88267960001 | ||||
THRAINSSON, Saevar Freyr | Amministratore | 25 Armuli Reykjavic 150 Iceland | Icelandic | Director | 120783310001 | |||||
TRYGGVASON, Asmunder | Amministratore | Flat 4 Lancaster Gate W2 3NH London | Icelandic | Company Director | 120782700001 |
AEROFONE (UK) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 22 gen 2010 Consegnato il 27 gen 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 26 set 2003 Consegnato il 15 ott 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 14 giu 2001 Consegnato il 23 giu 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge of deposit | Creato il 14 giu 2001 Consegnato il 22 giu 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or stanhope communications PLC to the chargee pursuant to any counter indemnity and all moneys now or at any time hereafter due | |
Brevi particolari The company charged with full title guarantee all its right, title and interest in and to the deposit. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge | Creato il 25 mar 1999 Consegnato il 26 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under or in relation to service provider agreements (as defined) in relation to subscribers or the subscriber base of the company or in relation to other agreements in writing related to such matters from time to time | |
Brevi particolari Fixed and floating charge on all goodwill and intellectual property rights of the company all book and other debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge | Creato il 14 apr 1993 Consegnato il 28 apr 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of the service provider agreement (as defined) | |
Brevi particolari The interest of the company in its customers.......all goodwill and the benefit of the service provider agreement.......see form 395. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge | Creato il 02 apr 1991 Consegnato il 09 apr 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the service provider agreement (as defined therein) and this charge | |
Brevi particolari The interest in the customers to telecommunication services provided and all goodwill, the benefit of all agreements. [See doc for details]. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0