AEROFONE (UK) LIMITED

AEROFONE (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAEROFONE (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02544334
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AEROFONE (UK) LIMITED?

    • Altre attività di telecomunicazioni (61900) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova AEROFONE (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Daisy House
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Lancashire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di AEROFONE (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per AEROFONE (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 28 mar 2013

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    Cessazione della carica di Gareth Robert Kirkwood come amministratore in data 12 apr 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Cessazione della carica di Peter Adam Daiches Dubens come amministratore in data 20 ott 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Alan Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Anthony Riley come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Gareth Robert Kirkwood come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    20 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter Adam Daiches Dubens il 04 nov 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 28 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Neil Gething come amministratore

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    46 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Enter into arrangements, entry into transaction. 03/06/2010
    RES13

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di AEROFONE (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCGLENNON, David Lewis
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    Segretario
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    149405880001
    RILEY, Matthew Robinson
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    Amministratore
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    United KingdomBritishChief Executive Officer178585250001
    SMITH, Stephen Alan
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    Amministratore
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director161471940001
    JONES, Jonathan Foster
    Lucks Farm Barn Greenwoods Lane
    Punnetts Town
    TN21 9HU Heathfield
    East Sussex
    Segretario
    Lucks Farm Barn Greenwoods Lane
    Punnetts Town
    TN21 9HU Heathfield
    East Sussex
    BritishDirector12127750001
    MARKS, David Alex
    Tinkers Hoe Queens Road
    Colmworth
    MK44 2LA Bedford
    Bedfordshire
    Segretario
    Tinkers Hoe Queens Road
    Colmworth
    MK44 2LA Bedford
    Bedfordshire
    BritishEngineer6143510001
    MARKS, David Alex
    Tinkers Hoe Queens Road
    Colmworth
    MK44 2LA Bedford
    Bedfordshire
    Segretario
    Tinkers Hoe Queens Road
    Colmworth
    MK44 2LA Bedford
    Bedfordshire
    BritishEngineer6143510001
    MARKS, Johanna Kesmin
    Wood End House
    Bedford Road, Pertenhall
    MK44 2AL Bedford
    Bedfordshire
    Segretario
    Wood End House
    Bedford Road, Pertenhall
    MK44 2AL Bedford
    Bedfordshire
    BritishCompany Director86707150003
    MARKS, Johanna Kesmin
    Wood End House
    Bedford Road, Pertenhall
    MK44 2AL Bedford
    Bedfordshire
    Segretario
    Wood End House
    Bedford Road, Pertenhall
    MK44 2AL Bedford
    Bedfordshire
    BritishCompany Director86707150003
    MARKS, Johanna Kesmin
    Tinkers Hoe
    Queens Road
    MK44 2LA Colmworth
    Bedfordshire
    Segretario
    Tinkers Hoe
    Queens Road
    MK44 2LA Colmworth
    Bedfordshire
    British86707150001
    PRENTY, Kenneth James
    4 Black Hat Close
    MK45 3HE Wilstead
    Bedfordshire
    Segretario
    4 Black Hat Close
    MK45 3HE Wilstead
    Bedfordshire
    British20476800004
    TINNER, Richard
    6 Pearman Drive
    SG12 0LW Dane End
    Hertfordshire
    Segretario
    6 Pearman Drive
    SG12 0LW Dane End
    Hertfordshire
    British51011370001
    TRYGGVASON, Asmunder
    Flat 4 Lancaster Gate
    W2 3NH London
    Segretario
    Flat 4 Lancaster Gate
    W2 3NH London
    IcelandicCompany Director120782700001
    BORNEO, Kenneth Allan
    26 Kimbolton Road
    MK40 2NR Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    26 Kimbolton Road
    MK40 2NR Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishSolicitor51321580001
    DUBENS, Peter Adam Daiches
    c/o C/O Oakley Capital Limited
    Cadogan Gate
    SW1X 0AS London
    3
    England
    Amministratore
    c/o C/O Oakley Capital Limited
    Cadogan Gate
    SW1X 0AS London
    3
    England
    SwitzerlandBritishCompany Director153016810001
    GETHING, Neil David
    Owl End
    Willow Lane
    RG10 8LG Wargrave
    Berks
    Amministratore
    Owl End
    Willow Lane
    RG10 8LG Wargrave
    Berks
    EnglandBritishCompany Director159025370001
    HILL, Simon John Crassweller
    7 Cortayne Road
    SW6 3QA London
    Amministratore
    7 Cortayne Road
    SW6 3QA London
    United KingdomBritishCompany Director74099040002
    JOHANNESDOTTIR, Katrin Olga
    Kvistaland 22
    108 Reykjavik
    Kvistaland 22
    Iceland
    Amministratore
    Kvistaland 22
    108 Reykjavik
    Kvistaland 22
    Iceland
    IcelandicDirector130129840001
    JONES, Jonathan Foster
    Lucks Farm Barn Greenwoods Lane
    Punnetts Town
    TN21 9HU Heathfield
    East Sussex
    Amministratore
    Lucks Farm Barn Greenwoods Lane
    Punnetts Town
    TN21 9HU Heathfield
    East Sussex
    EnglandBritishDirector12127750001
    KIRKWOOD, Gareth Robert
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    Amministratore
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director174056480001
    MARKS, David Alex
    Tinkers Hoe Queens Road
    Colmworth
    MK44 2LA Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    Tinkers Hoe Queens Road
    Colmworth
    MK44 2LA Bedford
    Bedfordshire
    United KingdomBritishEngineering6143510001
    MARKS, Johanna Kesmin
    Wood End House
    Bedford Road, Pertenhall
    MK44 2AL Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    Wood End House
    Bedford Road, Pertenhall
    MK44 2AL Bedford
    Bedfordshire
    United KingdomBritishDirector86707150003
    MARKS, Johanna Kesmin
    Wood End House
    Bedford Road, Pertenhall
    MK44 2AL Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    Wood End House
    Bedford Road, Pertenhall
    MK44 2AL Bedford
    Bedfordshire
    United KingdomBritishCompany Director86707150003
    PORISSON, Por Jes
    114 Langageroi
    Reykjavik
    108
    Iceland
    Amministratore
    114 Langageroi
    Reykjavik
    108
    Iceland
    IcelandicCompany Director124929830001
    RILEY, Anthony John
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    Amministratore
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    EnglandBritishFinance Director89230160001
    THOMPSON, Richard
    The Walled Manor
    Hertingfordbury Park
    SG14 2LX Hertingfordbury
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Walled Manor
    Hertingfordbury Park
    SG14 2LX Hertingfordbury
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director88267960001
    THRAINSSON, Saevar Freyr
    25 Armuli
    Reykjavic
    150
    Iceland
    Amministratore
    25 Armuli
    Reykjavic
    150
    Iceland
    IcelandicDirector120783310001
    TRYGGVASON, Asmunder
    Flat 4 Lancaster Gate
    W2 3NH London
    Amministratore
    Flat 4 Lancaster Gate
    W2 3NH London
    IcelandicCompany Director120782700001

    AEROFONE (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 22 gen 2010
    Consegnato il 27 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 09 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 26 set 2003
    Consegnato il 15 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Johanna Kesmin Marks
    Transazioni
    • 15 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 giu 2001
    Consegnato il 23 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 23 giu 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 23 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of deposit
    Creato il 14 giu 2001
    Consegnato il 22 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or stanhope communications PLC to the chargee pursuant to any counter indemnity and all moneys now or at any time hereafter due
    Brevi particolari
    The company charged with full title guarantee all its right, title and interest in and to the deposit.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 25 mar 1999
    Consegnato il 26 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in relation to service provider agreements (as defined) in relation to subscribers or the subscriber base of the company or in relation to other agreements in writing related to such matters from time to time
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge on all goodwill and intellectual property rights of the company all book and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Telecom Securicor Cellular Radio Limited
    Transazioni
    • 26 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of charge
    Creato il 14 apr 1993
    Consegnato il 28 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of the service provider agreement (as defined)
    Brevi particolari
    The interest of the company in its customers.......all goodwill and the benefit of the service provider agreement.......see form 395.
    Persone aventi diritto
    • Vodafone Limited
    Transazioni
    • 28 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of charge
    Creato il 02 apr 1991
    Consegnato il 09 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the service provider agreement (as defined therein) and this charge
    Brevi particolari
    The interest in the customers to telecommunication services provided and all goodwill, the benefit of all agreements. [See doc for details].
    Persone aventi diritto
    • Racal-Vodafone Limited
    Transazioni
    • 09 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0