OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED

OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02545971
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED?

    • (2222) /

    Dove si trova OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane
    N20 0YZ London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    VERTIS DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED28 dic 200028 dic 2000
    OLWEN DIRECT MAIL LIMITED13 nov 199013 nov 1990
    DRAMBURY LIMITED04 ott 199004 ott 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2004

    Quali sono le ultime deposizioni per OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 mag 2013

    5 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    4 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 mar 2013

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 set 2012

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 mar 2012

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 set 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 mar 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 set 2010

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 mar 2010

    5 pagine4.68

    Avviso di costituzione del Comitato di Liquidazione

    2 pagine4.48

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 set 2009

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 mar 2009

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 set 2008

    5 pagine4.68

    legacy

    1 pagine287

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 set 2008

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    7 pagine4.68

    Avviso di costituzione del Comitato di Liquidazione

    2 pagine4.48

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    8 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    8 pagine2.34B

    Risultato della riunione dei creditori

    35 pagine2.23B

    Certificato modificato di costituzione del comitato dei creditori

    1 pagine2.26B

    Dichiarazione delle attività

    11 pagine2.16B

    Chi sono gli amministratori di OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TAYLOR, Richard Scott
    The Stables Church Lane
    Dingley
    LE16 8PG Market Harborough
    Leicestershire
    Segretario
    The Stables Church Lane
    Dingley
    LE16 8PG Market Harborough
    Leicestershire
    British35333200002
    DIXON, Nicolas William
    3 Forster Road
    Holly Mount
    GU2 9AE Guildford
    Surrey
    Amministratore
    3 Forster Road
    Holly Mount
    GU2 9AE Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish24161370007
    TAYLOR, Richard Scott
    The Stables Church Lane
    Dingley
    LE16 8PG Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    The Stables Church Lane
    Dingley
    LE16 8PG Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish35333200002
    ANGELSON, Mark Alan
    876 Park Avenue
    Penthouse North
    10021 New York
    Usa
    Segretario
    876 Park Avenue
    Penthouse North
    10021 New York
    Usa
    Usa54679960003
    DRAKE, Ian Alexander
    1 Palace Green
    Addington
    CR0 9AJ Croydon
    Surrey
    Segretario
    1 Palace Green
    Addington
    CR0 9AJ Croydon
    Surrey
    British7119890002
    FISHER, Angus William Murray
    Coledown House
    Vicarage Lane, Curdridge
    S032 2DP Southampton
    Hants
    Segretario
    Coledown House
    Vicarage Lane, Curdridge
    S032 2DP Southampton
    Hants
    British122903010001
    FOOKES, Richard
    3 Hereford Drive
    Kings Ore
    CM7 9FX Braintree
    Essex
    Segretario
    3 Hereford Drive
    Kings Ore
    CM7 9FX Braintree
    Essex
    British81522540001
    HOWARD, John
    714 Avila Drive
    Davidsonville
    Maryland 21035
    America
    Segretario
    714 Avila Drive
    Davidsonville
    Maryland 21035
    America
    American107278560001
    STEEL, Angus Kennedy
    Brewery Cottage
    Brockhampton
    GL54 5XQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    Brewery Cottage
    Brockhampton
    GL54 5XQ Cheltenham
    Gloucestershire
    British62259790003
    ANGELSON, Mark Alan
    876 Park Avenue
    Penthouse North
    10021 New York
    Usa
    Amministratore
    876 Park Avenue
    Penthouse North
    10021 New York
    Usa
    Usa54679960003
    BULL, Dianne
    37 Copthorne Road
    KT22 7ED Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    37 Copthorne Road
    KT22 7ED Leatherhead
    Surrey
    British25261110001
    COLLINS, John Patrick
    6 Gorse Cottages
    Hammer Lane Bramshott Chase
    GU26 6DD Hindhead
    Surrey
    Amministratore
    6 Gorse Cottages
    Hammer Lane Bramshott Chase
    GU26 6DD Hindhead
    Surrey
    United KingdomBritish26864100001
    CROFT, Peter
    2 Edgewood Green
    Shirley
    CR0 7PT Croydon
    Amministratore
    2 Edgewood Green
    Shirley
    CR0 7PT Croydon
    United KingdomBritish36010140002
    DRAKE, Ian Alexander
    1 Palace Green
    Addington
    CR0 9AJ Croydon
    Surrey
    Amministratore
    1 Palace Green
    Addington
    CR0 9AJ Croydon
    Surrey
    British7119890002
    DURBIN, Dean
    19001 Windsor Forest Road
    Mount Airy
    Maryland 21771
    Usa
    Amministratore
    19001 Windsor Forest Road
    Mount Airy
    Maryland 21771
    Usa
    American81110710001
    EPPS, Gillian Margaret
    1a Hill Road
    CR4 2HS Mitcham
    Surrey
    Amministratore
    1a Hill Road
    CR4 2HS Mitcham
    Surrey
    British23569370001
    FISHER, Angus William Murray
    Coledown House
    Vicarage Lane, Curdridge
    S032 2DP Southampton
    Hants
    Amministratore
    Coledown House
    Vicarage Lane, Curdridge
    S032 2DP Southampton
    Hants
    United KingdomBritish122903010001
    FLANNERY, Christopher James
    2809 Boston Street
    Appartment 409
    IRISH Baltimore
    Usa
    Amministratore
    2809 Boston Street
    Appartment 409
    IRISH Baltimore
    Usa
    British30670590004
    FOOKES, Richard
    3 Hereford Drive
    Kings Ore
    CM7 9FX Braintree
    Essex
    Amministratore
    3 Hereford Drive
    Kings Ore
    CM7 9FX Braintree
    Essex
    British81522540001
    GAMBER, Mark Francis
    Erskine Cottage
    Garden Close Givons Grove
    KT22 8LU Leatherhead
    10
    Surrey
    Amministratore
    Erskine Cottage
    Garden Close Givons Grove
    KT22 8LU Leatherhead
    10
    Surrey
    British51105690002
    HEALY, Scott
    7 Mount Pleasant
    MK17 9EX Stoke Hammond
    Buckinghamshire
    Amministratore
    7 Mount Pleasant
    MK17 9EX Stoke Hammond
    Buckinghamshire
    British79690160001
    HINDLEY, Martyn John
    Upper Wield
    SO24 9RT Arlesford
    The Barn
    Hampshire
    Amministratore
    Upper Wield
    SO24 9RT Arlesford
    The Barn
    Hampshire
    EnglandBritish134332760001
    HOLMES, Matthew Willis
    Flat 2 19 Cleveland Road
    Barnes
    SW13 0AA London
    Amministratore
    Flat 2 19 Cleveland Road
    Barnes
    SW13 0AA London
    British43176290001
    LAYBOURNE, David Andrew
    9 Regency Mews
    BR3 2FG Beckenham
    Kent
    Amministratore
    9 Regency Mews
    BR3 2FG Beckenham
    Kent
    British30670600001
    MARTINDALE, Peter
    Exeter Mansions
    106 Shaftesbury Avenue
    W1D 5EQ London
    Amministratore
    Exeter Mansions
    106 Shaftesbury Avenue
    W1D 5EQ London
    British109116080001
    PONCIA, Kevin Peter
    23 Gibraltar Rise
    TN21 8HL Heathfield
    East Sussex
    Amministratore
    23 Gibraltar Rise
    TN21 8HL Heathfield
    East Sussex
    British39046370001
    REILLY, Edward Thomas
    62 North Sylvan Road
    06880 Westport
    Connecticut
    Usa
    Amministratore
    62 North Sylvan Road
    06880 Westport
    Connecticut
    Usa
    Usa62916050001
    RIVETT, Peter Christopher
    Motte Place Walton Manor
    Walton Street
    KT20 7SA Walton On The Hill
    Surrey
    Amministratore
    Motte Place Walton Manor
    Walton Street
    KT20 7SA Walton On The Hill
    Surrey
    United KingdomBritish105827610001
    ROLAND, Donald Edward
    4 Norwood Road
    Annapolis
    Maryland 21401
    Usa
    Amministratore
    4 Norwood Road
    Annapolis
    Maryland 21401
    Usa
    American71621920001
    ROOSEN, Adriaan Henri Dominique Marie
    Stationsweg 26
    Oosterbeek
    6861 Eh
    Netherlands
    Amministratore
    Stationsweg 26
    Oosterbeek
    6861 Eh
    Netherlands
    Dutch74228750001
    RUDDLE, Andrew Daniel
    The Barn Sunt Farm
    Caterfield Lane Staffhurst Wood
    RH9 ORR Oxted
    Surrey
    Amministratore
    The Barn Sunt Farm
    Caterfield Lane Staffhurst Wood
    RH9 ORR Oxted
    Surrey
    British20560270002
    SHERWIN, Theodore Daniel
    338 The Great Road
    Princeton
    FOREIGN Usa Nj 08540
    Amministratore
    338 The Great Road
    Princeton
    FOREIGN Usa Nj 08540
    Usa62915610001
    STEEL, Angus Kennedy
    Brewery Cottage
    Brockhampton
    GL54 5XQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Brewery Cottage
    Brockhampton
    GL54 5XQ Cheltenham
    Gloucestershire
    British62259790003

    OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 25 ott 2005
    Consegnato il 26 ott 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All property assets business undertaking and rights fixed or floating including mortgaged property plant and machinery property rights debts trusts accounts securities intellectual property goodwill contracts insolvency act realisations vat recoveries cash and stock-in-trade.
    Persone aventi diritto
    • Enterprise Finance Europe (UK) Limited
    Transazioni
    • 26 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 07 giu 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Debenture
    Creato il 22 dic 2004
    Consegnato il 11 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other credit party to the chargee or any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its right, title and interest in and to each of the following assets; th properties and all related rights; the debts; the equipment; the intellectual property; all present and future goodwill and all rights in relation to the uncalled capital of the company; the investments; floating charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • General Electric Capital Corporation (For Itself and as Agent for the Lenders) (the Agent)
    Transazioni
    • 11 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 gen 2000
    Consegnato il 18 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys and liabilities due or to become due from any chargor to the chargees under or in connection with a). The credit agreement b). Any other credit document to which the chargor is party from time to time and c). The debenture
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank (The "Collateral Agent")
    Transazioni
    • 18 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 19 nov 1996
    Consegnato il 03 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 mag 1995
    Consegnato il 27 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 27 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 10 mag 1991
    Consegnato il 17 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 26 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 mag 2006Inizio dell'amministrazione
    18 set 2006Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Barry David Lewis
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    N20 0YZ 310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London
    Praticante
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    N20 0YZ 310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London
    Freddy Khalastchi
    Harris Lipman Llp 2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane, Whetstone
    N20 0YZ London
    Praticante
    Harris Lipman Llp 2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane, Whetstone
    N20 0YZ London
    2
    DataTipo
    18 set 2006Inizio della liquidazione
    12 set 2013Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Freddy Khalastchi
    Harris Lipman Llp 2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane, Whetstone
    N20 0YZ London
    Praticante
    Harris Lipman Llp 2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane, Whetstone
    N20 0YZ London
    Freddy Khalastchi
    Harris Lipman Llp 2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane, Whetstone
    N20 0YZ London
    Praticante
    Harris Lipman Llp 2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane, Whetstone
    N20 0YZ London
    Barry David Lewis
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    N20 0YZ 310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London
    Praticante
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    N20 0YZ 310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London
    Barry David Lewis
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    N20 0YZ 310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London
    Praticante
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    N20 0YZ 310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0