CAPITA RUDDLE WILKINSON LIMITED

CAPITA RUDDLE WILKINSON LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCAPITA RUDDLE WILKINSON LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02546607
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CAPITA RUDDLE WILKINSON LIMITED?

    • Altre attività di ingegneria (71129) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CAPITA RUDDLE WILKINSON LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Registry
    34 Beckenham Road
    BR3 4TU Beckenham
    Kent
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CAPITA RUDDLE WILKINSON LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RUDDLE WILKINSON LIMITED26 nov 199026 nov 1990
    BUYEARN LIMITED08 ott 199008 ott 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di CAPITA RUDDLE WILKINSON LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CAPITA RUDDLE WILKINSON LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CAPITA RUDDLE WILKINSON LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 lug 2013

    Stato del capitale al 25 lug 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    Cessazione della carica di Timothy Jennings come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Clare Elizabeth Waters come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 17 Rochester Row Westminster London SW1P 1QT England

    1 pagineAD02

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    4 pagineAUD

    Stato del capitale al 19 nov 2010

    • Capitale: GBP 2
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    legacy

    2 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share prem/cap cont to nil 05/11/2010
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Capita Corporate Director Limited il 01 ott 2009

    1 pagineCH02

    Dettagli del segretario cambiati per Capita Group Secretary Limited il 01 ott 2009

    1 pagineCH04

    Chi sono gli amministratori di CAPITA RUDDLE WILKINSON LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CAPITA GROUP SECRETARY LIMITED
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Segretario
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2376959
    138426340001
    WATERS, Clare Elizabeth
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish66300280003
    CAPITA CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    Amministratore
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione5641516
    129795770003
    DURANCE, John William Frederick
    20 Westwood Park Road
    PE3 6JL Peterborough
    Cambridgeshire
    Segretario
    20 Westwood Park Road
    PE3 6JL Peterborough
    Cambridgeshire
    British22122990001
    CAPITA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    The Registry
    34 Beckenham Road
    BR3 4TU Beckenham
    Kent
    Segretario
    The Registry
    34 Beckenham Road
    BR3 4TU Beckenham
    Kent
    102944500001
    DEVINE, Clare Mary
    19 Linden Mews
    Mildway Grove North Islington
    N1 4RJ London
    Amministratore
    19 Linden Mews
    Mildway Grove North Islington
    N1 4RJ London
    British91720920001
    DURANCE, John William Frederick
    20 Westwood Park Road
    PE3 6JL Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    20 Westwood Park Road
    PE3 6JL Peterborough
    Cambridgeshire
    British22122990001
    FRANKLIN, Mervyn John
    The Manor House
    Main Road Tallington
    PE9 4RP Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    The Manor House
    Main Road Tallington
    PE9 4RP Stamford
    Lincolnshire
    United KingdomBritish159324130002
    JENNINGS, Timothy
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish149372130001
    MACKRILL, Robert John
    110 Lonsdale Road
    PE9 2SF Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    110 Lonsdale Road
    PE9 2SF Stamford
    Lincolnshire
    British22123000001
    MCKELVAY, Vivian
    9 Vale Court
    CF71 7ES Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    Amministratore
    9 Vale Court
    CF71 7ES Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    British57457670002
    ROBINSON, Derek Alan
    The Granary Stowe Farm
    Langtoft
    PE6 9SF Peterborough
    Lincolnshire
    Amministratore
    The Granary Stowe Farm
    Langtoft
    PE6 9SF Peterborough
    Lincolnshire
    EnglandBritish104466930001
    SCALLY, Brian
    30 Hawthorne Road
    Stapleford
    CB2 5DU Cambridge
    Amministratore
    30 Hawthorne Road
    Stapleford
    CB2 5DU Cambridge
    British2261970002
    TAYLOR, Edmund Hugh Anthony
    Pye End Main Road
    Tallington
    PE9 4RP Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    Pye End Main Road
    Tallington
    PE9 4RP Stamford
    Lincolnshire
    British22123010001
    TAYLOR, Norman Basil
    49 West Delph
    Whittlesey
    PE7 1RD Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    49 West Delph
    Whittlesey
    PE7 1RD Peterborough
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish168392150001
    TURNOCK, David Michael
    183 Broadway
    PE1 4DS Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    183 Broadway
    PE1 4DS Peterborough
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish22123030001
    WOLFE, Mark Gavin
    16 Stokenchurch Street
    Fulham
    SW6 3TR London
    Amministratore
    16 Stokenchurch Street
    Fulham
    SW6 3TR London
    British111969600001

    CAPITA RUDDLE WILKINSON LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 06 mag 2005
    Consegnato il 17 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 84 lincoln road peterborough cambidgeshire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 apr 2005
    Consegnato il 09 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 09 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 giu 1999
    Consegnato il 08 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 giu 1999
    Consegnato il 07 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    84 lincoln road peterborough city of peterborough t/n CB132856.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 giu 1999
    Consegnato il 17 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Edmund Hugh Anthony Taylor
    Transazioni
    • 17 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 giu 1999
    Consegnato il 17 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mervyn John Franklin
    Transazioni
    • 17 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 giu 1993
    Consegnato il 22 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 84 lincoln road, peterborough, cambridgeshire t/no: cb 132856 (including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • N. Taylor
    Transazioni
    • 22 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 giu 1993
    Consegnato il 22 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 84 lincoln road, peterborough, cambridgeshire t/no: cb 132856 (including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • J.W.F. Durance
    Transazioni
    • 22 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 giu 1993
    Consegnato il 22 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 84 lincoln road, peterborough, cambridgeshire t/no: cb 132856 (including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • D.M. Turnock
    Transazioni
    • 22 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 giu 1993
    Consegnato il 22 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 84 lincoln road, peterborough, cambridgeshire t/no: cb 132856 (including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • R.J. Mackrill
    Transazioni
    • 22 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 18 feb 1991
    Consegnato il 05 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 84 lincoln road peterborough cambridgeshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 18 feb 1991
    Consegnato il 02 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 02 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 17 lug 1993Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 17 lug 1993Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 26 gen 1994Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 26 gen 1994Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 16 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge dated 6.4.87 and further legal charge dated 30.6.89
    Creato il 06 apr 1987
    Acquisito il 18 feb 1991
    Consegnato il 02 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £519,146.08
    Brevi particolari
    F/H property k/a 84 lincoln road peterborough cambridgeshire.
    Persone aventi diritto
    • Norwich and Peterborough Building Society
    Transazioni
    • 02 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0