SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD GUARANTEECO LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD GUARANTEECO LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale |
| Numero di società | 02547272 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD GUARANTEECO LIMITED?
- Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione
Dove si trova SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD GUARANTEECO LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Portland House Bressenden Place SW1E 5BH London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD GUARANTEECO LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD LIMITED | 21 gen 1991 | 21 gen 1991 |
| RUGMARKET LIMITED | 10 ott 1990 | 10 ott 1990 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD GUARANTEECO LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Quali sono le ultime deposizioni per SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD GUARANTEECO LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Cristian Zaefferer come amministratore in data 01 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Jerome Arnaud Tourbier come amministratore in data 01 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Gertrud Schneider come amministratore in data 01 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Richard Thomas Widman come amministratore in data 01 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Pauline Tew come amministratore in data 01 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Paolo Morra come amministratore in data 01 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Ankur Rara come amministratore in data 01 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Samir Saab come amministratore in data 01 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Anchalika Kijkanakorn come amministratore in data 01 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Patrick Whitehead Burke come amministratore in data 01 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Rafael Bejerano come amministratore in data 09 feb 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 31 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 ott 2015, non è stata fornita alcuna lista dei soci | 12 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 17 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Panos Paleologos come amministratore in data 31 lug 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Ms Ankur Rara come amministratore in data 10 feb 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Ankur Rara come amministratore in data 10 feb 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Ms Ankur Rara come amministratore in data 10 feb 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 ott 2014, non è stata fornita alcuna lista dei soci | 12 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Nawalage Joseph Nahinda Cooray come amministratore in data 01 ago 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 16 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD GUARANTEECO LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEJERANO, Rafael | Amministratore | Bressenden Place SW1E 5BH London Portland House | England | British | 207441960001 | |||||||||
| MUEHLE, Henrik | Amministratore | c/o St Jame's Hotel & Club Park Place SW1A 1LS London 7-8 England | England | German | 182150070001 | |||||||||
| COLE, Christopher Andrew | Segretario | Luckham Park Colerne SN14 8AZ Wiltshire | British | 38644200002 | ||||||||||
| KERR, Paul Jonathan | Segretario | Deblins Green The Village, Ewhurst GU6 7PB Cranleigh Surrey | British | 16685470005 | ||||||||||
| JORDAN COMPANY SECRETARIES LIMITED | Segretario | - 22 Bedford Row WC1R 4JS London 20 United Kingdom |
| 97584300001 | ||||||||||
| JORDAN COMPANY SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon | 900008790001 | |||||||||||
| BEGHIN, Jean Philippe | Amministratore | The Windsor 103 Spring Street Melbourne Victoria 3000 Australia | Australian | 44944480001 | ||||||||||
| BRENNAN, Francis Martin | Amministratore | Park Hotel Kenmare Kenmare Kerry Ireland | Irish | 42401060001 | ||||||||||
| BURKE, Patrick Whitehead | Amministratore | Le Mont De La Pulente JE3 8HE St Brelade The Atlantic Hotel Channel Islands Jersey | Channel Islands | British | 171729020001 | |||||||||
| BURKE, Patrick Whitehead | Amministratore | Chanson De La Mer La Route De Letacq, St. Ouen JE3 2FB Jersey Channel Islands | Channel Islands | British | 171729020001 | |||||||||
| BYRNE, Andrew | Amministratore | 3 Lavington Stables Vandyke Close Putney Heath Lane SW15 3JH London | British | 45468800001 | ||||||||||
| COLE, Christopher Andrew | Amministratore | Luckham Park Colerne SN14 8AZ Wiltshire | British | 38644200002 | ||||||||||
| COORAY, Nawalage Joseph Nahinda | Amministratore | Lake Gardens Rajagiriya 233/12 Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lankan | 132239100001 | |||||||||
| COPE, John Joseph | Amministratore | 1075 California Street San Francisco California 94108 Usa | Usa | Us Citizen | 21693670001 | |||||||||
| CRAWFORD, Henry | Amministratore | 1 Ulster Street 2021 Paddington New South Wales Australia | Australian | 47036830001 | ||||||||||
| DICKER, Thomas | Amministratore | 20 Launceston Place W8 5RL London | German | 70155230001 | ||||||||||
| ELLIS, Christopher Grant | Amministratore | 14 Ferntree Drive Wakari Dunedin Otago FOREIGN New Zealand | New Zealander | 45316150001 | ||||||||||
| ERNI, Fritz | Amministratore | Meggenhornstrasse 19 Meggen 6045 Switzerland | Switzerland | Swiss-Canadian | 113551460001 | |||||||||
| FAIRLEY, Andrew Edwin John | Amministratore | 224 Kooyong Road Toorak 3151 Victoria Australia | Australian | 91828780002 | ||||||||||
| GARCIA, Felix | Amministratore | Plaza De Las Cortez 10 FOREIGN Madrid 28014 Spain | Spain | Spanish | 113551380001 | |||||||||
| GEBBIE, Morton Ross | Amministratore | Okiato Lodge Russell FOREIGN New Zealand | New Zealander | 45006720001 | ||||||||||
| GILBERT, Irondelle | Amministratore | Hotel Imperial Garoupe 770 Chenin De Garoupe Le Cap D'Antibes 06600 France | French | 59008110001 | ||||||||||
| GORING, Jeremy Christopher Richard | Amministratore | 13 Loxley Road Wandsworth SW18 3LL London | United Kingdom | British | 66519750005 | |||||||||
| GROSS, Carl Friedrich Otto | Amministratore | Am Huegel 22 D-66123 Saarbrucken Germany | German | 76697460001 | ||||||||||
| HOLMES, Terence Roy | Amministratore | 113 Salcott Road Battersea SW11 6DE London | British | 48237880004 | ||||||||||
| HUMES, Kenneth B | Amministratore | The Peaks At Telluride 136 Country Club Drive Telluride Colorado 81435 Usa | American | 39805130002 | ||||||||||
| ISUN, Rafael | Amministratore | Avinguda De Roma 130 At 2a Barcelona 08015 Spain | Spanish | 91158680001 | ||||||||||
| JENKINS, Philip Moore | Amministratore | Blanket Bay Glenorchy New Zealand | New Zealand | New Zealand British | 67301920001 | |||||||||
| JENKINS, Philip Poore | Amministratore | Wharekauhau Western Lake Road Palliser Bay Featherston New Zealand | British/New Zealander | 59008250001 | ||||||||||
| KALACH, Jose | Amministratore | Paseo De La Reforma 465 Col Cuauhtemoc 06500 Mexico | Mexican | 39658330001 | ||||||||||
| KERR, Paul Jonathan | Amministratore | 30 Dabernon Drive Stoke Dabernon KT11 3JD Cobham Surrey | British | 16685470001 | ||||||||||
| KIJKANAKORN, Anchalika | Amministratore | Lardprao Soi 95 Wangthonglang Bangkok 3 10310 Thailand | Thailand | Thai | 132239190001 | |||||||||
| LANDRY, Michael Gerard | Amministratore | 211 South Gordon Road 33301 Fort Lauderdale Florida | Usa | Canadian | 99616200001 | |||||||||
| MILLS, Brian Dudley Beynon | Amministratore | Fairways Fielden Road TN6 1TS Crowborough East Sussex | British | 36502780001 | ||||||||||
| MORRA, Paolo | Amministratore | c/o Hotel Centurian Palace Dorsoduro 30123 Venezia 173 Italy | Italy | Italian | 182149880001 |
SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD GUARANTEECO LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Creato il 01 giu 1999 Consegnato il 08 giu 1999 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent memorandum under seal | Creato il 17 dic 1991 Consegnato il 07 gen 1992 | In corso | Importo garantito £11,309.37 | |
Brevi particolari £11,309.37 and such further sums as may be required to ensure that the total sum or sums standing to the credit of such account is at all times equal to 50% of the yearly rent and the value added tax thereon reserved by the lease of unit 17 (postal unit 24) the blades deodar road putney london SW15. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0