QUEEN STREET NOMINEES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | QUEEN STREET NOMINEES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02549605 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di QUEEN STREET NOMINEES LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova QUEEN STREET NOMINEES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 8b Ennismore Gardens SW7 1NL London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di QUEEN STREET NOMINEES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| EX ELMBRIDGE HOLDINGS LIMITED | 27 set 1999 | 27 set 1999 |
| ELMBRIDGE HOLDINGS LIMITED | 18 apr 1991 | 18 apr 1991 |
| 131ST SHELF INVESTMENT COMPANY LIMITED | 18 ott 1990 | 18 ott 1990 |
Quali sono gli ultimi bilanci di QUEEN STREET NOMINEES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per QUEEN STREET NOMINEES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2011 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Anthony Francesco Lorenzo Amhurst come segretario in data 31 gen 2010 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 ott 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2010 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 8 Queen Street London W1J 5PD in data 22 feb 2011 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 ott 2010 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2009 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di un segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anthony Amhurst come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 ott 2009 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2008 | 6 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2007 | 6 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2006 | 7 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2005 | 4 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di QUEEN STREET NOMINEES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN, Raymond Alan | Amministratore | 8b Ennismore Gardens SW7 1NL London | United Kingdom | British | 117460770001 | |||||
| AMHURST, Anthony Francesco Lorenzo | Segretario | La Marjolaine Route De Tahiti FOREIGN Ramatuelle 83350 France | British | 80376940002 | ||||||
| RAND, Peter John | Segretario | 61 Kingswood Road KT20 5EF Tadworth Surrey | British | 33722020001 | ||||||
| M & N SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 118 London Road KT2 6QJ Kingston Upon Thames The Quadrant Surrey | 900001060001 | |||||||
| AMHURST, Anthony Francesco Lorenzo | Amministratore | La Marjolaine Route De Tahiti FOREIGN Ramatuelle 83350 France | British | 80376940002 | ||||||
| GAIR, William Cortis | Amministratore | Russell Court 60 Russell Hill Road CR8 2LB Purley Surrey | United Kingdom | British | 35531770001 | |||||
| JACKSON, Michael Edward Wilson | Amministratore | 2 Castello Avenue Putney SW15 6EA London | United Kingdom | British | 40521530001 | |||||
| LOWERY, Robert Johnson | Amministratore | 1 Devonshire Gardens Grove Park Chiswick W4 3TW London | British | 10629590001 | ||||||
| RAND, Peter John | Amministratore | 61 Kingswood Road KT20 5EF Tadworth Surrey | Uk | British | 33722020001 |
QUEEN STREET NOMINEES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental deed | Creato il 11 mar 1997 Consegnato il 25 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein supplemental to a composite guarantee and mortgage debenture dated 17TH february 1992 | |
Brevi particolari All the company's right title and interest in and to 10,000 ordinary shares of elmbridge limited and dividends payable thereto. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 03 giu 1994 Consegnato il 15 giu 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the investment agreement (as defined) on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and mortgage debenture | Creato il 17 feb 1992 Consegnato il 19 feb 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or in connection with the facility agreement, the counter indemnity and/or this deed | |
Brevi particolari See doc ref M553C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 15 mar 1991 Consegnato il 25 mar 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 15 mar 1991 Consegnato il 25 mar 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company (as agent and trustee for the lender) or the lenders on any account whatsoever. | |
Brevi particolari (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0