EAGLE PRESS HOLDINGS LIMITED

EAGLE PRESS HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEAGLE PRESS HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02549638
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EAGLE PRESS HOLDINGS LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova EAGLE PRESS HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EAGLE PRESS HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    627TH SHELF TRADING COMPANY LIMITED18 ott 199018 ott 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di EAGLE PRESS HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per EAGLE PRESS HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Risoluzione di insolvenza

    Resolution insolvency:- re. Books & accounts
    1 pagineLIQ MISC RES

    Indirizzo della sede legale modificato da Windlebrook House Guildford Road Bagshot Surrey GU19 5NG in data 01 mar 2010

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 15 feb 2010

    LRESSP

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2009

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 feb 2010

    Stato del capitale al 04 feb 2010

    • Capitale: GBP 1,071.04
    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Bilancio redatto al 30 set 2008

    8 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2007

    8 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 30 set 2006

    8 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 30 set 2005

    8 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di EAGLE PRESS HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LOVELL, David Thomas
    59 Gabriels Square
    Lower Earley
    RG6 3WN Reading
    Segretario
    59 Gabriels Square
    Lower Earley
    RG6 3WN Reading
    British100714080002
    LOVELL, David Thomas
    59 Gabriels Square
    Lower Earley
    RG6 3WN Reading
    Amministratore
    59 Gabriels Square
    Lower Earley
    RG6 3WN Reading
    EnglandBritish100714080002
    TAVIANSKY, Leon
    14 Pinehurst
    SL5 0TN Sunninghill
    Berkshire
    Amministratore
    14 Pinehurst
    SL5 0TN Sunninghill
    Berkshire
    United KingdomBritish99965810001
    BRUCE, Charles Alexander
    8 Prior Croft Close
    GU15 5DE Camberley
    Surrey
    Segretario
    8 Prior Croft Close
    GU15 5DE Camberley
    Surrey
    British3767870002
    HANNA, Roisin
    180 Holywell
    Upper Kilmacud Road
    Dublin 14
    Dublin
    Ireland
    Segretario
    180 Holywell
    Upper Kilmacud Road
    Dublin 14
    Dublin
    Ireland
    British44105690001
    ALLEN, Eamon Joseph
    Grenagh
    Avoca Avenue
    Blackrock
    County Dublin
    Ireland
    Amministratore
    Grenagh
    Avoca Avenue
    Blackrock
    County Dublin
    Ireland
    Irish33780080001
    BRUCE, Charles Alexander
    8 Prior Croft Close
    GU15 5DE Camberley
    Surrey
    Amministratore
    8 Prior Croft Close
    GU15 5DE Camberley
    Surrey
    British3767870002
    FEY, Anthony John
    Summer Meadow The Green
    Shamley Green
    GU5 0UA Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Summer Meadow The Green
    Shamley Green
    GU5 0UA Guildford
    Surrey
    EnglandBritish6267430002
    MANIFOLD, Albert Jude
    Spynans House
    Kiltegan
    County Wicklow
    Ireland
    Amministratore
    Spynans House
    Kiltegan
    County Wicklow
    Ireland
    IrelandIrish264302310001
    MARKEY, John
    25 Tollway
    Sherfield Park Chinham
    RG24 8RJ Basingstoke
    Hants
    Amministratore
    25 Tollway
    Sherfield Park Chinham
    RG24 8RJ Basingstoke
    Hants
    British33032500001
    MCGUIRE, Vivian Francis
    12 Knocknacree Park
    Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    Amministratore
    12 Knocknacree Park
    Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    Irish30974070001
    MONKS, John Andrew
    30 Fairlawn Park
    Kettlewell Hill
    GU21 4HT Woking
    Surrey
    Amministratore
    30 Fairlawn Park
    Kettlewell Hill
    GU21 4HT Woking
    Surrey
    United KingdomBritish219360003
    POMFRET, John William
    53a Woodham Park Road
    Woodham
    KT15 3TN Addlestone
    Edgefield
    Surrey
    Amministratore
    53a Woodham Park Road
    Woodham
    KT15 3TN Addlestone
    Edgefield
    Surrey
    EnglandBritish135129630001
    WAKLEY, Richard Paul
    33 Western Road
    Hiltingbury
    SO53 5DG Chandlers Ford
    Hampshire
    Amministratore
    33 Western Road
    Hiltingbury
    SO53 5DG Chandlers Ford
    Hampshire
    United KingdomBritish64172380004

    EAGLE PRESS HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and debenture
    Creato il 26 ago 1992
    Consegnato il 16 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of theother companies named therein to the chargee under the terms of the facilities agreement dated 26TH august 1992 and the security documents (as defined)
    Brevi particolari
    See form 395 ref M77. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 30 nov 1990
    Consegnato il 05 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the beneficiaries, under the terms of the senior facility agreement dated 30.11.90 the mezzaning loan agreement the interest rate hedging agreements and an overdraft facility, and all monies due or to become due from the S.K. fly & son limited to the chargee as trustee for the beneficiaries, under the terms of the senior facility agreement dated 30-11-90, the interest rate hedging agreements and an overdraft facility.
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a riverdene industrial estate, hersham, surrey. Title nos: sy 433369, sy 585271 and sy 548866, and/or the proceeds of sale thereof. Including buildings and fixtures. (See form 395 for full details).. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC.
    Transazioni
    • 05 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 01 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    EAGLE PRESS HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 ago 2010Data di scioglimento
    15 feb 2010Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Christopher Richard Frederick Day
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Nicholas Guy Edwards
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0