HAVEN HEALTHCARE (DEVELOPMENTS) LIMITED

HAVEN HEALTHCARE (DEVELOPMENTS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHAVEN HEALTHCARE (DEVELOPMENTS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02549996
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HAVEN HEALTHCARE (DEVELOPMENTS) LIMITED?

    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova HAVEN HEALTHCARE (DEVELOPMENTS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HAVEN HEALTHCARE (DEVELOPMENTS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MOBILITY PLUS LIMITED03 mag 199103 mag 1991
    REASONACTION LIMITED18 ott 199018 ott 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di HAVEN HEALTHCARE (DEVELOPMENTS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per HAVEN HEALTHCARE (DEVELOPMENTS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 30 set 2011

    12 pagineAA

    Cessazione della carica di Joanne Moore come amministratore in data 28 mar 2012

    1 pagineTM01

    Nomina di Angela Culhane come amministratore in data 28 mar 2012

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 18 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 nov 2011

    Stato del capitale al 02 nov 2011

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Nomina di Toby James Bailey Siddall come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Helen Owens come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Joanne Moore come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Michael Robert Parish il 10 ago 2010

    2 pagineCH01

    legacy

    3 pagineMG02

    Risoluzioni

    Resolutions
    12 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    12 pagineMG01

    legacy

    28 pagineMG01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio redatto al 30 set 2009

    12 pagineAA

    Cessazione della carica di Douglas Umbers come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Helen Anne Owens come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Anthony Hosking come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 18 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Care Uk Services Ltd il 01 ott 2009

    2 pagineCH04

    Chi sono gli amministratori di HAVEN HEALTHCARE (DEVELOPMENTS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CARE UK SERVICES LTD
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Segretario
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2482660
    125241530002
    CULHANE, Angela
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Amministratore
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    EnglandBritish68602910001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Amministratore
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    United KingdomBritish33223550003
    PARISH, Michael Robert
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Amministratore
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    EnglandBritish78828750003
    SIDDALL, Toby James Bailey
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Amministratore
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    United KingdomBritish159561400001
    BRYANT, James Richard Stansfeld
    Drapers Farmhouse
    Rushden
    SG9 0TB Buntingford
    Hertfordshire
    Segretario
    Drapers Farmhouse
    Rushden
    SG9 0TB Buntingford
    Hertfordshire
    British7897550001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    Segretario
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    British33223550003
    BOOKER, Roger Ian
    4 Southgate Gardens
    Long Melford
    CO10 9HB Sudbury
    Suffolk
    Amministratore
    4 Southgate Gardens
    Long Melford
    CO10 9HB Sudbury
    Suffolk
    British14044530002
    BRYANT, James Richard Stansfeld
    Drapers Farmhouse
    Rushden
    SG9 0TB Buntingford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Drapers Farmhouse
    Rushden
    SG9 0TB Buntingford
    Hertfordshire
    EnglandBritish7897550001
    CLOUGH, Richard Stanley
    Hanini 50 Second Avenue
    CO13 9LX Frinton On Sea
    Essex
    Amministratore
    Hanini 50 Second Avenue
    CO13 9LX Frinton On Sea
    Essex
    EnglandBritish7897560001
    COCHRANE, Gordon Douglas
    42 Richardson Road
    East Bergholt
    CO7 6RR Colchester
    Essex
    Amministratore
    42 Richardson Road
    East Bergholt
    CO7 6RR Colchester
    Essex
    EnglandBritish66110000001
    GEE, David Louis
    Bramble Gardens
    RH15 8UQ Burgess Hill
    8
    West Sussex
    Amministratore
    Bramble Gardens
    RH15 8UQ Burgess Hill
    8
    West Sussex
    United KingdomBritish26269060002
    HOSKING, Anthony Alistair Mark
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Amministratore
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    United KingdomBritish77527970005
    KENNEY, Stephen
    Hart House Sherbourne Street
    Edwardstone
    CO10 5PD Colchester
    Essex
    Amministratore
    Hart House Sherbourne Street
    Edwardstone
    CO10 5PD Colchester
    Essex
    British30516930002
    LOMER, Graham Charles
    3 Coppice End
    CO4 9RQ Colchester
    Essex
    Amministratore
    3 Coppice End
    CO4 9RQ Colchester
    Essex
    British96916290001
    MOORE, Joanne
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Amministratore
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    EnglandBritish178426390001
    OWENS, Helen Anne
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Amministratore
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    United KingdomBritish119584650001
    UMBERS, Douglas
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Amministratore
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    United KingdomBritish90541690001

    HAVEN HEALTHCARE (DEVELOPMENTS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 21 lug 2010
    Consegnato il 26 lug 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank Nv, London Branch (As Security Agent)
    Transazioni
    • 26 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    The supplemental legal charge
    Creato il 21 lug 2010
    Consegnato il 26 lug 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H rosebank house lower henley road caversham reading berkshire propriertor-haven healthcare (developments)limited t/no:BK128868. Tarino house hackney london propriertor-haven healthcare (developments) limited t/no:EGL228648 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) on the property.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V. London Branch (As Security Agent)
    Transazioni
    • 26 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 30 mar 2000
    Consegnato il 11 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, obligations and liabilities due or to become due from the company to any beneficiary under or pursuant to the terms of any of the finance documents, the loan facility or other financial accommodation and under the terms of the charge (all defined therein)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland("the Security Trustee")
    Transazioni
    • 11 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 mar 2000
    Consegnato il 10 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental debenture supplemental to a syndicated debenture dated 1/5/96
    Creato il 15 gen 1997
    Consegnato il 28 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the terms of any of the finance documents (as defined) and/or in connection with the loan facility or other financial accommodation from time to time granted or otherwise
    Brevi particolari
    F/Hold property formerly part of haywards heath hospital,butlers green rd,hayeards heath,west sussex.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 28 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 mag 1996
    Consegnato il 17 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security trustee),the agent and each of the banks (as defined) under or pursuant to the terms of the finance documents (as defined) and/or in connection with the loan facility or other financial accomodation from time to time granted or otherwise made available pursuant thereto
    Brevi particolari
    F/H land k/a 442 cherry hinton road cambridge t/n CB154770 and all the f/h land being a strip of land lying to the south of cherry hinton road cambridge t/n CB183488. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 17 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0