FINTRADE TECHNOLOGIES LTD

FINTRADE TECHNOLOGIES LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFINTRADE TECHNOLOGIES LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02552592
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FINTRADE TECHNOLOGIES LTD?

    • (2754) /

    Dove si trova FINTRADE TECHNOLOGIES LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Kings Wharf
    20-30 Kings Road
    RG1 3EX Reading
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FINTRADE TECHNOLOGIES LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ALLOY WHEELS INTERNATIONAL LIMITED05 feb 199105 feb 1991
    MISLEX (5) LIMITED26 ott 199026 ott 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di FINTRADE TECHNOLOGIES LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2002

    Quali sono le ultime deposizioni per FINTRADE TECHNOLOGIES LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rinvio della dissoluzione

    1 pagineL64.04

    Completamento della liquidazione

    1 pagineL64.07

    Varie

    Sec of state's release of liq
    1 pagineMISC

    Varie

    Sec of state's release of liq
    1 pagineMISC

    Ordine del tribunale di liquidazione

    1 pagineCOCOMP

    Ordine del tribunale di liquidazione

    1 pagineCOCOMP

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    8 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    4 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    4 pagine2.34B

    Risultato della riunione dei creditori

    3 pagine2.23B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    15 pagine2.17B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    5 pagine2.24B

    Dichiarazione delle attività

    18 pagine2.16B

    Risultato della riunione dei creditori

    3 pagine2.23B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    31 pagine2.17B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    6 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di FINTRADE TECHNOLOGIES LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ARM SECRETARIES LIMITED
    Somers Mounts Hill
    Benenden
    TN17 4ET Cranbrook
    Kent
    Segretario
    Somers Mounts Hill
    Benenden
    TN17 4ET Cranbrook
    Kent
    60146690007
    VERMAAK, Gerhardus
    13 Mayflower House
    Valetta Way
    ME1 1FA Rochester
    Kent
    Amministratore
    13 Mayflower House
    Valetta Way
    ME1 1FA Rochester
    Kent
    South African80269840003
    BELL, Paul Harrison
    Rowan House Stonewall Park Road
    Langton Green
    TN3 0HN Tunbridge Wells
    Kent
    Segretario
    Rowan House Stonewall Park Road
    Langton Green
    TN3 0HN Tunbridge Wells
    Kent
    British74801170002
    DAVIES, Stephen Raymond
    15 Court Lodge
    Shorne
    DA12 3EQ Gravesend
    Kent
    Segretario
    15 Court Lodge
    Shorne
    DA12 3EQ Gravesend
    Kent
    British50734440001
    DRURY, Kenneth Malcolm
    Dairy Farm Cottage
    Sutton Hoo,
    IP12 3DJ Woodbridge
    Suffolk
    Segretario
    Dairy Farm Cottage
    Sutton Hoo,
    IP12 3DJ Woodbridge
    Suffolk
    British56761690004
    EVANS, Lyn
    2 Dental Close
    Borden
    ME10 1DT Sittingbourne
    Kent
    Segretario
    2 Dental Close
    Borden
    ME10 1DT Sittingbourne
    Kent
    British66828710002
    HERSCH, Benson Selwyn
    60 Grange Gardens
    HA5 5QF Pinner
    Middlesex
    Segretario
    60 Grange Gardens
    HA5 5QF Pinner
    Middlesex
    British6057020001
    LINLEY, Andrew Northam
    9 Briar Fields
    Grove Green
    ME14 5UZ Maidstone
    Kent
    Segretario
    9 Briar Fields
    Grove Green
    ME14 5UZ Maidstone
    Kent
    South African39628820001
    BELL, Paul Harrison
    Rowan House Stonewall Park Road
    Langton Green
    TN3 0HN Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Rowan House Stonewall Park Road
    Langton Green
    TN3 0HN Tunbridge Wells
    Kent
    British74801170002
    COOK, Peter George
    2 Grove Cottages
    Hogg Lane
    WD6 3AL Elstree
    Middlesex
    Amministratore
    2 Grove Cottages
    Hogg Lane
    WD6 3AL Elstree
    Middlesex
    British36768870001
    DAVIES, Stephen Raymond
    15 Court Lodge
    Shorne
    DA12 3EQ Gravesend
    Kent
    Amministratore
    15 Court Lodge
    Shorne
    DA12 3EQ Gravesend
    Kent
    EnglandBritish50734440001
    DEELEY, Michael David
    33 Copper Tree Court
    Loose
    ME15 9RW Maidstone
    Kent
    Amministratore
    33 Copper Tree Court
    Loose
    ME15 9RW Maidstone
    Kent
    British4904280001
    DRURY, Kenneth Malcolm
    Dairy Farm Cottage
    Sutton Hoo,
    IP12 3DJ Woodbridge
    Suffolk
    Amministratore
    Dairy Farm Cottage
    Sutton Hoo,
    IP12 3DJ Woodbridge
    Suffolk
    British56761690004
    DYNE, Ronald Irvin
    6 Marsh Close
    Mill Hill
    NW7 4NY London
    Amministratore
    6 Marsh Close
    Mill Hill
    NW7 4NY London
    British10505810001
    LE ROUX, Allan
    13 Mayflower House
    Valetta Way
    ME1 1FA Rochester
    Kent
    Amministratore
    13 Mayflower House
    Valetta Way
    ME1 1FA Rochester
    Kent
    South African83399270002
    LINDSAY, Antony Dennis
    26 Jubilee Close
    Cam
    GL11 5JQ Dursley
    Gloucestershire
    Amministratore
    26 Jubilee Close
    Cam
    GL11 5JQ Dursley
    Gloucestershire
    British31476550001
    LINLEY, Andrew Northam
    9 Briar Fields
    Grove Green
    ME14 5UZ Maidstone
    Kent
    Amministratore
    9 Briar Fields
    Grove Green
    ME14 5UZ Maidstone
    Kent
    South African39628820001
    MERRITT, Paul Henry
    Green Hedges
    Chambers Green Road Pluckley
    TN27 0RH Ashford
    Kent
    Amministratore
    Green Hedges
    Chambers Green Road Pluckley
    TN27 0RH Ashford
    Kent
    British86760460001
    NOAKES, Bernard
    24 Petersfield
    Broomfield
    CM1 4EP Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    24 Petersfield
    Broomfield
    CM1 4EP Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritish20377840002
    SCHLOSBERG, Hilton Hiller
    2 Lake Drive
    Hartsbourne Road
    WD2 1QP Bushey Heath
    Hertfordshire
    Amministratore
    2 Lake Drive
    Hartsbourne Road
    WD2 1QP Bushey Heath
    Hertfordshire
    South African36217260002
    WALLER, John Daniel Arthur
    Berkeley House Berkeley Road
    TN20 6EH Mayfield
    East Sussex
    Amministratore
    Berkeley House Berkeley Road
    TN20 6EH Mayfield
    East Sussex
    British31476590001

    FINTRADE TECHNOLOGIES LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 22 lug 2002
    Consegnato il 05 ago 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Account charge
    Creato il 06 apr 2001
    Consegnato il 18 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities of the company and/or aac to the bank as at the date of the charge or thereafter (as from time to time modified, amended, renewed or extended) under the agreement and/or any security document (including the charge) to which the company and/or aac is a party and all other monies, obligations and liabilities of the company and/or aac to the bank howsoever arising (all terms as defined)
    Brevi particolari
    With full title guarantee all its right, title and interest in the account and the deposit as a continuing security in favour of the bank for the discharge of the secured obligations.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 ago 2000
    Consegnato il 22 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 17 mar 1998
    Consegnato il 18 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 x efco horizontal conveyorised alloy wheel pre-heating oven serial number 45697 together with the proceeds and products thereof benefit of all policies of insurance warranties guarantees and other contracts in respect of the prope rty. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royscot Industrial Leasing LTD
    • Royscot Commercial Leasing LTD.
    • Royscot Leasing LTD.
    • Royscot Trust PLC
    • Royscot Spa Leasing Limited
    Transazioni
    • 18 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 22 gen 1997
    Consegnato il 30 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors (as defined) to any beneficiary (as defined) pursuant to the terms of any of the finance documents and/or in connection with any loan facility or other financial accommodation from time to time granted and on any other account whatsoever together with all expenses under the terms of this debenture
    Brevi particolari
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 30 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Group cross-guarantee indemnity and debenture
    Creato il 22 gen 1997
    Consegnato il 04 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under clause 2 of the deed
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Must Screens Bv
    Transazioni
    • 04 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 28 feb 1995
    Consegnato il 08 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The plant machinery chattels or other equipment of the company as specified in the attached continuation sheets which also contain details of covenants by and restrictions on the company which protect and further define the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 08 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 28 apr 1994
    Consegnato il 05 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The plant machinery chattels or other equipment described in the schedule to the deed together with any alterations accessories replacements and renewals from time to time thereto. The benefit of any guarantee warranty or other obligations in relation thereto........ See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 05 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 lug 1993
    Consegnato il 27 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Meespierson N.V.
    Transazioni
    • 27 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 lug 1993
    Consegnato il 26 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 26 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 23 lug 1993
    Consegnato il 24 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The plant machinery and chattels of the company as detailed on form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 24 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 apr 1993
    Consegnato il 15 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property comprising the former parkfield works lying to the east of cardiff road,taff's well,taff-ely mid glamorgan t/n WA405745.
    Persone aventi diritto
    • Allied Trust Bank Limited
    Transazioni
    • 15 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 apr 1993
    Consegnato il 15 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property comprising the mellingriffith works,whitchurch,cardiff,s glamorgan t/n wa 150348.
    Persone aventi diritto
    • Allied Trust Bank Limited
    Transazioni
    • 15 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 lug 1991
    Consegnato il 16 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 12/1/91 and/or a supplemental loan agreement dated 22/7/91 on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land lying to the east of cardiff road, taff's well title no:- wa 405745 together with the entire benefit of all its rights title & inteest in all occupational and/& business leases a tenancies etc. fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Swiss Bank Corporation
    Transazioni
    • 16 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 27 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 lug 1991
    Consegnato il 16 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 12/1/91 and/or a supplemental loan agreement dated 22/7/91 on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property at milingriffith works, whitchurch title no:- wa 150348 together with the entire benefit of all its rights title & interest in all occupational and/or business leases a tenancies etc. fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment. (See form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Swiss Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 16 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 27 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 12 gen 1991
    Consegnato il 24 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures & fittings) (see form 395 for full details and details of the property).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Swiss Bank Corporation
    Transazioni
    • 24 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 27 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    FINTRADE TECHNOLOGIES LTD ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    10 dic 2004Fine dell'amministrazione
    11 dic 2003Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Antony David Nygate
    Bdo Stoy Hayward
    8 Baker Street
    London
    W1u 3ll
    Praticante
    Bdo Stoy Hayward
    8 Baker Street
    London
    W1u 3ll
    James Joseph Bannon
    Bdo Stoy Hayward Llp
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    Praticante
    Bdo Stoy Hayward Llp
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    1
    DataTipo
    10 dic 2004Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    2
    DataTipo
    05 ago 2010Data di scioglimento
    12 dic 2005Data della petizione
    05 ago 2008Conclusione della liquidazione
    08 mar 2006Inizio della liquidazione
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praticante
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0