PACEMAKER DISTRIBUTION LIMITED

PACEMAKER DISTRIBUTION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPACEMAKER DISTRIBUTION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02553549
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PACEMAKER DISTRIBUTION LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PACEMAKER DISTRIBUTION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 291 & 296 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di PACEMAKER DISTRIBUTION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 nov 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per PACEMAKER DISTRIBUTION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 09 nov 2012

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Cessazione della carica di Peter Louden come amministratore in data 13 mar 2012

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Crestwood House Birches Rise Willenhall West Midlands WV13 2DB in data 11 apr 2012

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter Louden il 07 dic 2011

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 30 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 nov 2011

    Stato del capitale al 01 nov 2011

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter Louden il 26 nov 2010

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2009

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Bernard Burns come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Peter Louden come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 30 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Bernard Kenneth Robbie Burns il 30 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ian David Horsfall il 30 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Ian David Horsfall il 30 nov 2009

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 30 nov 2008

    5 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 nov 2007

    5 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di PACEMAKER DISTRIBUTION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HORSFALL, Ian David
    Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Unit 291 & 296
    Worcestershire
    Segretario
    Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Unit 291 & 296
    Worcestershire
    British104565220001
    HORSFALL, Ian David
    Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Unit 291 & 296
    Worcestershire
    Amministratore
    Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Unit 291 & 296
    Worcestershire
    EnglandBritish104565220001
    GWILLIAM, Stephen Paul
    5 Andover Crescent
    DY6 8PH Kingswinford
    West Midlands
    Segretario
    5 Andover Crescent
    DY6 8PH Kingswinford
    West Midlands
    British93396970001
    RUSSELL, Craig
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    Segretario
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    British35522270001
    VANVENROOIJ, Douglas John
    29 Thomas Drive
    Warfield
    RG12 6DZ Bracknell
    Berkshire
    Segretario
    29 Thomas Drive
    Warfield
    RG12 6DZ Bracknell
    Berkshire
    British16106290002
    BLACK, David Russell
    Upper House
    Ashperton
    HR8 2SA Ledbury
    Herefordshire
    Amministratore
    Upper House
    Ashperton
    HR8 2SA Ledbury
    Herefordshire
    British2755270003
    BURNS, Bernard Kenneth Robbie
    Crestwood House
    Birches Rise
    WV13 2DB Willenhall
    West Midlands
    Amministratore
    Crestwood House
    Birches Rise
    WV13 2DB Willenhall
    West Midlands
    EnglandBritish239557120001
    DUNN, Lloyd John Charles
    Goodison 38 Mill Lane
    Barrow Upon Soar
    LE12 8LH Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Goodison 38 Mill Lane
    Barrow Upon Soar
    LE12 8LH Loughborough
    Leicestershire
    EnglandBritish105512500001
    JACKSON, Paul
    14 Redmain Way
    West Derby
    L12 0LU Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    14 Redmain Way
    West Derby
    L12 0LU Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish40294740001
    KELLY, Robert David Lindsay
    Glanville House
    Alcester Road Wooton Wawen
    B95 6BQ Henley In Arden
    Warwickshire
    Amministratore
    Glanville House
    Alcester Road Wooton Wawen
    B95 6BQ Henley In Arden
    Warwickshire
    EnglandWelsh161123860001
    LOUDEN, Peter
    Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Unit 291 & 296
    Worcestershire
    Amministratore
    Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Unit 291 & 296
    Worcestershire
    United KingdomBritish172376370001
    O'ROURKE, Gerald
    63 Manor Road
    TW15 2SL Ashford
    Middlesex
    Amministratore
    63 Manor Road
    TW15 2SL Ashford
    Middlesex
    EnglandBritish66245110003
    POTTER, Ian Roger
    17 Victoria Mill Drive
    Willaston
    CW5 6RR Nantwich
    Cheshire
    Amministratore
    17 Victoria Mill Drive
    Willaston
    CW5 6RR Nantwich
    Cheshire
    EnglandBritish63766210003
    REDBURN, Timothy John
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    Amministratore
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    EnglandBritish22018030002
    ROSSITER, Philip
    Coppathorne Wapsey Lane
    Hedgerley
    SL2 3XG Slough
    Berkshire
    Amministratore
    Coppathorne Wapsey Lane
    Hedgerley
    SL2 3XG Slough
    Berkshire
    British12257420001
    RUSSELL, Craig
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    Amministratore
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    British35522270001
    SMITH, Martin
    3 The Wilderness
    Molesey Park Road
    KT8 0JT East Molesey
    Surrey
    Amministratore
    3 The Wilderness
    Molesey Park Road
    KT8 0JT East Molesey
    Surrey
    United KingdomBritish11712330002
    VANVENROOIJ, Douglas John
    29 Thomas Drive
    Warfield
    RG12 6DZ Bracknell
    Berkshire
    Amministratore
    29 Thomas Drive
    Warfield
    RG12 6DZ Bracknell
    Berkshire
    British16106290002

    PACEMAKER DISTRIBUTION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental deed to the third guarantee and debenture (the "debenture") dated 20 june 2001 made between pacemaker distribution limited and the governor and company of the bank of scotland
    Creato il 19 dic 2001
    Consegnato il 02 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    As set out in the assignment dated 03 july 2001 the supplemental deed amends the definition of the "senior finance documents" (as defined therein)
    Brevi particolari
    As set out in the 395 registered on 3 july 2001 in relation to the debenture.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed to the second guarantee and debenture (the "debenture") dated 05 march 2001 made between pacemaker distribution limited and the governor and company of the bank of scotland
    Creato il 19 dic 2001
    Consegnato il 02 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    As set out in the assignment dated 13 march 2001 the supplemental deed amends the definition of the "senior finance documents" (as defined therein)
    Brevi particolari
    As set out in the 395 registered on 13 march 2001 in relation to the debenture.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 20 giu 2001
    Consegnato il 03 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities on or after the date of the debenture due, owing or incurred by the company (the "chargor") to the chargee (acting as security agent and trustee for the other beneficiaries (as defined) and includes any successor appointed by the beneficiaries pursuant to the finance documents) under or pursuant to the senior finance documents and the mezzanine finance documents (both as defined therein) to which it is expressed to be a party; and each other company to the chargee (acting as security agent and trustee for the other beneficiaries (as defined) and includes any successor appointed by the beneficiaries pursuant to the finance documents) (as therein defined) (except as a guarantor for the "chargor") under or pursuant to the senior finance documents and the mezzanine finance documents and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 05 mar 2001
    Consegnato il 13 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security agent and trustee for the benficiaries (as defined) under or pursuant to the senior finance documents (as defined) and each other company (as defined) (except as guarantor for the chargor) under or pursuant to the senior finance documents on any account whatsoever and all monies and liabilities owing or incurred to each beneficiary by the compan under or pursuant to the mezzanine finance documents (as defined) and each other company (except as a guarantor for the chargor) under or pursuant to the mezzanine finance documents on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 ago 1997
    Consegnato il 27 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 27 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 27 feb 1997
    Consegnato il 07 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Book debts debenture
    Creato il 16 nov 1994
    Consegnato il 18 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge on all book debts and other debts of the company both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 18 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 gen 1993
    Consegnato il 14 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H unit 13 trident way international trading estate brent road southall middlesex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 nov 1992
    Consegnato il 10 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PACEMAKER DISTRIBUTION LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 nov 2012Inizio della liquidazione
    06 mag 2013Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0