INDUSTRIAL CONTROL SERVICES GROUP LTD
Panoramica
Nome della società | INDUSTRIAL CONTROL SERVICES GROUP LTD |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02553840 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di INDUSTRIAL CONTROL SERVICES GROUP LTD?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova INDUSTRIAL CONTROL SERVICES GROUP LTD?
Indirizzo della sede legale | Pitfield Kiln Farm MK11 3DR Milton Keynes Buckinghamshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di INDUSTRIAL CONTROL SERVICES GROUP LTD?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
EXACTHOLD LIMITED | 31 ott 1990 | 31 ott 1990 |
Quali sono gli ultimi bilanci di INDUSTRIAL CONTROL SERVICES GROUP LTD?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per INDUSTRIAL CONTROL SERVICES GROUP LTD?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per INDUSTRIAL CONTROL SERVICES GROUP LTD?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 30 mar 2015
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 ott 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2013 | 15 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 ott 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di Brian Watson come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2012 | 15 pagine | AA | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Ics House Hall Road Maldon Essex CM9 4LA* in data 16 gen 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 ott 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato | 1 pagine | AD02 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Francis Conway come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2011 | 12 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 ott 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2010 | 13 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Thomas Greene come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr William Joseph Quinn come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 ott 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Nomina di Brian Andrew Watson come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di INDUSTRIAL CONTROL SERVICES GROUP LTD?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUINN, William Joseph | Amministratore | Hall Road CM9 4LA Maldon Ics House Essex | United Kingdom | British | None | 13012070003 | ||||
CONWAY, Francis Joseph | Segretario | Torrington Drive EN6 5HS Potters Bar 40 Hertfordshire | British | 137700320001 | ||||||
DODDS, Brian Alfred | Segretario | 4 Parkway Gidea Park RM2 5NT Romford Essex | British | 1782460002 | ||||||
CHALK, Clive Andrew | Amministratore | 12 Rydon Mews SW19 4RP Wimbledon London | United Kingdom | British | Retired Merchant Banker | 147480740001 | ||||
DODDS, Brian Alfred | Amministratore | 4 Parkway Gidea Park RM2 5NT Romford Essex | British | Chartered Accountant | 1782460002 | |||||
GREENE, Thomas | Amministratore | Capital Wharf 50 Wapping High Street E1W 1LY London 81 | United Kingdom | British | Director | 128888620002 | ||||
GRIFFIN, Claudia Maria | Amministratore | Rue De La Concorde 7 1050 Brussels Belgium | German | Finance Director | 125074000002 | |||||
HALL, Peter John, Doctor | Amministratore | Clavering Hall Stortford Road Clavering CB11 4PG Saffron Walden Essex | British | Electrical Engineer | 112317390001 | |||||
HENDRICKX, Frederic Jean Hubert Cecile | Amministratore | Korenveldlaan, 56 Wemmel 1780 Belgium | Belgium | Belgian | Emea General Counsel | 126703710001 | ||||
LEESER, Andrew John | Amministratore | 17 Rectory Road North Fambridge CM3 6NG Chelmsford Essex | United Kingdom | British | Management Accountant | 92752280001 | ||||
LINDSAY, David | Amministratore | 92 Sandringham Road WD24 7BE Watford Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 78093740001 | |||||
MANN, David William | Amministratore | Theydon Copt Forest Side CM16 4ED Epping Essex | England | British | Company Director | 11201900001 | ||||
MASON, Michael William | Amministratore | Willow Cottage 70 Wellington Road Muxton TF2 8NZ Telford Salop | British | Process Control Systems Execut | 64356330001 | |||||
MOTTERSHEAD, Peter David Leigh | Amministratore | Red Barn House Red Barn Drive Leavenheath CO6 4UW Colchester Essex | England | British | Engineer | 102140470001 | ||||
MURPHY, Rachel | Amministratore | 47 The Avenue Kew TW9 2AL Richmond | British | Venture Capitalist | 81893100002 | |||||
PALMER, Denis George | Amministratore | 27 Station Road Tiptree CO5 0BB Colchester Essex | British | Project Engineer | 32075450001 | |||||
PARSELL, Antony Clive | Amministratore | Hall Road CM9 4LA Maldon Ic5 House Essex | England | English | None | 76298010001 | ||||
RICHARDS, William Samuel Clive | Amministratore | Lower Hope Ullingswick HR1 3JF Hereford Herefordshire | England | British | Chartered Accountant | 70437990001 | ||||
RIMMER, David Norman | Amministratore | Ridgefield 23 Newport Road ST21 6BE Eccleshall Staffordshire | United Kingdom | British | Director | 71617270002 | ||||
TURNBULL, George Frederick, Professor | Amministratore | Millers Croft 37 Ferring Lane BN12 6QT Ferring West Sussex | United Kingdom | British | Engineer | 59375460001 | ||||
WATSON, Brian Andrew | Amministratore | Hall Road CM9 4LA Maldon Ics House Essex | United Kingdom | British | Accountant | 147524500001 | ||||
WEST, Ronald James | Amministratore | 65 Cherry Orchard CM0 7HE Southminster Essex | British | Technical Dir | 44779410002 | |||||
WHEATLEY, Clement Trevor | Amministratore | Plas-Y-Bryn Llanfair Road SY16 3JY Newtown Powys | Wales | British | Chairman | 10994430002 | ||||
WILKINSON, James Arthur | Amministratore | Beacon Hill House St Lawrence CM0 7UF Southminster Essex | British | Electrical Engineer | 1783380001 | |||||
WITHRINGTON, Geoffrey Alan | Amministratore | Martins Thakeham RH20 3EP Pulborough West Sussex | British | Chief Executive | 56500950001 | |||||
WRIGHT, Ian Francis | Amministratore | 240 Hamilton Lane Scraptoft LE7 9SD Leicester Leicestershire | England | British | Engineer | 70495900002 |
INDUSTRIAL CONTROL SERVICES GROUP LTD ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Mortgage debenture | Creato il 15 gen 2001 Consegnato il 24 gen 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The premises as defined in the mortgage debenture namely all and singular the undertaking and assets whatsoever and wheresoever both present and future. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 19 giu 1998 Consegnato il 06 lug 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the mortgage debenture | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 04 lug 1997 Consegnato il 16 lug 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the mortgage debenture | |
Brevi particolari Title no. Ex 511 366 : car parking land, the saltings, maldon, essex CM9 4LA owned by bcmb private clients limited. All other freehold and leasehold property of the companies; unpaid issued shares in the capital of the companies; all goodwill, engines, plant, machinery, fixtures, fittings, furniture and equipment, hire purchase agreements and books of account of the companies; all securities and documents evidencing any estate, right, title or interest of the companies in any property deposited with the trustee; all book debts and receivables of the companies; and all other fixed assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental charge | Creato il 18 giu 1997 Consegnato il 25 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a principal debenture dated 23RD april 1992 | |
Brevi particolari All patents patent applications trade marks trade mark applications designs design rights and all other intellectual property rights inclusive of all licences under the charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 23 apr 1992 Consegnato il 12 mag 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0