CARLYLE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCARLYLE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02555206
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CARLYLE LIMITED?

    • Operazione di strutture di stoccaggio e deposito per attività di trasporto via terra (52103) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova CARLYLE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    KROLL ADVISORY LTD
    4b Cornerblock 2 Cornwall Street
    B3 2DX Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CARLYLE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CARLYLE BUS & COACH LIMITED13 mag 199913 mag 1999
    CARLYLE PARTS AND SERVICE LIMITED13 dic 199413 dic 1994
    CARLYLE PARTS LIMITED05 nov 199005 nov 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di CARLYLE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per CARLYLE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    37 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    34 pagineAM10

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    15 pagineAM02

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    3 pagineAM06

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    51 pagineAM03

    Indirizzo della sede legale modificato da Carlyle Business Park Ham Lane Kingswinford West Midlands DY6 7JL United Kingdom a 4B Cornerblock 2 Cornwall Street Birmingham B3 2DX in data 27 ott 2022

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Susan Denise Moon il 02 ago 2022

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Laurie Paul Moon il 02 ago 2022

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Steven John Speak il 02 ago 2022

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Carlyle Business Park Great Bridge Street Swan Village West Bromwich West Midlands B70 0XA a Carlyle Business Park Ham Lane Kingswinford West Midlands DY6 7JL in data 02 ago 2022

    1 pagineAD01

    Iscrizione dell'ipoteca 025552060015, creata il 18 lug 2022

    30 pagineMR01

    Cessazione della carica di Monir-Jason Hassanyeh come amministratore in data 05 apr 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 dic 2021 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    30 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 025552060010 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 025552060011 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 025552060012 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 025552060013, creata il 03 nov 2021

    39 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 025552060014, creata il 04 nov 2021

    31 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 dic 2020 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Notifica di Lpw Group Ltd come persona con controllo significativo il 22 dic 2020

    2 paginePSC02

    Cessazione di Lpw (Europe) Ltd come persona con controllo significativo il 22 dic 2020

    1 paginePSC07

    Chi sono gli amministratori di CARLYLE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MOON, Susan Denise
    Ham Lane
    DY6 7JL Kingswinford
    Carlyle Business Park
    West Midlands
    United Kingdom
    Segretario
    Ham Lane
    DY6 7JL Kingswinford
    Carlyle Business Park
    West Midlands
    United Kingdom
    265559830001
    MOON, Laurie Paul
    Ham Lane
    DY6 7JL Kingswinford
    Carlyle Business Park
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Ham Lane
    DY6 7JL Kingswinford
    Carlyle Business Park
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish10813040004
    SPEAK, Steven John
    Ham Lane
    DY6 7JL Kingswinford
    Carlyle Business Park
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Ham Lane
    DY6 7JL Kingswinford
    Carlyle Business Park
    West Midlands
    England
    EnglandBritish237411880001
    TURTON, John Randolph
    18 Whitehill Road
    DY11 6JJ Kidderminster
    Worcestershire
    Segretario
    18 Whitehill Road
    DY11 6JJ Kidderminster
    Worcestershire
    British12717230001
    BOTTRILL, Neil Evans
    Old Timbers
    Pumphouse Lane Hanbury
    B60 4BX Bromsgrove
    Worcestershire
    Amministratore
    Old Timbers
    Pumphouse Lane Hanbury
    B60 4BX Bromsgrove
    Worcestershire
    United KingdomBritish12645610002
    CROFTS, John Edward
    86 Windy Arbour
    CV8 2BB Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    86 Windy Arbour
    CV8 2BB Kenilworth
    Warwickshire
    British33687320001
    DUNN, Stephen Alan
    2 Rodway Close
    WV4 6AX Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    2 Rodway Close
    WV4 6AX Wolverhampton
    West Midlands
    IrelandBritish18453030001
    FORTT, Michael John
    17 Meadow Close
    Downend
    BS16 6QS Bristol
    Avon
    Amministratore
    17 Meadow Close
    Downend
    BS16 6QS Bristol
    Avon
    EnglandBritish41158730001
    HASSANYEH, Monir-Jason
    Carlyle Business Park
    Great Bridge Street
    B70 0XA Swan Village West Bromwich
    West Midlands
    Amministratore
    Carlyle Business Park
    Great Bridge Street
    B70 0XA Swan Village West Bromwich
    West Midlands
    United KingdomBritish237416140002
    HOPPER, John Terence
    9 Thackholme
    WR4 0RZ Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    9 Thackholme
    WR4 0RZ Worcester
    Worcestershire
    British58835430002
    MOON, Gary
    Carlyle Business Park
    Great Bridge Street
    B70 0XA Swan Village West Bromwich
    West Midlands
    Amministratore
    Carlyle Business Park
    Great Bridge Street
    B70 0XA Swan Village West Bromwich
    West Midlands
    EnglandBritish12069370005
    PENN, William John Bannister
    35 Stuarts Green
    DY9 0XR Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    35 Stuarts Green
    DY9 0XR Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritish66966100002
    SMITH, Neil Patrick
    2 Mears Close
    New Oscott
    B23 5YJ Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    2 Mears Close
    New Oscott
    B23 5YJ Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish41159030001
    TURTON, John Randolph
    18 Whitehill Road
    DY11 6JJ Kidderminster
    Worcestershire
    Amministratore
    18 Whitehill Road
    DY11 6JJ Kidderminster
    Worcestershire
    EnglandBritish12717230001
    WAILING, Michael David
    Bridge House
    Fish House Lane
    B60 4JT Stoke Prior
    Worcestershire
    Amministratore
    Bridge House
    Fish House Lane
    B60 4JT Stoke Prior
    Worcestershire
    British25246550003
    WAINE, Christopher Robert
    4 The Bowers
    PR7 3LA Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    4 The Bowers
    PR7 3LA Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish119803270001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CARLYLE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Lpw Group Ltd
    Great Bridge Street
    Swan Village
    B70 0XA West Bromwich
    Carlyle Business Park
    West Midlands
    United Kingdom
    22 dic 2020
    Great Bridge Street
    Swan Village
    B70 0XA West Bromwich
    Carlyle Business Park
    West Midlands
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione12903678
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Great Bridge Street
    Swan Village
    B70 0XA West Bromwich
    Carlyle Business Park
    England
    22 ago 2019
    Great Bridge Street
    Swan Village
    B70 0XA West Bromwich
    Carlyle Business Park
    England
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06381094
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Mr John Randolph Turton
    Carlyle Business Park
    Great Bridge Street
    B70 0XA Swan Village West Bromwich
    West Midlands
    05 nov 2016
    Carlyle Business Park
    Great Bridge Street
    B70 0XA Swan Village West Bromwich
    West Midlands
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    Mr Neil Evans Bottrill
    Carlyle Business Park
    Great Bridge Street
    B70 0XA Swan Village West Bromwich
    West Midlands
    05 nov 2016
    Carlyle Business Park
    Great Bridge Street
    B70 0XA Swan Village West Bromwich
    West Midlands
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.

    CARLYLE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 18 lug 2022
    Consegnato il 19 lug 2022
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Carlyle Investments Limited
    Transazioni
    • 19 lug 2022Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 04 nov 2021
    Consegnato il 04 nov 2021
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Carlyle Investments Limited
    Transazioni
    • 04 nov 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 03 nov 2021
    Consegnato il 04 nov 2021
    In corso
    Breve descrizione
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the termsof the aforementionedinstrument creating or evidencing the charge. Details:. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • 4SYTE Limited
    Transazioni
    • 04 nov 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 18 ott 2019
    Consegnato il 04 nov 2019
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Breal Zeta Cf Limited
    Transazioni
    • 04 nov 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 15 nov 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 18 ott 2019
    Consegnato il 22 ott 2019
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Breal Zeta Cf Limited
    Transazioni
    • 22 ott 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 15 nov 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 22 ago 2019
    Consegnato il 28 ago 2019
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lmn Finance Designated Activity Company
    Transazioni
    • 28 ago 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 15 nov 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge (all assets)
    Creato il 13 gen 2011
    Consegnato il 15 gen 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transazioni
    • 15 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 gen 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 13 gen 2011
    Consegnato il 15 gen 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 15 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 gen 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal assignment
    Creato il 17 lug 2007
    Consegnato il 25 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and includes any discounting allowances the benefit of the contract and all securities for the contract.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 16 lug 2007
    Consegnato il 24 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 24 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 gen 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 17 gen 2006
    Consegnato il 02 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the interest in the interest earning deposit account of £8,643.96. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ubs Global Asset Management (UK) LTD
    Transazioni
    • 02 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ott 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed equitable charge
    Creato il 15 nov 1994
    Consegnato il 18 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book and other debts and/or other forms of obligations hte subject of a factoring agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Griffin Factors Limited
    Transazioni
    • 18 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 17 ago 1994
    Consegnato il 22 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 02 lug 1992
    Consegnato il 06 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 06 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 12 dic 1990
    Consegnato il 24 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Westpac Banking Corporation
    Transazioni
    • 24 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 22 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CARLYLE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 ott 2022Inizio dell'amministrazione
    26 ott 2023Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Steven Muncaster
    Kroll Advisory Ltd The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Praticante
    Kroll Advisory Ltd The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Matthew Ingram
    4b Cornerblock, 2 Cornwall Street
    B3 2DX Birmingham
    Praticante
    4b Cornerblock, 2 Cornwall Street
    B3 2DX Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0