MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED

MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMATRIX (HIGHLANDS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02558700
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Gladstone Place
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Hertfordshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TRAVELBASIC LIMITED15 nov 199015 nov 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Stato del capitale al 12 feb 2021

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account cancelled 26/01/2021
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2019

    20 pagineAA

    legacy

    79 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2018

    20 pagineAA

    legacy

    64 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Modifica dei dettagli di Malthurst Petroleum Limited come persona con controllo significativo il 16 lug 2019

    2 paginePSC05

    Nomina di Thomas Mckenzie Biggart come amministratore in data 11 mar 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Pinsent Masons Secretarial Limited come segretario in data 07 mar 2019

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di David Hathaway come segretario in data 07 mar 2019

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Graham Paul Timbers come amministratore in data 12 feb 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Simon Paul Lane come amministratore in data 19 dic 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr William Bahlsen Bannister come amministratore in data 19 dic 2018

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Vincent House 4 Grove Lane Epping Essex CM16 4LH a Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road St. Albans Hertfordshire AL1 3UU in data 21 dic 2018

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    Segretario
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione02318923
    76579530001
    BANNISTER, William Bahlsen
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish252731900001
    BIGGART, Thomas Mckenzie
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    ScotlandBritish215843640001
    LANE, Simon Paul
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish252862090001
    HATHAWAY, David
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Segretario
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    173702820001
    IQBAL, Damian Shameem
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    Segretario
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    173703080001
    KERRIDGE, Nicola Jane
    Melway House
    Child Okeford
    DT11 8EW Blandford Forum
    Dorset
    Segretario
    Melway House
    Child Okeford
    DT11 8EW Blandford Forum
    Dorset
    British20367220003
    BACK, Steven John
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    Amministratore
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    United KingdomBritish205661380001
    DICKENS, Karen Juanita, Dr
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    Amministratore
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    United KingdomBritish124061360001
    GRAY, Michael Stuart
    Slackbuie Way
    IV2 6AT Inverness
    16
    Inverness-Shire
    United Kingdom
    Amministratore
    Slackbuie Way
    IV2 6AT Inverness
    16
    Inverness-Shire
    United Kingdom
    United KingdomBritish82067270002
    KERRIDGE, Mark William
    Melway House
    Child Okeford
    DT11 8EW Blandford Forum
    Dorset
    Amministratore
    Melway House
    Child Okeford
    DT11 8EW Blandford Forum
    Dorset
    United KingdomBritish9965070004
    KERRIDGE, Nicola Jane
    Melway House
    Child Okeford
    DT11 8EW Blandford Forum
    Dorset
    Amministratore
    Melway House
    Child Okeford
    DT11 8EW Blandford Forum
    Dorset
    United KingdomBritish20367220003
    KERRIDGE, William Nicholas
    Prowtings
    Chawton
    GU34 1SD Alton
    Hampshire
    Amministratore
    Prowtings
    Chawton
    GU34 1SD Alton
    Hampshire
    United KingdomBritish9299940001
    LYNN, John Charles
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    Amministratore
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    United KingdomBritish29838790004
    PEACOCK, Graham Frederick
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    Amministratore
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    United KingdomBritish5133310002
    SCOTT, Richard Antony Cargill
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    Amministratore
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    EnglandBritish107002130001
    TIMBERS, Graham Paul
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish127888240001
    TOBBELL, Susan Margaret
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    Amministratore
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    United KingdomBritish17957620003

    Chi sono le persone con controllo significativo di MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Malthurst Petroleum Limited
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione00762360
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 ago 2015
    Consegnato il 25 ago 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 25 ago 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 10 dic 2009
    Consegnato il 15 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 30 nov 2009
    Consegnato il 02 feb 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and whole the subjects k/a and forming that area of ground at mintlaw service station south street mintlaw aberdeen comprising first:- (first) (one) all and whole that piece of ground lying in the village and lands and estate of mintlaw in the parish of longside and county of aberdeen, being the area of ground more particularly described in and shown delinated and coloured pink on the plan annexed (two) all and whole that lot of area of ground situated in the square in the village of mintlaw in the parish of longside and county of aberdeen see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 feb 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 8 january 2007 and
    Creato il 03 gen 2007
    Consegnato il 24 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Pitlochry service station perth road pitlochry.
    Persone aventi diritto
    • Bp Oil UK Limited
    Transazioni
    • 24 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 20TH september 2000 and
    Creato il 31 ago 2000
    Consegnato il 28 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    That area of ground extending to 91 poles 24 square yards or thereby lying in the former burgh of forres and county of moray together with the whole buildings and other erections thereon; all fittings fixtures therein and all right,title and interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Girobank PLC
    Transazioni
    • 28 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security
    Creato il 02 ott 1992
    Consegnato il 16 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of a minute of agreement dated 1ST and 22ND july 1992 and any future agreement.
    Brevi particolari
    All and whole the dominium utile and dominium directum of all and whole that piece of ground lying in the village and lands and estate of mintlaw in the parish of longside and county of aberdeen. For full details please see doc M385C.
    Persone aventi diritto
    • Bp Oil UK Limited
    Transazioni
    • 16 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 19 giu 1991
    Consegnato il 27 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £91800 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee by F.W.kerridge limited in respect of the obligations of the company
    Brevi particolari
    All and whole that area of ground extending to ninety one poles, twenty four square yards of thereby imperial standard measure lying in the former burgh of forres and county of moray see form 395 for details.
    Persone aventi diritto
    • Texaco Limited
    Transazioni
    • 27 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 15 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0