MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02558700 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Hertfordshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| TRAVELBASIC LIMITED | 15 nov 1990 | 15 nov 1990 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Stato del capitale al 12 feb 2021
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2019 | 20 pagine | AA | ||||||||||||||
legacy | 79 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2018 | 20 pagine | AA | ||||||||||||||
legacy | 64 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
Modifica dei dettagli di Malthurst Petroleum Limited come persona con controllo significativo il 16 lug 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||||||
Nomina di Thomas Mckenzie Biggart come amministratore in data 11 mar 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Pinsent Masons Secretarial Limited come segretario in data 07 mar 2019 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di David Hathaway come segretario in data 07 mar 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Graham Paul Timbers come amministratore in data 12 feb 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Simon Paul Lane come amministratore in data 19 dic 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr William Bahlsen Bannister come amministratore in data 19 dic 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Vincent House 4 Grove Lane Epping Essex CM16 4LH a Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road St. Albans Hertfordshire AL1 3UU in data 21 dic 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Segretario | Park Row LS1 5AB Leeds 1 England |
| 76579530001 | ||||||||||
| BANNISTER, William Bahlsen | Amministratore | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | United Kingdom | British | 252731900001 | |||||||||
| BIGGART, Thomas Mckenzie | Amministratore | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | Scotland | British | 215843640001 | |||||||||
| LANE, Simon Paul | Amministratore | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | England | British | 252862090001 | |||||||||
| HATHAWAY, David | Segretario | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | 173702820001 | |||||||||||
| IQBAL, Damian Shameem | Segretario | 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Vincent House Essex England | 173703080001 | |||||||||||
| KERRIDGE, Nicola Jane | Segretario | Melway House Child Okeford DT11 8EW Blandford Forum Dorset | British | 20367220003 | ||||||||||
| BACK, Steven John | Amministratore | 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Vincent House Essex | United Kingdom | British | 205661380001 | |||||||||
| DICKENS, Karen Juanita, Dr | Amministratore | 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Vincent House Essex | United Kingdom | British | 124061360001 | |||||||||
| GRAY, Michael Stuart | Amministratore | Slackbuie Way IV2 6AT Inverness 16 Inverness-Shire United Kingdom | United Kingdom | British | 82067270002 | |||||||||
| KERRIDGE, Mark William | Amministratore | Melway House Child Okeford DT11 8EW Blandford Forum Dorset | United Kingdom | British | 9965070004 | |||||||||
| KERRIDGE, Nicola Jane | Amministratore | Melway House Child Okeford DT11 8EW Blandford Forum Dorset | United Kingdom | British | 20367220003 | |||||||||
| KERRIDGE, William Nicholas | Amministratore | Prowtings Chawton GU34 1SD Alton Hampshire | United Kingdom | British | 9299940001 | |||||||||
| LYNN, John Charles | Amministratore | 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Vincent House Essex England | United Kingdom | British | 29838790004 | |||||||||
| PEACOCK, Graham Frederick | Amministratore | 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Vincent House Essex England | United Kingdom | British | 5133310002 | |||||||||
| SCOTT, Richard Antony Cargill | Amministratore | 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Vincent House Essex England | England | British | 107002130001 | |||||||||
| TIMBERS, Graham Paul | Amministratore | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | England | British | 127888240001 | |||||||||
| TOBBELL, Susan Margaret | Amministratore | 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Vincent House Essex England | United Kingdom | British | 17957620003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malthurst Petroleum Limited | 06 apr 2016 | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St Albans Gladstone Place Hertfordshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 20 ago 2015 Consegnato il 25 ago 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 10 dic 2009 Consegnato il 15 dic 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 30 nov 2009 Consegnato il 02 feb 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All and whole the subjects k/a and forming that area of ground at mintlaw service station south street mintlaw aberdeen comprising first:- (first) (one) all and whole that piece of ground lying in the village and lands and estate of mintlaw in the parish of longside and county of aberdeen, being the area of ground more particularly described in and shown delinated and coloured pink on the plan annexed (two) all and whole that lot of area of ground situated in the square in the village of mintlaw in the parish of longside and county of aberdeen see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 8 january 2007 and | Creato il 03 gen 2007 Consegnato il 24 gen 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Pitlochry service station perth road pitlochry. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 20TH september 2000 and | Creato il 31 ago 2000 Consegnato il 28 set 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari That area of ground extending to 91 poles 24 square yards or thereby lying in the former burgh of forres and county of moray together with the whole buildings and other erections thereon; all fittings fixtures therein and all right,title and interest thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 02 ott 1992 Consegnato il 16 ott 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of a minute of agreement dated 1ST and 22ND july 1992 and any future agreement. | |
Brevi particolari All and whole the dominium utile and dominium directum of all and whole that piece of ground lying in the village and lands and estate of mintlaw in the parish of longside and county of aberdeen. For full details please see doc M385C. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 19 giu 1991 Consegnato il 27 giu 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £91800 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee by F.W.kerridge limited in respect of the obligations of the company | |
Brevi particolari All and whole that area of ground extending to ninety one poles, twenty four square yards of thereby imperial standard measure lying in the former burgh of forres and county of moray see form 395 for details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0