OPEN ACCOUNTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | OPEN ACCOUNTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02561244 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di OPEN ACCOUNTS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova OPEN ACCOUNTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di OPEN ACCOUNTS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| OPENAGE LIMITED | 14 ago 1991 | 14 ago 1991 |
| WORTHFORT LIMITED | 22 nov 1990 | 22 nov 1990 |
Quali sono gli ultimi bilanci di OPEN ACCOUNTS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 28 feb 2015 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per OPEN ACCOUNTS LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per OPEN ACCOUNTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2015 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul David Gibson come amministratore in data 09 set 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Gordon James Wilson come amministratore in data 09 set 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Vinodka Murria come amministratore in data 18 mag 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Barbara Ann Firth come amministratore in data 31 mar 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ms Vinodka Murria il 06 dic 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 nov 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2014 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 nov 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2013 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Barbara Ann Firth il 11 dic 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 nov 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 29 feb 2012 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul David Gibson il 06 set 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 nov 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2011 | 7 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Hilary Lowe come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Hilary Anne Lowe come segretario | 3 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Gibson come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Harry Thompson come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 nov 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di OPEN ACCOUNTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON, Gordon James | Amministratore | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey | United Kingdom | British | 200853210001 | |||||
| GIBSON, Paul David | Segretario | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey | British | 192439290001 | ||||||
| JANES, Paul Nicholas | Segretario | 12 Lister Drive NN4 9XE Northampton Northamptonshire | British | 24280810002 | ||||||
| LINCOLN, Jeremy James Passmore | Segretario | The Mill House West Farndon NN11 3TX Daventry Northamptonshire | British | 77671560001 | ||||||
| LOWE, Hilary Anne | Segretario | Portsmouth Road KT11 3HQ Cobham Munro House Surrey | British | 159477980001 | ||||||
| WILLIAMS, Shirley Ann | Segretario | Paddocks View 15 Newland Street LE16 8LW Braybrooke Mkt Harborough | British | 32807350001 | ||||||
| BRACKEN, Jennifer Mary | Amministratore | 6 Cave Close Cawston CV22 7GL Rugby Warwickshire | England | British | 64931860003 | |||||
| BUSHELL, Stephen | Amministratore | 23 Isham Close NN2 7AQ Northampton Northamptonshire | British | 64931820001 | ||||||
| COOK, David Anthony | Amministratore | Brailes Hill House Upper Brailes OX15 5AT Banbury | England | British | 28576840003 | |||||
| COULSON, Richard John | Amministratore | New Farm Fawsley NN11 3BT Daventry Northamptonshire | British | 18833330001 | ||||||
| DAVIS, James Richard | Amministratore | Church Farm View LE12 Osgathorpe Leicestershire | British | 60399700001 | ||||||
| FIRTH, Barbara Ann | Amministratore | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey | United Kingdom | British | 73934790009 | |||||
| FROST, Davey | Amministratore | 21 Marriotts Road Long Buckby NN6 7QY Northampton Northamptonshire | England | English | 17000570001 | |||||
| GIBSON, Paul David | Amministratore | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey | United Kingdom | British | 192439290001 | |||||
| JANES, Paul Nicholas | Amministratore | 12 Lister Drive NN4 9XE Northampton Northamptonshire | England | British | 24280810002 | |||||
| MURRIA, Vinodka | Amministratore | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey | England | British | 57998050007 | |||||
| THOMPSON, Mark Harry | Amministratore | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey | United Kingdom | British | 156095450001 | |||||
| TIMOTHY, Fiona Maria | Amministratore | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey | England | British | 161343370001 | |||||
| WILLIAMS, Shirley Ann | Amministratore | 29 The Woodlands LE16 7BW Market Harborough Leicestershire | British | 32807350002 |
OPEN ACCOUNTS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 07 mar 2007 Consegnato il 09 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 07 set 2004 Consegnato il 11 set 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The f/h property k/a the white house church walk daventry northampton NN11 4BL t/n NN158704. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 07 set 2004 Consegnato il 11 set 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 24 feb 1992 Consegnato il 06 mar 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0