OPEN ACCOUNTS LIMITED

OPEN ACCOUNTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOPEN ACCOUNTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02561244
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OPEN ACCOUNTS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova OPEN ACCOUNTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OPEN ACCOUNTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    OPENAGE LIMITED14 ago 199114 ago 1991
    WORTHFORT LIMITED22 nov 199022 nov 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di OPEN ACCOUNTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2015

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per OPEN ACCOUNTS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per OPEN ACCOUNTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2015

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Paul David Gibson come amministratore in data 09 set 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Gordon James Wilson come amministratore in data 09 set 2015

    2 pagineAP01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Vinodka Murria come amministratore in data 18 mag 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Barbara Ann Firth come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Vinodka Murria il 06 dic 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 22 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 dic 2014

    Stato del capitale al 16 dic 2014

    • Capitale: GBP 259,859
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2014

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 nov 2013

    Stato del capitale al 26 nov 2013

    • Capitale: GBP 259,859
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2013

    7 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Barbara Ann Firth il 11 dic 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 22 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 feb 2012

    7 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul David Gibson il 06 set 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 22 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2011

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    Cessazione della carica di Hilary Lowe come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Hilary Anne Lowe come segretario

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di Paul Gibson come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Mark Harry Thompson come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 22 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di OPEN ACCOUNTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILSON, Gordon James
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish200853210001
    GIBSON, Paul David
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Segretario
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    British192439290001
    JANES, Paul Nicholas
    12 Lister Drive
    NN4 9XE Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    12 Lister Drive
    NN4 9XE Northampton
    Northamptonshire
    British24280810002
    LINCOLN, Jeremy James Passmore
    The Mill House
    West Farndon
    NN11 3TX Daventry
    Northamptonshire
    Segretario
    The Mill House
    West Farndon
    NN11 3TX Daventry
    Northamptonshire
    British77671560001
    LOWE, Hilary Anne
    Portsmouth Road
    KT11 3HQ Cobham
    Munro House
    Surrey
    Segretario
    Portsmouth Road
    KT11 3HQ Cobham
    Munro House
    Surrey
    British159477980001
    WILLIAMS, Shirley Ann
    Paddocks View
    15 Newland Street
    LE16 8LW Braybrooke
    Mkt Harborough
    Segretario
    Paddocks View
    15 Newland Street
    LE16 8LW Braybrooke
    Mkt Harborough
    British32807350001
    BRACKEN, Jennifer Mary
    6 Cave Close
    Cawston
    CV22 7GL Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    6 Cave Close
    Cawston
    CV22 7GL Rugby
    Warwickshire
    EnglandBritish64931860003
    BUSHELL, Stephen
    23 Isham Close
    NN2 7AQ Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    23 Isham Close
    NN2 7AQ Northampton
    Northamptonshire
    British64931820001
    COOK, David Anthony
    Brailes Hill House
    Upper Brailes
    OX15 5AT Banbury
    Amministratore
    Brailes Hill House
    Upper Brailes
    OX15 5AT Banbury
    EnglandBritish28576840003
    COULSON, Richard John
    New Farm
    Fawsley
    NN11 3BT Daventry
    Northamptonshire
    Amministratore
    New Farm
    Fawsley
    NN11 3BT Daventry
    Northamptonshire
    British18833330001
    DAVIS, James Richard
    Church Farm View
    LE12 Osgathorpe
    Leicestershire
    Amministratore
    Church Farm View
    LE12 Osgathorpe
    Leicestershire
    British60399700001
    FIRTH, Barbara Ann
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish73934790009
    FROST, Davey
    21 Marriotts Road
    Long Buckby
    NN6 7QY Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    21 Marriotts Road
    Long Buckby
    NN6 7QY Northampton
    Northamptonshire
    EnglandEnglish17000570001
    GIBSON, Paul David
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish192439290001
    JANES, Paul Nicholas
    12 Lister Drive
    NN4 9XE Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    12 Lister Drive
    NN4 9XE Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish24280810002
    MURRIA, Vinodka
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    EnglandBritish57998050007
    THOMPSON, Mark Harry
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish156095450001
    TIMOTHY, Fiona Maria
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    EnglandBritish161343370001
    WILLIAMS, Shirley Ann
    29 The Woodlands
    LE16 7BW Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    29 The Woodlands
    LE16 7BW Market Harborough
    Leicestershire
    British32807350002

    OPEN ACCOUNTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 07 mar 2007
    Consegnato il 09 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 07 set 2004
    Consegnato il 11 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a the white house church walk daventry northampton NN11 4BL t/n NN158704. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 set 2004
    Consegnato il 11 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 24 feb 1992
    Consegnato il 06 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0