ASCENT PUBLISHING LIMITED

ASCENT PUBLISHING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàASCENT PUBLISHING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02561341
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ASCENT PUBLISHING LIMITED?

    • Edizione di riviste per il grande pubblico e per le imprese (58142) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova ASCENT PUBLISHING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Quay House
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Somerset
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ASCENT PUBLISHING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HECTOPLEX LIMITED22 nov 199022 nov 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di ASCENT PUBLISHING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per ASCENT PUBLISHING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Nomina di Mr Oliver James Foster come amministratore in data 30 mag 2023

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr David John Bateson come segretario in data 31 mar 2023

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr David John Bateson come amministratore in data 31 mar 2023

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Anne Steele come segretario in data 31 mar 2023

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Zillah Ellen Byng-Thorne come amministratore in data 31 mar 2023

    1 pagineTM01

    Nomina di Robert William Tompkins come amministratore in data 18 dic 2022

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 30 set 2021

    10 pagineAA

    legacy

    182 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Zillah Ellen Byng-Thorne il 17 feb 2022

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Penelope Anne Ladkin-Brand come amministratore in data 01 nov 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Rachel Bernadette Addison come amministratore in data 30 ott 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Andrew Robbins come amministratore in data 16 lug 2021

    1 pagineTM01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 30 set 2020

    10 pagineAA

    legacy

    172 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Stato del capitale al 15 feb 2021

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di ASCENT PUBLISHING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BATESON, David John
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    Segretario
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    307810200001
    BATESON, David John
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    Amministratore
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    EnglandBritishCompany Secretary/Director259939150001
    FOSTER, Oliver James
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    Amministratore
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    EnglandBritishCompany Director280151610001
    LADKIN-BRAND, Penelope Anne
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    Amministratore
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    EnglandBritishCompany Director288978380001
    TOMPKINS, Robert William
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    Amministratore
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    EnglandBritishCompany Director303888570001
    BATY, Claire Vanessa
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    Segretario
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    172523620001
    BATY, Claire Vanessa
    50 Poland Street
    W1F 7AX London
    St Giles House
    United Kingdom
    Segretario
    50 Poland Street
    W1F 7AX London
    St Giles House
    United Kingdom
    British154576220001
    BRANKIN, Grainne
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    Segretario
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    189923220001
    JONES, Matthew David Alexander
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    Segretario
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    184773520001
    KEITH, Philippa Anne
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    Segretario
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    163452200001
    LADKIN-BRAND, Penelope Anne
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    Segretario
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    236311250001
    MAW, Timothy Ian
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    Segretario
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    264854790001
    RAW, John Whitfield
    Shoreham House
    Ewhurst Green
    TN32 5RE Robertsbridge
    East Sussex
    Segretario
    Shoreham House
    Ewhurst Green
    TN32 5RE Robertsbridge
    East Sussex
    BritishChartered Accountant4765070001
    ROBERTS, Ian Paul Hartin
    50 Poland Street
    W1F 7AX London
    St Giles House
    United Kingdom
    Segretario
    50 Poland Street
    W1F 7AX London
    St Giles House
    United Kingdom
    British73221640002
    STEELE, Anne
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    Segretario
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    273245050001
    ADDISON, Rachel Bernadette
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    Amministratore
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    United KingdomBritishDirector250816460001
    BYNG-THORNE, Zillah Ellen
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    Amministratore
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    EnglandBritishChief Executive182681640004
    COATES, Robin
    60 Tonsley Hill
    SW18 1BD London
    Amministratore
    60 Tonsley Hill
    SW18 1BD London
    United KingdomBritishPublisher31946410002
    EVANS, Andrew
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    Amministratore
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector146626820001
    FOSTER, Oliver James
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    Amministratore
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    EnglandBritishFinancial Controller199325990001
    HARGREAVES, Mark John
    Flat 1 7 Castletown Road
    West Kensington
    W14 9HE London
    Amministratore
    Flat 1 7 Castletown Road
    West Kensington
    W14 9HE London
    BritishPublishing Director45894290001
    HARRIS, Peter Jonathan
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    Amministratore
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director40917640001
    HARRIS, Peter Andrew
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    Amministratore
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    BritishEditorial Director25488840002
    JOHNSTON, Philip
    Mews Cottage
    The Close
    CM6 1EW Great Dunmow
    Essex
    Amministratore
    Mews Cottage
    The Close
    CM6 1EW Great Dunmow
    Essex
    BritishPublishing Director65914690001
    KERSWELL, Mark Henry
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    Amministratore
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant82609620003
    LADKIN-BRAND, Penelope Anne
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    Amministratore
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer207597270001
    LALLY, Michael
    50 Poland Street
    W1F 7AX London
    St Giles House
    United Kingdom
    Amministratore
    50 Poland Street
    W1F 7AX London
    St Giles House
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director57649530002
    MAW, Timothy Ian
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    Amministratore
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    EnglandBritishCompany Secretary/Director101514930002
    MUKERJI, Swagatam
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    Amministratore
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Financial Officer 121222440001
    NOBLE, Nicholas
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    Amministratore
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    BritishExhibitions Director105923690001
    RAPLEY, Nicholas
    17 Hampstead Lane
    Highgate
    N6 4RT London
    Amministratore
    17 Hampstead Lane
    Highgate
    N6 4RT London
    BritishPublishing42330120001
    RAW, John Whitfield
    Shoreham House
    Ewhurst Green
    TN32 5RE Robertsbridge
    East Sussex
    Amministratore
    Shoreham House
    Ewhurst Green
    TN32 5RE Robertsbridge
    East Sussex
    United KingdomBritishChartered Accountant4765070001
    ROBBINS, Michael Andrew
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    Amministratore
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Somerset
    England
    EnglandBritishChartered Accountant268060140001
    ROGERS, Derek Walter
    50 Poland Street
    W1F 7AX London
    St Giles House
    United Kingdom
    Amministratore
    50 Poland Street
    W1F 7AX London
    St Giles House
    United Kingdom
    BritishSales Director3044750001
    SHARMAN, Howard
    10 Gatcombe Road
    N19 4PT London
    Amministratore
    10 Gatcombe Road
    N19 4PT London
    EnglandBritishPublisher31946390002

    Chi sono le persone con controllo significativo di ASCENT PUBLISHING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    06 apr 2016
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2008885
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ASCENT PUBLISHING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 03 apr 2018
    Consegnato il 04 apr 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Not applicable.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 04 apr 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 01 ago 2017
    Consegnato il 07 ago 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Not applicable.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 12 giu 2015
    Consegnato il 16 giu 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 16 giu 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 03 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 14 dic 2001
    Consegnato il 19 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 04 ago 1998
    Consegnato il 11 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the agent,arranger or the banks (as defined) under a facilities agreement or under any overdraft facilities or under the interest rate protection agreements (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • First Union National Bank
    Transazioni
    • 11 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 lug 1991
    Consegnato il 06 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 15 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0