CARLIOL PROPERTIES LIMITED
Panoramica
Nome della società | CARLIOL PROPERTIES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02562005 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CARLIOL PROPERTIES LIMITED?
- Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi
Dove si trova CARLIOL PROPERTIES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Unex House Church Lane Stetchworth CB8 9TN Newmarket Suffolk |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CARLIOL PROPERTIES LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
PLUSRETURN LIMITED | 23 nov 1990 | 23 nov 1990 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CARLIOL PROPERTIES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per CARLIOL PROPERTIES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anthony James Alexander Helme come amministratore in data 24 feb 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Andrew Page come amministratore in data 24 feb 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2017 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 nov 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2016 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Robert John Brown come segretario in data 29 lug 2016 | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Andrew John Page come segretario in data 29 lug 2016 | 3 pagine | AP03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2015 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 nov 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2014 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 nov 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2013 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2012 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 nov 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 nov 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2011 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2010 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 nov 2010 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2009 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Robert John Brown come segretario | 3 pagine | AP03 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CARLIOL PROPERTIES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGE, Andrew John | Segretario | Church Lane Stetchworth CB8 9TN Newmarket Unex House Suffolk | 211854160001 | |||||||
PAGE, Andrew John | Amministratore | Unex House Church Lane Stetchworth CB8 9TN Newmarket Suffolk | England | British | Accountant | 243791130001 | ||||
BROWN, Robert John | Segretario | Church Lane Stetchworth CB8 9TN Newmarket Unex House Suffolk | British | 147818750001 | ||||||
CROWE, John | Segretario | 93 Jesmond Park West NE7 7BY Newcastle Upon Tyne | British | 33656900001 | ||||||
FOLEY, Nicholas John | Segretario | St Benets Northfield Avenue HA5 1AR Pinner Middlesex | British | 6020290001 | ||||||
GIDNEY, Douglas George | Segretario | Hawksbury Bury Road Hargrave IP29 5HP Bury St Edmunds Suffolk | British | Chartered Accountant | 56305750001 | |||||
WHELAN, Joanne | Segretario | 26 Trinity Courtyard St Peters Basin NE6 1TS Newcastle Upon Tyne | British | 37635990001 | ||||||
HELME, Anthony James Alexander | Amministratore | Newlands Cottage Widdington CB11 3SN Saffron Walden Essex | United Kingdom | British | Director | 11617880001 | ||||
MINTER, Michael Joseph | Amministratore | Astley House Astley Drive Whitley Bay NE26 4AE North Tyneside Tyne And Wear | British | Company Director | 21613460001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CARLIOL PROPERTIES LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
---|---|---|---|
Mr Anthony James Alexander Helme | 06 apr 2016 | Unex House Church Lane Stetchworth CB8 9TN Newmarket Suffolk | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||
Natura del controllo
|
CARLIOL PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Supplemental mortgage | Creato il 29 lug 1992 Consegnato il 30 lug 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari F/H- land registered under t/n-TY161384. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 19 apr 1991 Consegnato il 30 apr 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £4,500,000 and all other monies due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 19/04/1991 | |
Brevi particolari Legal mortgage over f/hold land and buildings at 34/40 grey street and the southeast side of market lane, newcastle t/no ty 21331. (see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & charge | Creato il 19 apr 1991 Consegnato il 30 apr 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from gainsborough property holdings limited: to the chargee on any account whatsover, under the terms of a facility letter dated 14/6/90. | |
Brevi particolari All of the company's right title and interest in and to the deposit account held with the lender. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0