SHOREPAC LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSHOREPAC LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02562324
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SHOREPAC LIMITED?

    • (2121) /

    Dove si trova SHOREPAC LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Beech House Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Berkshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di SHOREPAC LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per SHOREPAC LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di Carolyn Cattermole come amministratore

    1 pagineTM01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 10 mag 2011

    • Capitale: GBP 10
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 17 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2010

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Alexander Manisty come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Anthony Thorne come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Miles William Roberts come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2009

    7 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Alexander Manisty il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Dr Anthony David Thorne il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Stephen William Dryden il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Carolyn Tracy Cattermole il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Anne Steele il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    Chi sono gli amministratori di SHOREPAC LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    STEELE, Anne
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    British77624110001
    DRYDEN, Stephen William
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish47821400004
    ROBERTS, Miles William
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish57880630003
    BALL, Janet Vivien
    The Beeches St Marys Lane
    LN11 0DU Louth
    Lincolnshire
    Segretario
    The Beeches St Marys Lane
    LN11 0DU Louth
    Lincolnshire
    British22587470002
    FENSOME, Richard James
    Ravenscroft
    15 Fulmer Drive
    SL9 7HH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Segretario
    Ravenscroft
    15 Fulmer Drive
    SL9 7HH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British84096960001
    ULYATT, Ann
    Raybecca
    Main Road Thimbleby
    LN9 5RB Horncastle
    Lincolnshire
    Segretario
    Raybecca
    Main Road Thimbleby
    LN9 5RB Horncastle
    Lincolnshire
    British20885500001
    BALL, Janet Vivien
    The Beeches St Marys Lane
    LN11 0DU Louth
    Lincolnshire
    Amministratore
    The Beeches St Marys Lane
    LN11 0DU Louth
    Lincolnshire
    British22587470002
    BALL, Kenneth William
    The Beeches St Marys Lane
    LN11 0DU Louth
    Lincolnshire
    Amministratore
    The Beeches St Marys Lane
    LN11 0DU Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritish4246970002
    BLACKFORD, Christopher Fitzgerald
    .
    Dovecote Church Road, Walpole St Peter
    PE14 7NS Wisbech
    Amministratore
    .
    Dovecote Church Road, Walpole St Peter
    PE14 7NS Wisbech
    British61034050002
    BROUGHTON, Geoffrey
    17 St James View
    LN11 9XY Louth
    Lincolnshire
    Amministratore
    17 St James View
    LN11 9XY Louth
    Lincolnshire
    British45727470002
    BUTTON, Graham Christopher
    1 Harmston Park Avenue
    LN5 9GF Lincoln
    Lincolnshire
    Amministratore
    1 Harmston Park Avenue
    LN5 9GF Lincoln
    Lincolnshire
    British77558190002
    CATTERMOLE, Carolyn Tracy
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish53026290002
    GOULSBRA, Andrew
    4 Alfred Smith Way
    Legbourne
    LN11 8NE Louth
    Lincolnshire
    Amministratore
    4 Alfred Smith Way
    Legbourne
    LN11 8NE Louth
    Lincolnshire
    British45727460001
    LOWE, John Arthur
    14 North Park Road
    LS8 1JD Leeds
    Amministratore
    14 North Park Road
    LS8 1JD Leeds
    British51404250001
    MANISTY, Alexander
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish72427180001
    MORRIS, Gavin Mathew
    20 Argyll Road
    W8 7BG London
    Amministratore
    20 Argyll Road
    W8 7BG London
    EnglandBritish16228990001
    THORNE, Anthony David
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish40130640001
    ULYATT, Ann
    Raybecca
    Main Road Thimbleby
    LN9 5RB Horncastle
    Lincolnshire
    Amministratore
    Raybecca
    Main Road Thimbleby
    LN9 5RB Horncastle
    Lincolnshire
    British20885500001

    SHOREPAC LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    An omnibus guarantee and set-off agreement dated
    Creato il 22 mar 2004
    Consegnato il 25 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling or in a currency or currencies other than sterling;.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 20 march 2002
    Creato il 18 mag 2003
    Consegnato il 30 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 05 apr 1993
    Consegnato il 08 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 08 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 apr 1993
    Consegnato il 09 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Factory premises at warwick road fairfield industrial estate louth lincs and goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 09 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0