ASHLEY HOUSE PLC.
Panoramica
| Nome della società | ASHLEY HOUSE PLC. |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società per azioni |
| Numero di società | 02563627 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ASHLEY HOUSE PLC.?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
- Attività di consulenza gestionale diverse dalla gestione finanziaria (70229) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
- Attività di architettura (71111) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova ASHLEY HOUSE PLC.?
| Indirizzo della sede legale | C/O Begbies Traynor Toronto Square Toronto Street LS1 2HJ Leeds England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ASHLEY HOUSE PLC.?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ASHLEY HOUSE INTERBUILD PLC | 14 gen 1994 | 14 gen 1994 |
| ASHLEY HOUSE INTERIORS LIMITED | 10 mag 1991 | 10 mag 1991 |
| LARGECHANCE LIMITED | 29 nov 1990 | 29 nov 1990 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ASHLEY HOUSE PLC.?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 apr 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per ASHLEY HOUSE PLC.?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||
Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione | 26 pagine | AM23 | ||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore | 23 pagine | AM10 | ||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore | 24 pagine | AM10 | ||
Soddisfazione dell'onere 025636270014 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione | 3 pagine | AM19 | ||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore | 24 pagine | AM10 | ||
Notifica di approvazione tacita delle proposte | 3 pagine | AM06 | ||
Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA | 16 pagine | AM02 | ||
Dichiarazione della proposta dell'amministratore | 49 pagine | AM03 | ||
Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione | 21 pagine | CVA4 | ||
Nomina di un amministratore | 3 pagine | AM01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 168 Birmingham Road Shenstone Wood End Lichfield WS14 0NX England a C/O Begbies Traynor Toronto Square Toronto Street Leeds LS1 2HJ in data 10 dic 2020 | 1 pagine | AD01 | ||
Cessazione della carica di Jonathan Holmes come amministratore in data 30 nov 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 set 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 168 Birmingham Road Shenstone Wood End Lichfield WS14 0NX England a 168 Birmingham Road Shenstone Wood End Lichfield WS14 0NX in data 11 nov 2020 | 1 pagine | AD01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Begbies Traynor Toronto Square Toronto Street Leeds LS1 2HJ England a 168 Birmingham Road Shenstone Wood End Lichfield WS14 0NX in data 11 nov 2020 | 1 pagine | AD01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Unit 1, Barnes Wallis Court Wellington Road Cressex Business Park High Wycombe Buckinghamshire HP12 3PS England a C/O Begbies Traynor Toronto Square Toronto Street Leeds LS1 2HJ in data 22 set 2020 | 1 pagine | AD01 | ||
Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore | 13 pagine | CVA1 | ||
Cessazione della carica di Andrew John Willetts come amministratore in data 30 mar 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Christopher Peter Lyons come amministratore in data 30 mar 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Adrian Wright come amministratore in data 11 dic 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
**Parte della proprietà o attività è stata liberata dall'onere ** 7 | 5 pagine | MR05 | ||
**Parte della proprietà o attività è stata liberata dall'onere ** 025636270013 | 5 pagine | MR05 | ||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 30 ott 2019
| 3 pagine | SH01 | ||
Chi sono gli amministratori di ASHLEY HOUSE PLC.?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATHAWAY, James Andrew John | Segretario | Toronto Square Toronto Street LS1 2HJ Leeds C/O Begbies Traynor England | 243715060001 | |||||||
| HATHAWAY, James Andrew John | Amministratore | Toronto Square Toronto Street LS1 2HJ Leeds C/O Begbies Traynor England | England | British | 129270110001 | |||||
| WALTERS, Antony John | Amministratore | Toronto Square Toronto Street LS1 2HJ Leeds C/O Begbies Traynor England | England | British | 118049310003 | |||||
| WRIGHT, Adrian | Amministratore | Toronto Square Toronto Street LS1 2HJ Leeds C/O Begbies Traynor England | England | British | 179203000002 | |||||
| BAILEY, David Charles | Segretario | Cemlyn Ton Road Llangybi NP15 1PA Usk Monmouthshire | British | 95338890001 | ||||||
| CANE, James Andrew | Segretario | 26 Bellevue Road SW13 0BJ London | British | 75312800001 | ||||||
| HENRY, Dominick Hugh Mitcheson | Segretario | Penny Farm Holwell DT9 5LF Sherborne Dorset | British | 98974710001 | ||||||
| HOLMES, George Edward, Mr. | Segretario | Number 1 Hamilton Way Farnham Common SL2 3TT Slough Berkshire | British | 119933900001 | ||||||
| MINION, Kate Elizabeth | Segretario | 12 Walnut Drive Bletchley MK2 2JA Milton Keynes Buckinghamshire | British | 69215500001 | ||||||
| RONALDSON, Stephen Frank | Segretario | 221 Sheen Lane East Sheen SW14 8LE London | British | 1772340003 | ||||||
| ARNOLD FORSTER, Jake | Amministratore | Pages Lane N10 1PU London 21 | British | 123415220002 | ||||||
| BURTON, Anthony David | Amministratore | Beechwood House Halls Hole Road TN2 4RD Tunbridge Wells Kent | Uk | British | 3513950001 | |||||
| CANE, James Andrew | Amministratore | 26 Bellevue Road SW13 0BJ London | England | British | 75312800001 | |||||
| COGHLAN, John Bernard | Amministratore | Southview Warren Park Coombe Hill KT2 7HX Kingston Upon Thames | Uk | Irish | 188501300004 | |||||
| COOK, Allan Cameron | Amministratore | 72 Lavenham Road SW18 5HE London Greater London | United Kingdom | British | 125405420001 | |||||
| CROXFORD, Nigel Keith | Amministratore | Tanglewood 57 Summerleys Road HP27 9PZ Princes Risborough Buckinghamshire | England | British | 40314050003 | |||||
| DARCH, Richard | Amministratore | Lancaster Road Cressex Business Park HP12 3YZ High Wycombe 6 Cliveden Office Village | England | British | 88696540001 | |||||
| ELLEN, Simon Tudor | Amministratore | Sbj Ltd 100 Whitechapel Road E1 1JG London | United Kingdom | British | 111926600001 | |||||
| FROST, Giles James | Amministratore | Gorst Road SW11 6JB London 21 | United Kingdom | British | 81910810001 | |||||
| GIBSON, Andrew | Amministratore | Bonehouse Barn Newbiggin Hall Farm Carleton CA4 0AJ Carlisle Cumbria | United Kingdom | British | 127928730001 | |||||
| GRAY, Steven William | Amministratore | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court Warwickshire United Kingdom | England | British | 130215290001 | |||||
| GUNN, John Humphrey | Amministratore | 23 Edwardes Square W8 6HE London | England | British | 705110002 | |||||
| HARTSHORNE, David John Morice | Amministratore | Lancaster Road Cressex Business Park HP12 3YZ High Wycombe 6 Cliveden Office Village | England | British | 87382740001 | |||||
| HENRY, Dominick Hugh Mitcheson | Amministratore | Penny Farm Holwell DT9 5LF Sherborne Dorset | British | 98974710001 | ||||||
| HOLMES, George Edward, Mr. | Amministratore | Number 1 Hamilton Way Farnham Common SL2 3TT Slough Berkshire | England | British | 119933900001 | |||||
| HOLMES, Jonathan | Amministratore | Birmingham Road Shenstone Wood End WS14 0NX Lichfield 168 England | Northern Ireland | British | 107261280003 | |||||
| HOLMES, Mary | Amministratore | 4 Ingleglen Farnham Common SL2 3QA Slough Berkshire | British | 24994830002 | ||||||
| LYONS, Christopher Peter | Amministratore | Wellington Road Cressex Business Park HP12 3PS High Wycombe Unit 1, Barnes Wallis Court Buckinghamshire England | England | British | 67480620001 | |||||
| MINION, Stephen Gregory | Amministratore | Wellington Road Cressex Business Park HP12 3PS High Wycombe Unit 1, Barnes Wallis Court Buckinghamshire England | United Kingdom | British | 201775990001 | |||||
| MOSLEY, Gail | Amministratore | Cresset House 8 Churchill Gate OX20 1UP Woodstock Oxfordshire | British | 15989410004 | ||||||
| MOSLEY, Geoffrey Clive | Amministratore | Thatchings High Street OX10 6HQ Ewelme Oxfordshire | British | 75109200001 | ||||||
| MOY, John Lewington | Amministratore | Wellington Road Cressex Business Park HP12 3PS High Wycombe Unit 1, Barnes Wallis Court Buckinghamshire England | England | Uk | 193608450001 | |||||
| WALKER, Bruce Layland | Amministratore | 59 Chiswick Staithe Hartington Road W4 3TP London | United Kingdom | British | 82714410001 | |||||
| WARNER, Richard Edward Lubbock | Amministratore | The Old Guildhall The Street, Monks Eleigh IP7 7AU Ipswich Suffolk | England | British | 49287690004 | |||||
| WELLS, William Henry Weston, Sir | Amministratore | Box Cottage Sudbrook Lane TW10 7AT Petersham Surrey | England | British | 50963820001 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per ASHLEY HOUSE PLC.?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 24 lug 2017 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
ASHLEY HOUSE PLC. ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 27 ago 2019 Consegnato il 29 ago 2019 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione All of the shares in the share capital of romsey extra care limited (other than those held by the lender). Contiene un'ipotesi negativa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 12 feb 2018 Consegnato il 15 feb 2018 | In corso | ||
Debitore che agisce come trustee nudo: Sì L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 04 lug 2017 Consegnato il 25 lug 2017 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 25 giu 2014 Consegnato il 26 giu 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 06 feb 2014 Consegnato il 20 feb 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assignment and charge | Creato il 20 dic 2010 Consegnato il 30 dic 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All its right in title to and interest in the agreement dated 16 march 2010 see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Share charge | Creato il 20 nov 2009 Consegnato il 30 nov 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Full title guarantee all right title and interest all related rights see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture deed | Creato il 11 set 2008 Consegnato il 12 set 2008 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Third party assignation of single contract | Creato il 06 ott 2005 Consegnato il 08 ott 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from soho road health plaza limited (the "borrower") to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All rights title and interest arising out of in to and under the guarantee dated 10 august 2005. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 28 ago 2003 Consegnato il 05 set 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £250,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari A floating charge over the assets of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 13 giu 2000 Consegnato il 15 giu 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The property at chalfont hall chalfont st peter buckinghamshire. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage deed | Creato il 29 apr 1999 Consegnato il 30 apr 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Site at fairfield leys coldharbour farm aylesbury. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 31 lug 1996 Consegnato il 08 ago 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal and floating charge | Creato il 10 nov 1995 Consegnato il 23 nov 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito 386,000 and all other sums due from the company to the chargee under this charge or otherwise | |
Brevi particolari 9 kingfisher court,281/295 farnham rd,slough,berkshire............t/no. Bk 281821..........see form 395. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
ASHLEY HOUSE PLC. ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA) |
| ||||||||||||||||||||||
| 2 |
| In amministrazione |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0