ASHLEY HOUSE PLC.

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàASHLEY HOUSE PLC.
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 02563627
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ASHLEY HOUSE PLC.?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
    • Attività di consulenza gestionale diverse dalla gestione finanziaria (70229) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
    • Attività di architettura (71111) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ASHLEY HOUSE PLC.?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Begbies Traynor Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ASHLEY HOUSE PLC.?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ASHLEY HOUSE INTERBUILD PLC14 gen 199414 gen 1994
    ASHLEY HOUSE INTERIORS LIMITED10 mag 199110 mag 1991
    LARGECHANCE LIMITED29 nov 199029 nov 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di ASHLEY HOUSE PLC.?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per ASHLEY HOUSE PLC.?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    26 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    23 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    24 pagineAM10

    Soddisfazione dell'onere 025636270014 in pieno

    1 pagineMR04

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    24 pagineAM10

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    3 pagineAM06

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    16 pagineAM02

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    49 pagineAM03

    Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione

    21 pagineCVA4

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 168 Birmingham Road Shenstone Wood End Lichfield WS14 0NX England a C/O Begbies Traynor Toronto Square Toronto Street Leeds LS1 2HJ in data 10 dic 2020

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Jonathan Holmes come amministratore in data 30 nov 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 set 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 168 Birmingham Road Shenstone Wood End Lichfield WS14 0NX England a 168 Birmingham Road Shenstone Wood End Lichfield WS14 0NX in data 11 nov 2020

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Begbies Traynor Toronto Square Toronto Street Leeds LS1 2HJ England a 168 Birmingham Road Shenstone Wood End Lichfield WS14 0NX in data 11 nov 2020

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 1, Barnes Wallis Court Wellington Road Cressex Business Park High Wycombe Buckinghamshire HP12 3PS England a C/O Begbies Traynor Toronto Square Toronto Street Leeds LS1 2HJ in data 22 set 2020

    1 pagineAD01

    Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore

    13 pagineCVA1

    Cessazione della carica di Andrew John Willetts come amministratore in data 30 mar 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christopher Peter Lyons come amministratore in data 30 mar 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Adrian Wright come amministratore in data 11 dic 2019

    2 pagineAP01

    **Parte della proprietà o attività è stata liberata dall'onere ** 7

    5 pagineMR05

    **Parte della proprietà o attività è stata liberata dall'onere ** 025636270013

    5 pagineMR05

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 30 ott 2019

    • Capitale: GBP 612,514.57
    3 pagineSH01

    Chi sono gli amministratori di ASHLEY HOUSE PLC.?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HATHAWAY, James Andrew John
    Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    C/O Begbies Traynor
    England
    Segretario
    Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    C/O Begbies Traynor
    England
    243715060001
    HATHAWAY, James Andrew John
    Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    C/O Begbies Traynor
    England
    Amministratore
    Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    C/O Begbies Traynor
    England
    EnglandBritish129270110001
    WALTERS, Antony John
    Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    C/O Begbies Traynor
    England
    Amministratore
    Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    C/O Begbies Traynor
    England
    EnglandBritish118049310003
    WRIGHT, Adrian
    Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    C/O Begbies Traynor
    England
    Amministratore
    Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    C/O Begbies Traynor
    England
    EnglandBritish179203000002
    BAILEY, David Charles
    Cemlyn
    Ton Road Llangybi
    NP15 1PA Usk
    Monmouthshire
    Segretario
    Cemlyn
    Ton Road Llangybi
    NP15 1PA Usk
    Monmouthshire
    British95338890001
    CANE, James Andrew
    26 Bellevue Road
    SW13 0BJ London
    Segretario
    26 Bellevue Road
    SW13 0BJ London
    British75312800001
    HENRY, Dominick Hugh Mitcheson
    Penny Farm
    Holwell
    DT9 5LF Sherborne
    Dorset
    Segretario
    Penny Farm
    Holwell
    DT9 5LF Sherborne
    Dorset
    British98974710001
    HOLMES, George Edward, Mr.
    Number 1 Hamilton Way
    Farnham Common
    SL2 3TT Slough
    Berkshire
    Segretario
    Number 1 Hamilton Way
    Farnham Common
    SL2 3TT Slough
    Berkshire
    British119933900001
    MINION, Kate Elizabeth
    12 Walnut Drive
    Bletchley
    MK2 2JA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    12 Walnut Drive
    Bletchley
    MK2 2JA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British69215500001
    RONALDSON, Stephen Frank
    221 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8LE London
    Segretario
    221 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8LE London
    British1772340003
    ARNOLD FORSTER, Jake
    Pages Lane
    N10 1PU London
    21
    Amministratore
    Pages Lane
    N10 1PU London
    21
    British123415220002
    BURTON, Anthony David
    Beechwood House Halls Hole Road
    TN2 4RD Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Beechwood House Halls Hole Road
    TN2 4RD Tunbridge Wells
    Kent
    UkBritish3513950001
    CANE, James Andrew
    26 Bellevue Road
    SW13 0BJ London
    Amministratore
    26 Bellevue Road
    SW13 0BJ London
    EnglandBritish75312800001
    COGHLAN, John Bernard
    Southview Warren Park
    Coombe Hill
    KT2 7HX Kingston Upon Thames
    Amministratore
    Southview Warren Park
    Coombe Hill
    KT2 7HX Kingston Upon Thames
    UkIrish188501300004
    COOK, Allan Cameron
    72 Lavenham Road
    SW18 5HE London
    Greater London
    Amministratore
    72 Lavenham Road
    SW18 5HE London
    Greater London
    United KingdomBritish125405420001
    CROXFORD, Nigel Keith
    Tanglewood
    57 Summerleys Road
    HP27 9PZ Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Tanglewood
    57 Summerleys Road
    HP27 9PZ Princes Risborough
    Buckinghamshire
    EnglandBritish40314050003
    DARCH, Richard
    Lancaster Road
    Cressex Business Park
    HP12 3YZ High Wycombe
    6 Cliveden Office Village
    Amministratore
    Lancaster Road
    Cressex Business Park
    HP12 3YZ High Wycombe
    6 Cliveden Office Village
    EnglandBritish88696540001
    ELLEN, Simon Tudor
    Sbj Ltd
    100 Whitechapel Road
    E1 1JG London
    Amministratore
    Sbj Ltd
    100 Whitechapel Road
    E1 1JG London
    United KingdomBritish111926600001
    FROST, Giles James
    Gorst Road
    SW11 6JB London
    21
    Amministratore
    Gorst Road
    SW11 6JB London
    21
    United KingdomBritish81910810001
    GIBSON, Andrew
    Bonehouse Barn
    Newbiggin Hall Farm Carleton
    CA4 0AJ Carlisle
    Cumbria
    Amministratore
    Bonehouse Barn
    Newbiggin Hall Farm Carleton
    CA4 0AJ Carlisle
    Cumbria
    United KingdomBritish127928730001
    GRAY, Steven William
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    Warwickshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    Warwickshire
    United Kingdom
    EnglandBritish130215290001
    GUNN, John Humphrey
    23 Edwardes Square
    W8 6HE London
    Amministratore
    23 Edwardes Square
    W8 6HE London
    EnglandBritish705110002
    HARTSHORNE, David John Morice
    Lancaster Road
    Cressex Business Park
    HP12 3YZ High Wycombe
    6 Cliveden Office Village
    Amministratore
    Lancaster Road
    Cressex Business Park
    HP12 3YZ High Wycombe
    6 Cliveden Office Village
    EnglandBritish87382740001
    HENRY, Dominick Hugh Mitcheson
    Penny Farm
    Holwell
    DT9 5LF Sherborne
    Dorset
    Amministratore
    Penny Farm
    Holwell
    DT9 5LF Sherborne
    Dorset
    British98974710001
    HOLMES, George Edward, Mr.
    Number 1 Hamilton Way
    Farnham Common
    SL2 3TT Slough
    Berkshire
    Amministratore
    Number 1 Hamilton Way
    Farnham Common
    SL2 3TT Slough
    Berkshire
    EnglandBritish119933900001
    HOLMES, Jonathan
    Birmingham Road
    Shenstone Wood End
    WS14 0NX Lichfield
    168
    England
    Amministratore
    Birmingham Road
    Shenstone Wood End
    WS14 0NX Lichfield
    168
    England
    Northern IrelandBritish107261280003
    HOLMES, Mary
    4 Ingleglen
    Farnham Common
    SL2 3QA Slough
    Berkshire
    Amministratore
    4 Ingleglen
    Farnham Common
    SL2 3QA Slough
    Berkshire
    British24994830002
    LYONS, Christopher Peter
    Wellington Road
    Cressex Business Park
    HP12 3PS High Wycombe
    Unit 1, Barnes Wallis Court
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    Wellington Road
    Cressex Business Park
    HP12 3PS High Wycombe
    Unit 1, Barnes Wallis Court
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish67480620001
    MINION, Stephen Gregory
    Wellington Road
    Cressex Business Park
    HP12 3PS High Wycombe
    Unit 1, Barnes Wallis Court
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    Wellington Road
    Cressex Business Park
    HP12 3PS High Wycombe
    Unit 1, Barnes Wallis Court
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritish201775990001
    MOSLEY, Gail
    Cresset House
    8 Churchill Gate
    OX20 1UP Woodstock
    Oxfordshire
    Amministratore
    Cresset House
    8 Churchill Gate
    OX20 1UP Woodstock
    Oxfordshire
    British15989410004
    MOSLEY, Geoffrey Clive
    Thatchings
    High Street
    OX10 6HQ Ewelme
    Oxfordshire
    Amministratore
    Thatchings
    High Street
    OX10 6HQ Ewelme
    Oxfordshire
    British75109200001
    MOY, John Lewington
    Wellington Road
    Cressex Business Park
    HP12 3PS High Wycombe
    Unit 1, Barnes Wallis Court
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    Wellington Road
    Cressex Business Park
    HP12 3PS High Wycombe
    Unit 1, Barnes Wallis Court
    Buckinghamshire
    England
    EnglandUk193608450001
    WALKER, Bruce Layland
    59 Chiswick Staithe
    Hartington Road
    W4 3TP London
    Amministratore
    59 Chiswick Staithe
    Hartington Road
    W4 3TP London
    United KingdomBritish82714410001
    WARNER, Richard Edward Lubbock
    The Old Guildhall
    The Street, Monks Eleigh
    IP7 7AU Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    The Old Guildhall
    The Street, Monks Eleigh
    IP7 7AU Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritish49287690004
    WELLS, William Henry Weston, Sir
    Box Cottage
    Sudbrook Lane
    TW10 7AT Petersham
    Surrey
    Amministratore
    Box Cottage
    Sudbrook Lane
    TW10 7AT Petersham
    Surrey
    EnglandBritish50963820001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per ASHLEY HOUSE PLC.?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    24 lug 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    ASHLEY HOUSE PLC. ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 27 ago 2019
    Consegnato il 29 ago 2019
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All of the shares in the share capital of romsey extra care limited (other than those held by the lender).
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Places for People Living + Limited
    Transazioni
    • 29 ago 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 13 dic 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 12 feb 2018
    Consegnato il 15 feb 2018
    In corso
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Invescare Limited
    Transazioni
    • 15 feb 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 03 set 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • 08 feb 2020Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 04 lug 2017
    Consegnato il 25 lug 2017
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Maureen Moy
    Transazioni
    • 25 lug 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 17 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 25 giu 2014
    Consegnato il 26 giu 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rockpool (Security Trustee) Limited
    Transazioni
    • 26 giu 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 06 feb 2014
    Consegnato il 20 feb 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Novus Lending Limited
    Transazioni
    • 20 feb 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of assignment and charge
    Creato il 20 dic 2010
    Consegnato il 30 dic 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right in title to and interest in the agreement dated 16 march 2010 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transazioni
    • 30 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Share charge
    Creato il 20 nov 2009
    Consegnato il 30 nov 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Full title guarantee all right title and interest all related rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Admenta Holdings Limited
    Transazioni
    • 30 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture deed
    Creato il 11 set 2008
    Consegnato il 12 set 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 gen 2016Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 03 set 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • 08 feb 2020Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Third party assignation of single contract
    Creato il 06 ott 2005
    Consegnato il 08 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from soho road health plaza limited (the "borrower") to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights title and interest arising out of in to and under the guarantee dated 10 august 2005. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 28 ago 2003
    Consegnato il 05 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    A floating charge over the assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ashley House Investments LTD
    Transazioni
    • 05 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 13 giu 2000
    Consegnato il 15 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property at chalfont hall chalfont st peter buckinghamshire. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage deed
    Creato il 29 apr 1999
    Consegnato il 30 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Site at fairfield leys coldharbour farm aylesbury. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 30 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 lug 1996
    Consegnato il 08 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal and floating charge
    Creato il 10 nov 1995
    Consegnato il 23 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    386,000 and all other sums due from the company to the chargee under this charge or otherwise
    Brevi particolari
    9 kingfisher court,281/295 farnham rd,slough,berkshire............t/no. Bk 281821..........see form 395. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transazioni
    • 23 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ASHLEY HOUSE PLC. ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 ago 2020Data della riunione per approvare il CVA
    21 dic 2020Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Julian Pitts
    Fourth Floor, Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    Fourth Floor, Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Robert Alexander Henry Maxwell
    4th Floor Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    4th Floor Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    2
    DataTipo
    21 dic 2020Inizio dell'amministrazione
    03 gen 2023Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Julian Pitts
    Fourth Floor, Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    Fourth Floor, Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Robert Alexander Henry Maxwell
    4th Floor Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    4th Floor Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0