DE FACTO 779 LIMITED

DE FACTO 779 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDE FACTO 779 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02566340
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DE FACTO 779 LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova DE FACTO 779 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DE FACTO 779 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PAGE GROUP LIMITED16 ago 199116 ago 1991
    HURRYLINK LIMITED07 dic 199007 dic 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di DE FACTO 779 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 nov 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per DE FACTO 779 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per DE FACTO 779 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 27 ago 2014

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    4.70

    Risoluzione di insolvenza

    Resolution insolvency:res re statement of account
    1 pagineLIQ MISC RES

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Claverham Limited Bishops Road Claverham BS49 4NF

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Forge Lane Sunbury on Thames Middlesex TW16 6EQ a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 05 set 2014

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagine4.70

    Cessazione della carica di James Scott Erickson come amministratore in data 10 giu 2014

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robert Andrew Fulton come amministratore in data 16 giu 2014

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Alexander Lipyeat come amministratore in data 10 giu 2014

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Scott Robert Anderson come amministratore in data 10 giu 2014

    2 pagineTM01

    Nomina di Rajinder Singh Kullar come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Christian Bruno Jean Idczak come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Evan Francis Smith come amministratore

    3 pagineAP01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    resolution

    Risoluzione di capitalizzazione o emissione di azioni bonus

    £55760992.55 capitalised 30/05/2014
    RES14

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 30 mag 2014

    • Capitale: GBP 2.00
    4 pagineSH01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 05 giu 2014

    • Capitale: GBP 2
    6 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account cancelled 03/06/2014
    RES13

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Stato del capitale al 28 mag 2014

    • Capitale: GBP 2
    4 pagineSH19

    Chi sono gli amministratori di DE FACTO 779 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EDWIN COE SECRETARIES LIMITED
    2 Stone Buildings
    Lincolns Inn
    WC2A 3TH London
    Segretario
    2 Stone Buildings
    Lincolns Inn
    WC2A 3TH London
    98679750001
    IDCZAK, Christian Bruno Jean
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Amministratore
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandFrench129935690010
    KULLAR, Rajinder Singh
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Amministratore
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Untied KingdomBritish74999290008
    SMITH, Evan Francis
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Amministratore
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandAmerican,Irish73647690004
    HAYES, Alan Newton
    31 Rivermead
    KT8 9AZ East Molesey
    Surrey
    Segretario
    31 Rivermead
    KT8 9AZ East Molesey
    Surrey
    British50244440001
    JOHNSON, Stephen
    55 New Inn Lane
    Burpham
    GU4 7HT Guildford
    Surrey
    Segretario
    55 New Inn Lane
    Burpham
    GU4 7HT Guildford
    Surrey
    British87153000001
    ANDERSON, Scott Robert
    S 7th Street
    Phoenix
    Suite 100 3420
    Arizona Az 85040
    Usa
    Amministratore
    S 7th Street
    Phoenix
    Suite 100 3420
    Arizona Az 85040
    Usa
    UsaUsa179893610001
    BROOKS, Peter John
    Reads Cottage
    Main Road Vellow
    PO41 0TE Yarmouth
    Isle Of Wight
    Amministratore
    Reads Cottage
    Main Road Vellow
    PO41 0TE Yarmouth
    Isle Of Wight
    UkBritish38936100002
    BUCKWALTER, Vint William
    319
    North Highland Avenue
    Rockford
    Illinois 61107
    United States
    Amministratore
    319
    North Highland Avenue
    Rockford
    Illinois 61107
    United States
    United StatesUnited States155716410001
    CLAY, John Earl
    S Maize Road
    Wichita
    1643
    Kansas Ks67209
    Usa
    Amministratore
    S Maize Road
    Wichita
    1643
    Kansas Ks67209
    Usa
    UsaUsa179893780001
    ERICKSON, James Scott
    3414 South 5th Street
    Phoenix
    Arizona Az85040
    United States Of America
    Amministratore
    3414 South 5th Street
    Phoenix
    Arizona Az85040
    United States Of America
    United States Of AmericaAmerican186117700001
    FULTON, Robert Andrew
    The Green
    Stratford Road
    B90 4LA Solihull
    C/O Goodrich Control Systems 3
    West Midlands
    England
    Amministratore
    The Green
    Stratford Road
    B90 4LA Solihull
    C/O Goodrich Control Systems 3
    West Midlands
    England
    United KingdomBritish90652480001
    GIBBS, Paul Richard
    St Julians House
    Ford Road
    GU24 8SS Chobham
    Amministratore
    St Julians House
    Ford Road
    GU24 8SS Chobham
    United KingdomBritish24933430003
    HAYES, Alan Newton
    31 Rivermead
    KT8 9AZ East Molesey
    Surrey
    Amministratore
    31 Rivermead
    KT8 9AZ East Molesey
    Surrey
    British50244440001
    HILL, Steven William
    7 Ellwood Gardens
    WD25 0DR Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    7 Ellwood Gardens
    WD25 0DR Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish86799890001
    JACOBS, Clifton Dale
    4209 Martina Drive
    Loves Park
    Illinois 61111
    Usa
    Amministratore
    4209 Martina Drive
    Loves Park
    Illinois 61111
    Usa
    American117893050001
    JOHN, Ian Clive
    Tynwald
    23a Longfield Drive
    HP6 5HD Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Tynwald
    23a Longfield Drive
    HP6 5HD Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish114024160001
    JOHNSON, Stephen
    55 New Inn Lane
    Burpham
    GU4 7HT Guildford
    Surrey
    Amministratore
    55 New Inn Lane
    Burpham
    GU4 7HT Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish87153000001
    KNIGHT, Michael William Patrick, Sir
    Craigwell
    Mortehoe
    EX34 7ED Woolacombe
    North Devon
    Amministratore
    Craigwell
    Mortehoe
    EX34 7ED Woolacombe
    North Devon
    British65873590001
    LEGG, John Robert
    Boat House Flat
    Bridge Mews Bridge Barn Lane
    GU21 1NL Woking
    Surrey
    Amministratore
    Boat House Flat
    Bridge Mews Bridge Barn Lane
    GU21 1NL Woking
    Surrey
    British24933440002
    LIPYEAT, Mark Alexander
    Forge Lane
    Sunbury On Thames
    Middlesex
    Tw16 6eq
    Amministratore
    Forge Lane
    Sunbury On Thames
    Middlesex
    Tw16 6eq
    United KingdomBritish87359810001
    LIPYEAT, Mark Alexander
    4 Yew Tree Close
    GU14 0QR Farnborough
    Hampshire
    Amministratore
    4 Yew Tree Close
    GU14 0QR Farnborough
    Hampshire
    United KingdomBritish87359810001
    LYE, Raymond John
    Enstone Manor Farm Windy Hill
    Enstone
    OX7 4HN Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Enstone Manor Farm Windy Hill
    Enstone
    OX7 4HN Oxford
    Oxfordshire
    British13687320001
    MARKS, Nigel William
    Am Reisblick 10
    86751
    Moenchsdeggingen
    Germany
    Amministratore
    Am Reisblick 10
    86751
    Moenchsdeggingen
    Germany
    GermanyBritish157482810001
    SCHELL, Andreas
    4747
    Harrison Avenue
    Rockford
    Illinois
    United States
    Amministratore
    4747
    Harrison Avenue
    Rockford
    Illinois
    United States
    UsaGerman155716080001
    SPANA, Mark David
    Burgess Trail
    Stillman Valley
    6780 E
    61084 Illinois
    United States
    Amministratore
    Burgess Trail
    Stillman Valley
    6780 E
    61084 Illinois
    United States
    United States134506380001
    WICKS, Eve
    Shirland Road
    Rockton
    6203
    61072 Illinois
    United States
    Amministratore
    Shirland Road
    Rockton
    6203
    61072 Illinois
    United States
    United States134505750001

    DE FACTO 779 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 05 nov 1996
    Consegnato il 15 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Series of debentures
    Creato il 09 mag 1991
    Consegnato il 09 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Transazioni
    • 09 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 05 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 27 apr 1991
    Consegnato il 16 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facilities agreement of even date and the charge
    Brevi particolari
    The whole rights to and in the benefit of the company in and to the key man insurance policies including all profits & proceeds thereof (for full details see form 395).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of set off
    Creato il 27 apr 1991
    Consegnato il 16 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or page aerospace LTD page engineering (holdings) LTD to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All sums & interest (if any) thereon standing or which may stand to the credit of any bank accounts in the companys name of maintained on the companys behalf or maintained in the name of a designated company in the banks books.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 27 apr 1981
    Consegnato il 16 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other group company (as defined) under the terms of the facilities agreement of even date and under the terms of the debenture and other security documents (as defined ) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    DE FACTO 779 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    27 ago 2014Inizio della liquidazione
    20 giu 2015Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praticante
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0