THE SCOTTS COMPANY (MANUFACTURING) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | THE SCOTTS COMPANY (MANUFACTURING) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02566745 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di THE SCOTTS COMPANY (MANUFACTURING) LIMITED?
- fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (20150) / Industrie manifatturiere
- fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a. (20590) / Industrie manifatturiere
Dove si trova THE SCOTTS COMPANY (MANUFACTURING) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 8th Floor 20 Farringdon Street EC4A 4AB London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di THE SCOTTS COMPANY (MANUFACTURING) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MIRACLE GARDEN CARE (MANUFACTURING) LIMITED | 08 nov 1995 | 08 nov 1995 |
| 'HOWDEN PRODUCTS LIMITED' | 02 dic 1992 | 02 dic 1992 |
| IMPKEMIX (NO. 39) LIMITED | 07 dic 1990 | 07 dic 1990 |
Quali sono gli ultimi bilanci di THE SCOTTS COMPANY (MANUFACTURING) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per THE SCOTTS COMPANY (MANUFACTURING) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Cessazione di A Person with Significant Control come persona con controllo significativo il 30 ago 2019 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||||||
Notifica di The Scotts Miracle-Gro Company come persona con controllo significativo il 30 ago 2019 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 nov 2019 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Tmf Corporate Administration Services Limited il 05 ago 2019 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 5th Floor 6 st. Andrew Street London EC4A 3AE United Kingdom a C/O Tmf Group 8th Floor 20 Farringdon Street London EC4A 4AB | 1 pagine | AD02 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 06 ago 2019
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 5th Floor 6 st. Andrew Street London EC4A 3AE United Kingdom a 8th Floor 20 Farringdon Street London EC4A 4AB in data 05 ago 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2018 | 19 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2017 | 20 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 nov 2018 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Kelly Berry il 01 set 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||||||
Nomina di Kelly Berry come amministratore in data 01 set 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Phillip Andrew Jones come amministratore in data 01 set 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 28 giu 2018
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 nov 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Aimee Deluca il 01 nov 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di THE SCOTTS COMPANY (MANUFACTURING) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED | Segretario | 20 Farringdon Street EC4A 4AB London 8th Floor United Kingdom |
| 140723560001 | ||||||||||
| BERRY, Kelly | Amministratore | Scottslawn Road 43041 Marysville 14111 Ohio United States | United States | American | Vice President And Treasurer | 250533550001 | ||||||||
| DELUCA, Aimee | Amministratore | Scottslawn Road 43041 Marysville 14111 Ohio United States | United States | American | Tax Accountant | 162680580001 | ||||||||
| COLLETT, Brian | Segretario | 254 Old Church Road Chingford E4 8BT London | British | 32267100002 | ||||||||||
| LACHLAN, Cacilia Maria | Segretario nominato | 10 Guernsey Farm Drive Horsell Rise GU21 4BE Woking Surrey | British | 900008880001 | ||||||||||
| SCHMENK, Christiane Ward | Segretario | 615 Timberview Drive Marysville Ohio FOREIGN Usa Oh 43041 | American | Director | 50940430001 | |||||||||
| SHORTHOSE, Sally Jane | Segretario | Deepdene Copse 2 Trout Road GU27 1RD Haslemere Surrey | British | Solicitor | 29368550002 | |||||||||
| WALKER, John, Dr | Segretario | Fairlawn Christchurch Road GU25 4PJ Wentworth Surrey | British | 49739170001 | ||||||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Segretario | Upper Bank Street E14 5JJ London 10 United Kingdom |
| 38508390004 | ||||||||||
| BERGER, Charles | Amministratore | 147 East Deshler Columbus Ohio 43206 FOREIGN Usa | American | Company Director | 51186010002 | |||||||||
| BOURNE, Anthony John, Dr | Amministratore | 138 Cambridge Street SW1V 4QF London | England | British | Company Official | 12074490001 | ||||||||
| BREDDY, Martin Nicholas | Amministratore | Weyside Park Cateshall Lane GU7 1XE Godalming Salisbury House Surrey England | England | British | Company Director | 116208820001 | ||||||||
| CLAGGETT, Edward | Amministratore | 8026 Balmoral Court Dublin IRISH Ohio 43017 United States | Usa | American | Tax Adviser | 64997550001 | ||||||||
| DEARING, Roland | Amministratore | 81 Kilnwick Road YO42 2LJ Pocklington East Yorkshire | England | British | Manafacturing Director | 73026750001 | ||||||||
| ELSDON, Peter John | Amministratore | Chase Warren Tennysons Lane GU27 3AF Haslemere Surrey | United Kingdom | British | Director | 67751830001 | ||||||||
| GAITER, John Milne | Amministratore | 44 Stoatley Rise GU27 1AG Haslemere Surrey | British | General Manager | 32103820002 | |||||||||
| HAGEDORN, James | Amministratore | Beach Road Sand Point NY11050 New York Usa | Usa | Company Director | 49249700001 | |||||||||
| HUGHES, Malcolm Francis | Amministratore | 38 Effingham Road KT6 5JY Long Ditton Surrey | British | Business Manager | 45828970001 | |||||||||
| JONES, Phillip Andrew | Amministratore | Scottslawn Road 43041 Marysville 14111 Ohio United States | United States | British | Business Executive | 195352900001 | ||||||||
| KIRKBRIDE, Nicholas George | Amministratore | Kelbrook House 44 Whielden Street HP7 0HU Amersham Buckinghamshire | England | British | Managing Director | 56809820001 | ||||||||
| LACHLAN, Cacilia Maria | Amministratore delegato nominato | 10 Guernsey Farm Drive Horsell Rise GU21 4BE Woking Surrey | British | 900008880001 | ||||||||||
| LARSON, Douglas | Amministratore | 21, Chemin De La Sauvegarde 69130 Ecully The Scotts Company France | France | Canadian And French | Vp Finance, Cfo International | 162680620002 | ||||||||
| O'DONNELL, Dale G. | Amministratore | Scottslawn Road 43041 Marysville 14111 Ohio Usa | United States | American | Finance | 197602570001 | ||||||||
| POWELL, Stephen Mark | Amministratore | Flat 3 34 Nevern Place SW5 London | Australian | Solicitor | 44712350001 | |||||||||
| REED, Matthew | Amministratore | Osbornes Oast House Main Road Kingsley GU35 9LW Bordon Hampshire | British | Chartered Accountant | 56184660001 | |||||||||
| RUST, Neil Kenneth | Amministratore | Lewes Road Blackboys TN22 5LE Uckfield September House East Sussex United Kingdom | England | British | Company Director | 178537740001 | ||||||||
| SHORTHOSE, Sally Jane | Amministratore | Deepdene Copse 2 Trout Road GU27 1RD Haslemere Surrey | British | Solicitor | 29368550002 | |||||||||
| SMITH, Derrick | Amministratore | 21 Phillips Crescent Headley GU35 8NU Bordon Hampshire | British | Business Manager | 41954600001 | |||||||||
| STOHLER, Robert | Amministratore | 723 Olde Mill Circle Bloomington In 47401 Indiana Usa | American | Company Director | 50637990001 | |||||||||
| VAN WINDEN, Adrianus Petrus | Amministratore | 12 Puddingstone Drive AL4 0GY St Albans Hertfordshire | Dutch | Finance Director | 79046290001 | |||||||||
| WILSON, John Sheppard | Amministratore | 31 Riverside Court 20 Nine Elms Lane SW8 5DB London | New Zealand | Company Manager | 36562020001 | |||||||||
| WYATT, John Henry Aldworth | Amministratore | Kings Copse House Bradfield RG7 6JR Reading Berkshire | United Kingdom | American | Managing Director | 117393650001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di THE SCOTTS COMPANY (MANUFACTURING) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Scotts Miracle-Gro Company | 30 ago 2019 | Scottslawn Road 43041 Marysville 14111 Ohio United States | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Scotts Company (Uk) Limited, The | 06 apr 2016 | 6 St. Andrew Street EC4A 3AE London 5th Floor United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
THE SCOTTS COMPANY (MANUFACTURING) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee and debenture | Creato il 16 mar 1995 Consegnato il 27 mar 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The guaranteed liabilities (as defined in the guarantee and debenture) comprising, inter alia, all those guarantee obligations set out in clause 2 thereof and including a guarantee to bankers trust company as security trustee for itself and the other finance parties (as defined therein) of the due and punctual payment by the borrower and each other obligor (as defined therein) of the sums comprised in the indebtedness (also as defined) | |
Brevi particolari F/H land at ferry road howdendyke boothferry humberside t/n HS171118 and l/h land at ferry road howdendyke boothferry humberside t/n HS237096. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 31 dic 1994 Consegnato il 11 gen 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land at ferry road howdendyke boothferry humberside t/n HS171118 and l/h land at ferry road howdendyke boothferry t/n HS237096 and all buildings and fixtures and. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0