KM REALISATIONS (2009) LIMITED

KM REALISATIONS (2009) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKM REALISATIONS (2009) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02567238
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KM REALISATIONS (2009) LIMITED?

    • (5242) /
    • (9231) /

    Dove si trova KM REALISATIONS (2009) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KM REALISATIONS (2009) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KAREN MILLEN LIMITED10 gen 199110 gen 1991
    OVAL (676) LIMITED10 dic 199010 dic 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di KM REALISATIONS (2009) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al26 gen 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per KM REALISATIONS (2009) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 30 nov 2011

    27 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 01 mar 2011

    21 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 01 set 2011

    21 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 01 set 2010

    28 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 01 set 2010

    22 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 01 mar 2010

    45 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 01 set 2009

    19 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 01 set 2009

    17 pagine2.24B

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed karen millen LIMITED\certificate issued on 01/09/09
    2 pagineCERTNM

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    16 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    33 pagine2.17B

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    5 pagine395

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Bilancio redatto al 26 gen 2008

    21 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 27 gen 2007

    21 pagineAA

    legacy

    8 pagine395

    legacy

    6 pagine363a

    legacy

    2 pagine403b

    legacy

    2 pagine403b

    Chi sono gli amministratori di KM REALISATIONS (2009) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GLANVILLE, Richard Spencer
    Babshole Farm
    Sudburys Farm Road
    CM12 9SP Little Burstead
    Essex
    Segretario
    Babshole Farm
    Sudburys Farm Road
    CM12 9SP Little Burstead
    Essex
    British69669910005
    WILKS, Jessica
    1 Forge Cottages
    High Street
    RH8 0DT Limpsfield
    Surrey
    Segretario
    1 Forge Cottages
    High Street
    RH8 0DT Limpsfield
    Surrey
    British116562380001
    GLANVILLE, Richard Spencer
    Babshole Farm
    Sudburys Farm Road
    CM12 9SP Little Burstead
    Essex
    Amministratore
    Babshole Farm
    Sudburys Farm Road
    CM12 9SP Little Burstead
    Essex
    United KingdomBritish69669910005
    LOVELOCK, Derek John
    Oldfields Farm
    Amersham Road
    HP9 2UG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Oldfields Farm
    Amersham Road
    HP9 2UG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish116560620001
    LUSTMAN, Margaret Eve
    Exeter Road
    NW2 4SE London
    49
    Amministratore
    Exeter Road
    NW2 4SE London
    49
    EnglandBritish40930620002
    SHEARWOOD, Mike
    Upton Fields House
    Upton Road
    NG25 0QA Southwell
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Upton Fields House
    Upton Road
    NG25 0QA Southwell
    Nottinghamshire
    EnglandBritish95093740001
    LAMBERT, Roy Jefferson
    6 Middle Street
    EC1A 7JA London
    Segretario
    6 Middle Street
    EC1A 7JA London
    British7959460002
    SHARMA, Sanjib
    Apartment A609 The Jam Factory
    27 Green Walk
    SE1 4TU London Bridge
    London
    Segretario
    Apartment A609 The Jam Factory
    27 Green Walk
    SE1 4TU London Bridge
    London
    British111733770001
    STANFORD, Kevin Gerald
    The Dower House
    Royden Hall Road
    TN12 5NH East Peckham
    Kent
    Segretario
    The Dower House
    Royden Hall Road
    TN12 5NH East Peckham
    Kent
    British83560040001
    GOLDSBROUGH, Sandy
    Loft 3 Building 7
    30-32 Shepherdess Walk
    N1 7LB London
    Amministratore
    Loft 3 Building 7
    30-32 Shepherdess Walk
    N1 7LB London
    British113880110001
    MILLEN, Karen Denise
    243-245 The Lodge
    Tonbridge Road
    ME18 5PA Wateringbury Nr Kent
    Kent
    Amministratore
    243-245 The Lodge
    Tonbridge Road
    ME18 5PA Wateringbury Nr Kent
    Kent
    United KingdomBritish141602700001
    SAMUEL, Nicholas Michael
    133 Saint Josephs Vale
    SE3 0XQ London
    Amministratore
    133 Saint Josephs Vale
    SE3 0XQ London
    British78875220001
    SHARMA, Sanjib
    Apartment A609 The Jam Factory
    27 Green Walk
    SE1 4TU London Bridge
    London
    Amministratore
    Apartment A609 The Jam Factory
    27 Green Walk
    SE1 4TU London Bridge
    London
    British111733770001
    SIGURDSSON, Gunnar
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    Amministratore
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    EnglandIcelandic114179720001
    STANFORD, Kevin Gerald
    The Dower House
    Royden Hall Road
    TN12 5NH East Peckham
    Kent
    Amministratore
    The Dower House
    Royden Hall Road
    TN12 5NH East Peckham
    Kent
    United KingdomBritish83560040001

    KM REALISATIONS (2009) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 26 feb 2009
    Consegnato il 13 mar 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barclays bank PLC re karen millen limited business premium account a/n 73087859, euro current account a/n 55407599, euro business premium account a/n 42498555 the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge on shares
    Creato il 14 mar 2008
    Consegnato il 27 mar 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares, the derivative assets; all dividends see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kaupthing Bank Hf. (As Security Trustee for the Finance Parties)(in Such Capacity, the Security Trustee)
    Transazioni
    • 27 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 28 dic 2007
    Consegnato il 05 gen 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the security trustee and/or the other financial parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kaupthing Bank Hf (Security Trustee)
    Transazioni
    • 05 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 2008Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Amendment agreement to a charge on shares dated 12 october 2006
    Creato il 21 mag 2007
    Consegnato il 23 mag 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares, the derivative assets, all dividends interest and other income deriving from any stocks shares or other securities and all moneys income and amounts from all or any part of the shares or T. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kaupthing Bank Hf (As Security Trustee for the Secured Parties) (in Such Capacity the Securitytrustee)
    Transazioni
    • 23 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge on shares
    Creato il 12 ott 2006
    Consegnato il 21 ott 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares the derivative assets all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kaupthing Bank Hf (As Security Trustee for the Secured Parties) the Security Trustee
    Transazioni
    • 21 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 12 ott 2006
    Consegnato il 21 ott 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kaupthing Bank Hf. (As Security Trustee for the Secured Parties) (the "Security Trustee")
    Transazioni
    • 21 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 2008Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Share pledge agreement
    Creato il 27 lug 2004
    Consegnato il 11 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee, and/or the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Pursuant to the share pledge, the pledgor pledged under the belgian act of 5 may 1872 to the pledgee by way of first ranking pledge as security for the due performance of the secured liabilities, the shares, together with the other pledged assets;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Acting as Security Trustee)
    Transazioni
    • 11 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed to the composite guarantee and debenture dated 15 november 2003
    Creato il 25 giu 2004
    Consegnato il 07 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company to the security trustee and/or the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 07 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 ott 2003
    Consegnato il 07 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H premises unit 4, the barkers centre, kensington high street, london.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 28 ott 2003
    Consegnato il 07 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Th registered trade marks being, mark: press & bastyan, no: 2103182, class: 25, and the full benefit of all rights and remedies of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 28 ott 2003
    Consegnato il 31 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or karen millen holdings limited or press & bastyan limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kaupthing Bank Hf
    Transazioni
    • 31 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 lug 2002
    Consegnato il 09 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 29 apr 2002
    Consegnato il 07 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 nov 1998
    Consegnato il 07 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 22 feb 1996
    Consegnato il 24 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Basement ground and first floors of 17 - 19 neal street london WC2 benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property any shares or membership rights in ant management company for the property any goodwill of any business at the property any rental and other money payable and all other payments whatever. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 24 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 feb 1996
    Consegnato il 13 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property - unit 4 barkers arcade high st,kensington,london W.8 with all fixtures/fittings; the goodwill of business and all rights/licences.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 24 ago 1995
    Consegnato il 31 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of keyman insurance policy
    Creato il 28 giu 1993
    Consegnato il 07 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The benefit of the policey insurance dated 28/06/93 no 14B 75J60 with J.rothschild assurance in the amount of £1000000.
    Persone aventi diritto
    • Aitken Hume Bank PLC
    Transazioni
    • 07 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 11 giu 1993
    Consegnato il 25 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility letter and/or this charge
    Brevi particolari
    Unit 7 barkers kensington high street london together with all fixtures and fittings and all right title estates and all stocks shares and other securities together with all dividends and a floating charge over the companys undertaking and all its assets and the goodwill of the business.
    Persone aventi diritto
    • Aitken Hume Bank PLC
    Transazioni
    • 25 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 16 nov 1992
    Consegnato il 19 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 19 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 giu 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    KM REALISATIONS (2009) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    02 mar 2009Inizio dell'amministrazione
    30 nov 2011Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Philip Stephen Bowers
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Neville Barry Khan
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Lee Antony Manning
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0