GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED

GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02569263
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Thrid Floor One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    16 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Newton House Cambridge Business Park, Cowley Road Cambridge CB4 0WZ a Thrid Floor One London Square Cross Lanes Guildford Surrey GU1 1UN in data 09 lug 2015

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 22 giu 2015

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 17 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 gen 2015

    Stato del capitale al 28 gen 2015

    • Capitale: GBP 658,000
    SH01

    Cessazione della carica di Spencer Neal Dredge come amministratore in data 31 dic 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Anthony Charles Weaver come amministratore in data 31 dic 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Anthony Charles Weaver come amministratore in data 31 dic 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Spencer Neal Dredge come amministratore in data 31 dic 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Haywood Chapman come amministratore in data 01 dic 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Spencer Neal Dredge come amministratore in data 31 gen 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter John Hallett come amministratore in data 31 gen 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 17 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 gen 2014

    Stato del capitale al 13 gen 2014

    • Capitale: GBP 658,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Paul Harvey Myhill come segretario in data 01 gen 2013

    1 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MYHILL, Paul Harvey
    One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Thrid Floor
    Surrey
    Segretario
    One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Thrid Floor
    Surrey
    175307330001
    CHAPMAN, Haywood Trefor
    One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Thrid Floor
    Surrey
    Amministratore
    One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Thrid Floor
    Surrey
    United KingdomBritish193406100001
    BALAAM, Martin Anthony
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    Segretario
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    British82233550001
    HAYES, Peter Andrew
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Segretario
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    164940450001
    HAYES, Peter Andrew
    2 Somersby Crescent
    SL6 3YY Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    2 Somersby Crescent
    SL6 3YY Maidenhead
    Berkshire
    British66610550002
    HOUSTON, Donald John
    10 Lauder Crescent
    PH1 1SU Perth
    Segretario
    10 Lauder Crescent
    PH1 1SU Perth
    British45207780002
    O'RORKE, Nicholas
    Kirtlington Business Centre, Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B - Office 10
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Kirtlington Business Centre, Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B - Office 10
    Oxfordshire
    United Kingdom
    149437450001
    PARISH, Antony Jonathan
    Three Beeches
    139 Old Woking Road
    GU22 8PD Pyrford
    Surrey
    Segretario
    Three Beeches
    139 Old Woking Road
    GU22 8PD Pyrford
    Surrey
    English21589960002
    PARISH, Deborah
    Winding Wood,
    Mile Path
    GU22 0JX Woking
    Segretario
    Winding Wood,
    Mile Path
    GU22 0JX Woking
    British103332870001
    SIEBERT, Paul William
    56 Rucklidge Avenue
    NW10 4PS London
    Segretario
    56 Rucklidge Avenue
    NW10 4PS London
    British91575150001
    VAN DEN HEUVEL, Christopher Edward Francis, Mr.
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    Segretario
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    British80721980001
    BALAAM, Martin Anthony
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    Amministratore
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    United KingdomBritish82233550001
    CALDER, Ian William
    13 Boscombe Road
    SW19 3AX London
    Amministratore
    13 Boscombe Road
    SW19 3AX London
    British65078310001
    COLEMAN, Nevil David
    51b Englands Lane
    NW3 4YD London
    Amministratore
    51b Englands Lane
    NW3 4YD London
    British67334160001
    CONOLEY, John Richard
    Dromkeen
    Old Compton Lane
    GU9 8EH Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Dromkeen
    Old Compton Lane
    GU9 8EH Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish80922910001
    CROSS, Ray John
    52 Waterhouse Moor
    CM18 6BB Harlow
    Essex
    Amministratore
    52 Waterhouse Moor
    CM18 6BB Harlow
    Essex
    British42422430004
    DREDGE, Spencer Neal
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    Amministratore
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United KingdomBritish138270950001
    EDWARDS, Roger Francis
    146 Chertsey Lane
    TW18 3LS Staines
    Middlesex
    Amministratore
    146 Chertsey Lane
    TW18 3LS Staines
    Middlesex
    British3398820001
    HALLETT, Peter John
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Amministratore
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    United KingdomBritish20621770002
    HOUSTON, Donald John
    10 Lauder Crescent
    PH1 1SU Perth
    Amministratore
    10 Lauder Crescent
    PH1 1SU Perth
    ScotlandBritish45207780002
    JOHN, Ian Clive
    Tynwald
    23a Longfield Drive
    HP6 5HD Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Tynwald
    23a Longfield Drive
    HP6 5HD Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish114024160001
    PARISH, Antony Jonathan
    Winding Wood Eagle Lodge
    Mile Path
    GU22 0JX Woking
    Surrey
    Amministratore
    Winding Wood Eagle Lodge
    Mile Path
    GU22 0JX Woking
    Surrey
    United KingdomBritish21589960003
    PARISH, Deborah
    Winding Wood,
    Mile Path
    GU22 0JX Woking
    Amministratore
    Winding Wood,
    Mile Path
    GU22 0JX Woking
    British103332870001
    PERKS, Timothy Howard
    Bowdown Farmhouse Burys Bank Road
    Greenham
    RG19 8DA Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Bowdown Farmhouse Burys Bank Road
    Greenham
    RG19 8DA Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish100207880001
    RAMZAN, Mohammed
    336 Olton Boulevard West
    B11 3HJ Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    336 Olton Boulevard West
    B11 3HJ Birmingham
    West Midlands
    British45096260001
    ROWETT, Geoffrey David
    Flat 20 Belvedere House
    Churchfields Avenue
    KT13 9XY Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Flat 20 Belvedere House
    Churchfields Avenue
    KT13 9XY Weybridge
    Surrey
    British58991930003
    STEVENS, Kevin
    42 Armadale Road
    GU21 3LB Woking
    Surrey
    Amministratore
    42 Armadale Road
    GU21 3LB Woking
    Surrey
    British65078350001
    WEAVER, Anthony Charles
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Amministratore
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    United KingdomBritish153397180001
    YAPP, Stephen
    Kirtlington Business Centre, Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B - Office 10
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Kirtlington Business Centre, Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B - Office 10
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish42686850001

    GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Group debenture
    Creato il 21 giu 2012
    Consegnato il 29 giu 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each present and future secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 giu 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 26 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 ott 2006
    Consegnato il 13 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 24 nov 2005
    Consegnato il 06 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession to a debenture dated 14 may 2001
    Creato il 30 apr 2004
    Consegnato il 30 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by the obligors (including the company) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 11 mar 2004
    Consegnato il 23 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £73,800 plus vat of £12,915;interest bearing account designated "third floor 12/12A golden square london W1 deposit account" the amount sanding from time to time to the credit of such account and all interest credited.
    Persone aventi diritto
    • Carlton Screen Advertising Limited
    Transazioni
    • 23 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent security deposit deed
    Creato il 25 feb 2002
    Consegnato il 12 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The sum of £12,730 and all other monies credited from time to time to the interest bearing account opened at the london clearing bank where the deposit account is from time to time held by seagate distribution (UK) limited (the "landlord") in the landlords name.
    Persone aventi diritto
    • Seagate Distribution (UK) Limited
    Transazioni
    • 12 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent security deposit deed
    Creato il 25 feb 2002
    Consegnato il 06 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £12,730 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit sum of £12,730 plus value added tax together with interest representing security for the performance by the company of its obligations under the lease.
    Persone aventi diritto
    • Seagate Distribution (UK) Limited
    Transazioni
    • 06 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    All assets debenture deed
    Creato il 19 dic 1997
    Consegnato il 22 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 22 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 12 mar 1996
    Consegnato il 21 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 apr 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 16 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of rent deposit
    Creato il 06 ott 1993
    Consegnato il 14 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 06/10/93
    Brevi particolari
    A reent deposit in the sum of £6453 under the rent deposit.
    Persone aventi diritto
    • Wereldhave Property Corporation PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 giu 2015Inizio della liquidazione
    03 nov 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John Ariel
    Portland 25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    West Sussex
    Praticante
    Portland 25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    West Sussex
    Terence Guy Jackson
    Third Floor One London Square Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Praticante
    Third Floor One London Square Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0