BOWOOD PARTNERS LIMITED

BOWOOD PARTNERS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBOWOOD PARTNERS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02569473
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BOWOOD PARTNERS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova BOWOOD PARTNERS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    16 Eastcheap
    EC3M 1BD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BOWOOD PARTNERS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GRIMSTON INSURANCE SERVICES LIMITED19 dic 199019 dic 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di BOWOOD PARTNERS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2014

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per BOWOOD PARTNERS LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al30 giu 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per BOWOOD PARTNERS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Stato del capitale al 17 giu 2016

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share premium a/c & other reserve be cancelled 27/05/2016
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Ritiro della richiesta di cancellazione della società

    1 pagineDS02

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Ian Richardson come amministratore in data 11 nov 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 lug 2015

    Stato del capitale al 28 lug 2015

    • Capitale: GBP 676,650.4
    SH01

    Nomina di William David Bloomer come amministratore in data 29 apr 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Ian Richardson come amministratore in data 29 apr 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Tuffield come amministratore in data 29 apr 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jonathan Mark Thompson-Copsey come amministratore in data 29 apr 2015

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 giu 2015 al 30 set 2015

    1 pagineAA01

    Indirizzo della sede legale modificato da Woodlands Manton Lane Bedford Bedfordshire MK41 7LW a 16 Eastcheap London EC3M 1BD in data 30 apr 2015

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2014

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 lug 2014

    Stato del capitale al 21 lug 2014

    • Capitale: GBP 676,650.4
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2013

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 lug 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 23 lug 2013

    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2012

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di BOWOOD PARTNERS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MOORE, Andrew John
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    Segretario
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    British133845040001
    BLOOMER, William David
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    Amministratore
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    United KingdomBritish72374560002
    GRIMSTON, Katherine
    The Old Rectory
    MK18 4AR Finmere
    Bucks
    Segretario
    The Old Rectory
    MK18 4AR Finmere
    Bucks
    British23550560001
    HATHAWAY, Rodney Francis
    Boxted Church Road
    Great Horkesley
    CO6 4AL Colchester
    Elmdene
    Essex
    Segretario
    Boxted Church Road
    Great Horkesley
    CO6 4AL Colchester
    Elmdene
    Essex
    British61813590002
    TRILLO, David John
    45 Ellington Street
    N7 8PN London
    Segretario
    45 Ellington Street
    N7 8PN London
    British14014360001
    WHITING, Andrew Michael John
    14 Buckden Road
    Brampton
    PE28 4PS Huntingdon
    Cambridgeshire
    Segretario
    14 Buckden Road
    Brampton
    PE28 4PS Huntingdon
    Cambridgeshire
    British38444620001
    ALBON, Philip Ian
    Manton Lane
    MK41 7LW Bedford
    Woodlands
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Manton Lane
    MK41 7LW Bedford
    Woodlands
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish53364690001
    ANGEL, Alan Paul
    26 Northwick Circle
    HA3 0EE Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    26 Northwick Circle
    HA3 0EE Harrow
    Middlesex
    United KingdomBritish39825440002
    ANGEL, Alan Paul
    9 Aston Avenue
    HA3 0DB Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    9 Aston Avenue
    HA3 0DB Harrow
    Middlesex
    British39825440001
    ARNOLD, David John Middleton
    Flat 308
    Gilbert House
    EC2Y 8BD Barbican
    London
    Amministratore
    Flat 308
    Gilbert House
    EC2Y 8BD Barbican
    London
    British36584410002
    ARNOLD, David John Middleton
    Abbotshay Cottage
    Ayot St Lawrence
    AL6 9BS St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Abbotshay Cottage
    Ayot St Lawrence
    AL6 9BS St Albans
    Hertfordshire
    British36584410001
    BARNES, Paul
    Shafford Mill
    Childwick Bury
    AL3 6LB St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Shafford Mill
    Childwick Bury
    AL3 6LB St Albans
    Hertfordshire
    EnglandEnglish32833320001
    BONIFACE, Michael John Owen
    Rashleigh Horton Road
    Horton
    DA49 BN Kirby
    Kent
    Amministratore
    Rashleigh Horton Road
    Horton
    DA49 BN Kirby
    Kent
    United KingdomBritish207125910001
    BRIDGWATER, Paul Charles
    Manton Lane
    MK41 7LW Bedford
    Woodlands
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Manton Lane
    MK41 7LW Bedford
    Woodlands
    Bedfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish87505170002
    BRIDGWATER, Paul Charles
    Manton Lane
    MK41 7LW Bedford
    Woodlands
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Manton Lane
    MK41 7LW Bedford
    Woodlands
    Bedfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish87505170002
    CAVAZZI, Gary Mark
    Wedgwood Knowl Hill
    The Hockering
    GU22 7HL Woking
    Surrey
    Amministratore
    Wedgwood Knowl Hill
    The Hockering
    GU22 7HL Woking
    Surrey
    United KingdomUsa27090250002
    COLLINS, Andrew Dominic John Bucke
    Adlestrop
    GL56 0YN Moreton In Marsh
    Adlestrop Park
    Gloucestershire
    Amministratore
    Adlestrop
    GL56 0YN Moreton In Marsh
    Adlestrop Park
    Gloucestershire
    United KingdomBritish139705290001
    COUGHLIN, Alan Alfred
    17 Lampern Crescent
    CM12 0FE Billericay
    Essex
    Amministratore
    17 Lampern Crescent
    CM12 0FE Billericay
    Essex
    British61617320001
    CURITZ, Maurice Anthony
    Holts Barn Holt Road
    Little Horkesley
    CO6 4DR Colchester
    Essex
    Amministratore
    Holts Barn Holt Road
    Little Horkesley
    CO6 4DR Colchester
    Essex
    British14791280001
    FAGG, Paul John
    24 Doves Croft
    Tunstall
    ME9 8LQ Sittingbourne
    Kent
    Amministratore
    24 Doves Croft
    Tunstall
    ME9 8LQ Sittingbourne
    Kent
    United KingdomBritish48990790002
    GAYTON, Ashley Vivian
    The Paddocks
    Lower Road Peldon
    CO5 7PR Colchester
    Essex
    Amministratore
    The Paddocks
    Lower Road Peldon
    CO5 7PR Colchester
    Essex
    British91623980002
    GINGELL, Timothy
    20 Dorking Road
    KT18 7LX Epsom
    Surrey
    Amministratore
    20 Dorking Road
    KT18 7LX Epsom
    Surrey
    British50905970002
    GREENER, Stephen Thomas
    Ash Farm House Gravel Lane
    Barton Stacey
    SO21 3RL Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    Ash Farm House Gravel Lane
    Barton Stacey
    SO21 3RL Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish55748330003
    GRIMSTON, Gerald Charles Walter, The Hon
    The Old Rectory
    MK18 4AR Finmere
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Old Rectory
    MK18 4AR Finmere
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish12430760001
    HUDSON, John Henry
    Strawberry Fields Long Mill Lane
    Crouch Borough Green
    TN15 8QB Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Strawberry Fields Long Mill Lane
    Crouch Borough Green
    TN15 8QB Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish104588370001
    JEWERS, David John
    Corner Cottage Howe Street
    Great Waltham
    CM3 1BS Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Corner Cottage Howe Street
    Great Waltham
    CM3 1BS Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritish113199070001
    MITCHELL, Adrian Edward Michael
    44 Stormont Road
    Battersea
    SW11 5EL London
    Amministratore
    44 Stormont Road
    Battersea
    SW11 5EL London
    British37610700001
    OVENS, Michael John Meyrick
    15 Criffel Avenue
    SW2 4AY London
    Amministratore
    15 Criffel Avenue
    SW2 4AY London
    British14990390002
    REED, David Michael
    Manton Lane
    MK41 7LW Bedford
    Woodlands
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Manton Lane
    MK41 7LW Bedford
    Woodlands
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish159470820001
    RICHARDSON, Ian
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    Amministratore
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    United KingdomBritish197592500001
    STANCIK, John David
    259 Mayflower Road
    Lake Forest
    Illinois 60045
    America
    Amministratore
    259 Mayflower Road
    Lake Forest
    Illinois 60045
    America
    American42367650002
    THOMPSON-COPSEY, Jonathan Mark
    EC3V 1LE London
    One Whittington Avenue
    England
    Amministratore
    EC3V 1LE London
    One Whittington Avenue
    England
    EnglandBritish146513890002
    TOWNSEND, Philip Michael
    80 Sandford Road
    BR2 9AN Bromley
    Kent
    Amministratore
    80 Sandford Road
    BR2 9AN Bromley
    Kent
    British40919720002
    TRILLO, David John
    45 Ellington Street
    N7 8PN London
    Amministratore
    45 Ellington Street
    N7 8PN London
    EnglandBritish14014360001
    TUFFIELD, Andrew
    114 Cardamom Building
    31 Shad Thames
    SE1 2YR London
    Amministratore
    114 Cardamom Building
    31 Shad Thames
    SE1 2YR London
    United KingdomBritish56383230001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per BOWOOD PARTNERS LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    30 giu 2016La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società.

    BOWOOD PARTNERS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Accession deed
    Creato il 17 ott 2008
    Consegnato il 23 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 23 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 28 mar 2007
    Consegnato il 07 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 21 giu 2006
    Consegnato il 05 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Equitable mortgage of land acquired since 28 april 2005 or to be acquired in future. Fixed charge of plant and machinery, goodwill, rights and interest in intellectual property, uncalled share capital, rights and interest in shares and other securities and in contracts. Floating charge of all property and undertaking.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cccc Growth Fund, L.L.C.
    Transazioni
    • 05 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 giu 2006
    Consegnato il 30 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of variation (made in addition to and modifying the security and trust deed dated 6 october 1997 the "principal deed"))
    Creato il 19 nov 1999
    Consegnato il 24 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The payment of all costs charges expenses and other liabilities properly incurred by the chargee its delegates or agents or any receiver appointed under the security and trust deed in or about the exercise of the powers contained in the security and trust deed (as modified) or otherwise in relation thereto including all remuneration payable to any such receiver and the payment of all debts and obligations for the time being due owing or incurred whether actually or contingently by the company in respect of insurance transactions
    Brevi particolari
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to the byelaw or otherwise required to be paid into an insurance broking account of the company and all approved iba assets of the company (and all assets which would be approved).
    Persone aventi diritto
    • Lloyd's (A Statutory Corporation)(as Trustee for the Creditors for the Time Being of the Company in Respect of Insurance Transactions)
    Transazioni
    • 24 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 06 ott 1997
    Consegnato il 08 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    As required by lloyd's brokers byelaw (no 5 of 1988) the company has entered into a trust deed under which all insurance broking account assets are subject to a floating charge held on trust by the society of lloyd's for the benefit of the insurance creditors.
    Persone aventi diritto
    • The Society of Lloyd's
    Transazioni
    • 08 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 27 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0