DIGITAL AND DIRECT COMMUNICATIONS LIMITED

DIGITAL AND DIRECT COMMUNICATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDIGITAL AND DIRECT COMMUNICATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02573203
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DIGITAL AND DIRECT COMMUNICATIONS LIMITED?

    • Attività di consulenza in tecnologie dell'informazione (62020) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova DIGITAL AND DIRECT COMMUNICATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1st Floor 2 Television Centre
    101 Wood Lane
    W12 7FR London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DIGITAL AND DIRECT COMMUNICATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FINEX COMMUNICATIONS GROUP PLC09 dic 199109 dic 1991
    FINEX COMMUNICATIONS PLC11 gen 199111 gen 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di DIGITAL AND DIRECT COMMUNICATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per DIGITAL AND DIRECT COMMUNICATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    24 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 apr 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Eden House 8 Spital Square London E1 6DU a 1st Floor 2 Television Centre 101 Wood Lane London England W12 7FR

    1 pagineAD02

    Cessazione della carica di Nicola Raj come segretario in data 15 feb 2019

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Pembroke Building Kensington Village Avonmore Road London W14 8DG a 1st Floor 2 Television Centre 101 Wood Lane London England and Wales W12 7FR in data 20 feb 2019

    1 pagineAD01

    Nomina di Ms Danielle Bassil come amministratore in data 12 lug 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Islip come amministratore in data 12 lug 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    25 pagineAA

    Nomina di Ms Nicole Pruesse come amministratore in data 02 mag 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Michael Islip come amministratore in data 02 mag 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms Sue Frogley come amministratore in data 02 mag 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Guy David Mark Elliott come amministratore in data 02 mag 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ariel Marciano come amministratore in data 02 mag 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nigel Gregory Vaz come amministratore in data 02 mag 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 apr 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Notifica di Digitaslbi Limited come persona con controllo significativo il 30 mar 2018

    2 paginePSC02

    Cessazione di Sapient Limited come persona con controllo significativo il 30 mar 2018

    1 paginePSC07

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    23 pagineAA

    Nomina di Ms Nicola Raj come segretario in data 07 giu 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Raj Basran come segretario in data 18 gen 2017

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 gen 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di DIGITAL AND DIRECT COMMUNICATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MUNIS, Joanne
    Kensington Village
    Avonmore Road
    W14 8DG London
    Pembroke Building
    England
    Segretario
    Kensington Village
    Avonmore Road
    W14 8DG London
    Pembroke Building
    England
    202596350001
    BASSIL, Danielle
    2 Television Centre
    101 Wood Lane
    W12 7FR London
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    2 Television Centre
    101 Wood Lane
    W12 7FR London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomAustralianChief Executive Officer211094550001
    FROGLEY, Sue
    2 Television Centre
    101 Wood Lane
    W12 7FR London
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    2 Television Centre
    101 Wood Lane
    W12 7FR London
    1st Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishCeo244838370001
    PRUESSE, Nicole
    2 Television Centre
    101 Wood Lane
    W12 7FR London
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    2 Television Centre
    101 Wood Lane
    W12 7FR London
    1st Floor
    United Kingdom
    GermanyGermanCoo Emea246703190001
    BASRAN, Raj
    Kensington Village
    Avonmore Road
    W14 8DG London
    Pembroke Building
    England
    Segretario
    Kensington Village
    Avonmore Road
    W14 8DG London
    Pembroke Building
    England
    202595370001
    BOXALL, David Russell
    9 Challacombe
    SS1 3TY Southend On Sea
    Essex
    Segretario
    9 Challacombe
    SS1 3TY Southend On Sea
    Essex
    BritishSolicitor120328200001
    BOXALL, David Russell
    9 Challacombe
    SS1 3TY Southend On Sea
    Essex
    Segretario
    9 Challacombe
    SS1 3TY Southend On Sea
    Essex
    British120328200001
    BUTTERWORTH, Michael Guy
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    Segretario
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    British76600500002
    DIXON, Sophie Murray
    Spital Square
    E1 6DU London
    Eden House 8
    England
    Segretario
    Spital Square
    E1 6DU London
    Eden House 8
    England
    British166609100001
    FINE, Raymond Philip Ronald
    Spronketts Spronketts Lane
    Bolney
    RH17 5SA Haywards Heath
    West Sussex
    Segretario
    Spronketts Spronketts Lane
    Bolney
    RH17 5SA Haywards Heath
    West Sussex
    British23792490001
    LEES, Jennifer Kathryn
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    Segretario
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    British24587010002
    NICHOLS, Richard Stephen
    3a Devonshire Road
    AL5 4TJ Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    3a Devonshire Road
    AL5 4TJ Harpenden
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant54128690001
    RAJ, Nicola
    Kensington Village
    Avonmore Road
    W14 8DG London
    Pembroke Building
    United Kingdom
    Segretario
    Kensington Village
    Avonmore Road
    W14 8DG London
    Pembroke Building
    United Kingdom
    233357490001
    VENA, Valerie
    8 Spital Square
    E1 6DU London
    Eden House
    Segretario
    8 Spital Square
    E1 6DU London
    Eden House
    169077580001
    VENA, Valerie
    8 Spital Square
    E1 6DU London
    Eden House
    Segretario
    8 Spital Square
    E1 6DU London
    Eden House
    British164222970001
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Segretario
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    British147948820001
    CLYDE SECRETARIES LIMITED
    Houndsditch
    EC3A 7AR London
    The St Botolph Building 138
    United Kingdom
    Segretario
    Houndsditch
    EC3A 7AR London
    The St Botolph Building 138
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02177318
    38770650001
    BOXALL, David Russell
    9 Challacombe
    SS1 3TY Southend On Sea
    Essex
    Amministratore
    9 Challacombe
    SS1 3TY Southend On Sea
    Essex
    United KingdomBritishDirector120328200001
    BOXALL, David Russell
    9 Challacombe
    SS1 3TY Southend On Sea
    Essex
    Amministratore
    9 Challacombe
    SS1 3TY Southend On Sea
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director120328200001
    BURNS, Graeme Ian, Mr.
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    Amministratore
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector75720570001
    CRIDDLE, Scott
    47 Marine Avenue
    BN3 4LH Hove
    East Sussex
    Amministratore
    47 Marine Avenue
    BN3 4LH Hove
    East Sussex
    BritishOperations Director80855090002
    DUCKETT, Sarah
    82 High Street
    Ashwell
    SG7 5NS Baldock
    Hertfordshire
    Amministratore
    82 High Street
    Ashwell
    SG7 5NS Baldock
    Hertfordshire
    BritishOperations Director45958230005
    ELLIOTT, Guy David Mark
    Kensington Village
    Avonmore Road
    W14 8DG London
    Pembroke Building
    Amministratore
    Kensington Village
    Avonmore Road
    W14 8DG London
    Pembroke Building
    EnglandBritishVice President, Sapientnitro205439450001
    FINE, Kerry Ann
    Spronketts Spronketts Lane
    Bolney
    RH17 5SA Haywards Heath Warninglid
    West Sussex
    Amministratore
    Spronketts Spronketts Lane
    Bolney
    RH17 5SA Haywards Heath Warninglid
    West Sussex
    United KingdomBritishDirector39083640001
    FINE, Kerry Ann
    Spronketts Spronketts Lane
    Bolney
    RH17 5SA Haywards Heath Warninglid
    West Sussex
    Amministratore
    Spronketts Spronketts Lane
    Bolney
    RH17 5SA Haywards Heath Warninglid
    West Sussex
    United KingdomBritishMarketing Consultant39083640001
    FINE, Raymond Philip Ronald
    1 Battersea Bridge Road
    SW11 3BZ London
    The Glassmill
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Battersea Bridge Road
    SW11 3BZ London
    The Glassmill
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector23792490001
    FINE, Raymond Philip Ronald
    Spronketts Spronketts Lane
    Bolney
    RH17 5SA Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    Spronketts Spronketts Lane
    Bolney
    RH17 5SA Haywards Heath
    West Sussex
    EnglandBritishMarketing Consultant23792490001
    FOENANDER, John
    The Garden House
    Bentfield Place
    CM24 8HL Stansted
    Essex
    Amministratore
    The Garden House
    Bentfield Place
    CM24 8HL Stansted
    Essex
    BritishManaging Director45958310005
    FORD, Peter Charles, Doctor
    8 Spital Square
    E1 6DU London
    Eden House
    Amministratore
    8 Spital Square
    E1 6DU London
    Eden House
    United KingdomBritishManagement169109790001
    FREEDMAN, Anthony
    Ground Floor
    101 Sutherland Avenue
    W9 2HG London
    Amministratore
    Ground Floor
    101 Sutherland Avenue
    W9 2HG London
    BritishGroup Accounts Manager33498430001
    HEATH, Crispin Alexis
    107b Byrne Road
    SW12 9JA London
    Amministratore
    107b Byrne Road
    SW12 9JA London
    BritishClient Services95481350001
    HOWARD OF LYMPNE, Michael, Rt Hon
    66 Alderney Street
    SW1V 4EX London
    Amministratore
    66 Alderney Street
    SW1V 4EX London
    United KingdomBritishMember Of Parliament156283880001
    ISLIP, Michael John
    Kensington Village
    Avonmore Road
    W14 8DG London
    Pembroke Building
    Amministratore
    Kensington Village
    Avonmore Road
    W14 8DG London
    Pembroke Building
    EnglandBritishCeo202418430001
    JONES, Gareth Neil
    1 Battersea Bridge Road
    SW11 3BZ London
    The Glasshouse
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Battersea Bridge Road
    SW11 3BZ London
    The Glasshouse
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector82208930001
    MARCIANO, Ariel
    Kensington Village
    Avonmore Road
    W14 8DG London
    Pembroke Building
    Amministratore
    Kensington Village
    Avonmore Road
    W14 8DG London
    Pembroke Building
    United StatesFrenchChief Financial Officer205708370001

    Chi sono le persone con controllo significativo di DIGITAL AND DIRECT COMMUNICATIONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Timber Bush
    EH6 6QH Edinburgh
    51
    Scotland
    30 mar 2018
    Timber Bush
    EH6 6QH Edinburgh
    51
    Scotland
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneSc177425
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Avonmore Road
    W14 8DG London
    Pembroke Building
    England
    06 apr 2016
    Avonmore Road
    W14 8DG London
    Pembroke Building
    England
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03144067
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    DIGITAL AND DIRECT COMMUNICATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 26 mar 2007
    Consegnato il 28 mar 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company
    Transazioni
    • 28 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 and
    Creato il 12 ago 2005
    Consegnato il 26 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18 october 2004 and
    Creato il 27 lug 2005
    Consegnato il 04 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 mar 1999
    Consegnato il 17 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £686,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ray Fine
    Transazioni
    • 17 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent security deposit deed
    Creato il 05 mar 1999
    Consegnato il 09 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The due performance and observance of the covenants agreements and conditions on the part of the company under a lease dated 3RD march 1999 and all costs and expenses which the chargee may incur by reason or in consequence of any breach of the covenants agreements and conditions contained in the lease
    Brevi particolari
    The sum of £47,850.00 placed in an interest bearing deposit account together with any interest credited to the deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Shelton Properties Sarl
    Transazioni
    • 09 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 06 feb 1995
    Consegnato il 09 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 13 gen 1995
    Consegnato il 17 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the provisions of a sub-lease and this deed (as defined therein)
    Brevi particolari
    £17657.50 deposited by the company with its landlords. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor`S of Christ`S Hospital
    Transazioni
    • 17 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0