THE KEEP MOTOR GROUP (EPSOM) LIMITED

THE KEEP MOTOR GROUP (EPSOM) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE KEEP MOTOR GROUP (EPSOM) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02574080
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE KEEP MOTOR GROUP (EPSOM) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova THE KEEP MOTOR GROUP (EPSOM) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE KEEP MOTOR GROUP (EPSOM) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CARTOW LIMITED16 gen 199116 gen 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE KEEP MOTOR GROUP (EPSOM) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per THE KEEP MOTOR GROUP (EPSOM) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Arriva Plc 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland SR3 3XP in data 14 set 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 04 set 2012

    LRESSP

    Cessazione della carica di Martin James Hibbert come amministratore in data 28 ago 2012

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 26 mag 2012

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 02 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 nov 2011

    Stato del capitale al 03 nov 2011

    • Capitale: GBP 400,002
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Nomina di Kenneth Mcintyre Carlaw come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Turner come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Martin James Hibbert come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen Lonsdale come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 02 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Stephen Philip Lonsdale il 02 nov 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Paul Turner il 02 nov 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 02 nov 2010

    1 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 nov 2009

    14 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    6 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di THE KEEP MOTOR GROUP (EPSOM) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAVIES, Elizabeth Anne
    C/O Arriva Plc
    1 Admiral Way Doxford
    SR3 3XP International Business Park
    Sunderland
    Segretario
    C/O Arriva Plc
    1 Admiral Way Doxford
    SR3 3XP International Business Park
    Sunderland
    British102907000002
    CARLAW, Kenneth Mcintyre
    Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11
    Amministratore
    Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11
    EnglandBritish161250030001
    SEAR MAYES, David
    25 Carisbrooke Road
    Mountsorrel
    LE12 7BR Loughborough
    Leicestershire
    Segretario
    25 Carisbrooke Road
    Mountsorrel
    LE12 7BR Loughborough
    Leicestershire
    British10555810001
    THORPE, Elizabeth Anne
    2 Oakwood
    DH7 0NP Lanchester
    County Durham
    Segretario
    2 Oakwood
    DH7 0NP Lanchester
    County Durham
    British102907000001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    VIRTUE, John
    91 Hollywood Avenue
    Gosforth
    NE3 5BU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    91 Hollywood Avenue
    Gosforth
    NE3 5BU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British102404840001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BELL, Joseph
    Highup 52 Binns Lane
    Holmfirth
    HD7 1BJ Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Highup 52 Binns Lane
    Holmfirth
    HD7 1BJ Huddersfield
    West Yorkshire
    British16822660001
    CLARKSON, Christopher
    57 Henbury Road
    Westbury-On-Trym
    BS9 3NP Bristol
    Avon
    Amministratore
    57 Henbury Road
    Westbury-On-Trym
    BS9 3NP Bristol
    Avon
    United KingdomBritish84819430001
    COWIE, Thomas, Sir
    Broadwood Hall
    DH7 0TD Lanchester
    County Durham
    Amministratore
    Broadwood Hall
    DH7 0TD Lanchester
    County Durham
    United KingdomBritish142033700001
    DAVISON, Gerald Richard
    Oak Farm
    Butchers Lane
    TA7 9LY Shapwick
    Somerset
    Amministratore
    Oak Farm
    Butchers Lane
    TA7 9LY Shapwick
    Somerset
    British37548680001
    HIBBERT, Martin James
    C/O Arriva Plc
    1 Admiral Way Doxford
    SR3 3XP International Business Park
    Sunderland
    Amministratore
    C/O Arriva Plc
    1 Admiral Way Doxford
    SR3 3XP International Business Park
    Sunderland
    EnglandBritish111092090001
    HODGSON, Gordon William
    Bramble House
    Easington Lane
    DH5 0QX Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Bramble House
    Easington Lane
    DH5 0QX Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    British1108360001
    JANE, Iain Stewart
    The Folly 53 Barmpton Lane
    DL1 3HH Darlington
    County Durham
    Amministratore
    The Folly 53 Barmpton Lane
    DL1 3HH Darlington
    County Durham
    British45241110001
    LONSDALE, Stephen Philip
    C/O Arriva Plc
    1 Admiral Way Doxford
    SR3 3XP International Business Park
    Sunderland
    Amministratore
    C/O Arriva Plc
    1 Admiral Way Doxford
    SR3 3XP International Business Park
    Sunderland
    United KingdomBritish4971910001
    O'HAGAN, Leonard John Patrick
    Moyallen
    11 Elton Park
    IRISH Sandycove
    County Dublin
    Ireland
    Amministratore
    Moyallen
    11 Elton Park
    IRISH Sandycove
    County Dublin
    Ireland
    Irish15365240001
    PYKETT, Terrance Neil
    Humblebee Hall
    WR7 4PF North Piddle
    Worcestershire
    Amministratore
    Humblebee Hall
    WR7 4PF North Piddle
    Worcestershire
    EnglandBritish8804520002
    RAY, John Alfred
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    Amministratore
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    British58415290001
    SEAR MAYES, David
    25 Carisbrooke Road
    Mountsorrel
    LE12 7BR Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    25 Carisbrooke Road
    Mountsorrel
    LE12 7BR Loughborough
    Leicestershire
    British10555810001
    TURNER, David Paul
    C/O Arriva Plc
    1 Admiral Way Doxford
    SR3 3XP International Business Park
    Sunderland
    Amministratore
    C/O Arriva Plc
    1 Admiral Way Doxford
    SR3 3XP International Business Park
    Sunderland
    United KingdomBritish48937720001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Amministratore delegato nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    THE KEEP MOTOR GROUP (EPSOM) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of charge
    Creato il 25 mar 1994
    Consegnato il 07 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge all book debts and other debts now and from time to time due or owing to the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 28 mag 1993
    Consegnato il 17 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge all book debts and other debts now and from time to time due or owing to the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 28 mag 1993
    Consegnato il 17 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    THE KEEP MOTOR GROUP (EPSOM) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 apr 2013Data di scioglimento
    04 set 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Timothy Clay
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praticante
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Rob Sadler
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praticante
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0