IMAGO 2014 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàIMAGO 2014 LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02575558
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di IMAGO 2014 LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso di apparecchiature e componenti elettronici e di telecomunicazione (46520) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova IMAGO 2014 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Odyssey Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di IMAGO 2014 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    IMAGO 2014 PLC19 set 201419 set 2014
    IMAGO GROUP PLC05 mar 200405 mar 2004
    IMAGO MICRO LIMITED10 lug 199110 lug 1991
    DIPLEMA 245 LIMITED21 gen 199121 gen 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di IMAGO 2014 LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 set 2020
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 giu 2021
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2019

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per IMAGO 2014 LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al21 gen 2020
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma04 feb 2020
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al21 gen 2019
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per IMAGO 2014 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ripristino per ordine del tribunale

    4 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2019

    2 pagineAA

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2018

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2017

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Kay Vickerage il 12 dic 2017

    1 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da "Genesis" Snelsmore Common Newbury RG14 3BG England a Odyssey Westridge Highclere Newbury RG20 9PX in data 12 dic 2017

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2016

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 gen 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio consolidato redatto al 30 set 2015

    25 pagineAA

    Nomina di Mrs Kay Vickerage come amministratore in data 01 apr 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 21 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 gen 2016

    Stato del capitale al 26 gen 2016

    • Capitale: GBP 51,984.1
    SH01

    Bilancio consolidato redatto al 30 set 2014

    35 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 gen 2015

    Stato del capitale al 22 gen 2015

    • Capitale: GBP 51,984.1
    SH01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 lug 2014 al 30 set 2014

    1 pagineAA01

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    4 pagineMR04

    Certificato di cambio di nome e ri-registrazione da Società Pubblica a Responsabilità Limitata a Privata

    1 pagineCERT11

    Riregistrazione del Memorandum e dello Statuto

    44 pagineMAR

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di ri-registrazione

    RES02

    Riregistrazione da società pubblica a società a responsabilità limitata privata

    1 pagineRR02

    Chi sono gli amministratori di IMAGO 2014 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VICKERAGE, Kay
    Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    Odyssey
    England
    Segretario
    Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    Odyssey
    England
    British12466950002
    GEORGE, Andrew
    54 Wentworth Gardens
    GU34 2BJ Alton
    Hampshire
    Amministratore
    54 Wentworth Gardens
    GU34 2BJ Alton
    Hampshire
    EnglandBritish115104730001
    VICKERAGE, Ian Geoffrey
    Snelsmore Common
    RG14 3BG Newbury
    "Genesis"
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Snelsmore Common
    RG14 3BG Newbury
    "Genesis"
    Berkshire
    England
    EnglandBritish24979700003
    VICKERAGE, Kay
    Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    Odyssey
    England
    Amministratore
    Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    Odyssey
    England
    EnglandBritish207223290001
    WEBSTER, Martin
    10 St Peters Place
    W9 2EE London
    Segretario nominato
    10 St Peters Place
    W9 2EE London
    British900005040001
    JONES, Kevin Gareth Brown
    52 Cartmel Drive
    Woodley
    RG5 3NG Reading
    Amministratore
    52 Cartmel Drive
    Woodley
    RG5 3NG Reading
    British62807710002
    REARDON, Jonathan Andrew
    Westfield Latchmore Bank
    Little Hallingbury
    CM22 7PH Bishop's Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore delegato nominato
    Westfield Latchmore Bank
    Little Hallingbury
    CM22 7PH Bishop's Stortford
    Hertfordshire
    British900005030001
    WEBSTER, Martin
    10 St Peters Place
    W9 2EE London
    Amministratore delegato nominato
    10 St Peters Place
    W9 2EE London
    British900005040001
    WRIGHT, Andrew John
    Acre Edge
    Longton By Passage, Walmer Bridge
    PR4 5RE Preston
    Lancashire
    Amministratore
    Acre Edge
    Longton By Passage, Walmer Bridge
    PR4 5RE Preston
    Lancashire
    EnglandBritish70446280001
    ZABOURA, Margaret
    15 Whiteknights Road
    RG6 7BY Reading
    Berkshire
    Amministratore
    15 Whiteknights Road
    RG6 7BY Reading
    Berkshire
    British60020330001
    ZARAIAH, Ralph
    31 Sycamore Close
    Garston
    WD2 6DF Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    31 Sycamore Close
    Garston
    WD2 6DF Watford
    Hertfordshire
    British45893470001

    Chi sono le persone con controllo significativo di IMAGO 2014 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Ian Geoffrey Vickerage
    Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    Odyssey
    England
    14 apr 2016
    Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    Odyssey
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    Mrs Kay Vickerage
    Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    Odyssey
    England
    14 apr 2016
    Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    Odyssey
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.

    IMAGO 2014 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    All assets debenture
    Creato il 31 gen 2012
    Consegnato il 02 feb 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 02 feb 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 24 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 10 ago 2004
    Consegnato il 28 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 02 ott 2003
    Consegnato il 18 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 18 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 16 lug 2003
    Consegnato il 19 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 19 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creato il 21 nov 2000
    Consegnato il 30 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The account with the bank denominated in sterlimg designated lloyds tsb PLC re imago micro limited and now numbered 7559424, all deposits with the bank's treasury division in the name of the bank re the company.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge
    Creato il 02 ott 2000
    Consegnato il 04 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 28 september 2000 (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed charge upon all book and other debts present and future and all things in action, floating charge the stock in trade and the whole of the charged assets described above.
    Persone aventi diritto
    • Ibm United Kingdom Financial Services Limited
    Transazioni
    • 04 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit deed
    Creato il 02 dic 1999
    Consegnato il 11 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and lease of even date
    Brevi particolari
    All the companys right title benefit and interest in and to the account in which the deposit of £11,940.35 is held together with a sum equivalent to vat thereon.
    Persone aventi diritto
    • Britel Developments (Thatcham) Limited
    Transazioni
    • 11 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deposit deed
    Creato il 02 dic 1999
    Consegnato il 09 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 2 december 1999
    Brevi particolari
    £11,940 due or to become due from the company to the chargee.
    Persone aventi diritto
    • Britel Developments (Thatcham) Limited
    Transazioni
    • 09 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2014Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 16 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge by way of debenture
    Creato il 10 feb 1998
    Consegnato il 14 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Close Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 14 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 apr 1994
    Consegnato il 11 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a financing agreement or on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all book debts and other debts other than such debts as the factor may have specifically agreed in writing to exclude from such charge. Floating charge on all book debts and other debts of the company which are not charged by way of fixed charge.
    Persone aventi diritto
    • Close Invoice Financing Limited
    Transazioni
    • 11 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 17 mar 1994
    Consegnato il 23 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 ago 1991
    Consegnato il 15 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures) (see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 29 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0