IMAGO 2014 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | IMAGO 2014 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02575558 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di IMAGO 2014 LIMITED?
- Commercio all'ingrosso di apparecchiature e componenti elettronici e di telecomunicazione (46520) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova IMAGO 2014 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Odyssey Westridge Highclere RG20 9PX Newbury England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di IMAGO 2014 LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| IMAGO 2014 PLC | 19 set 2014 | 19 set 2014 |
| IMAGO GROUP PLC | 05 mar 2004 | 05 mar 2004 |
| IMAGO MICRO LIMITED | 10 lug 1991 | 10 lug 1991 |
| DIPLEMA 245 LIMITED | 21 gen 1991 | 21 gen 1991 |
Quali sono gli ultimi bilanci di IMAGO 2014 LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 30 set 2020 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 giu 2021 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2019 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per IMAGO 2014 LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 21 gen 2020 |
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 04 feb 2020 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 21 gen 2019 |
| Scaduto | Sì |
Quali sono le ultime deposizioni per IMAGO 2014 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ripristino per ordine del tribunale | 4 pagine | AC92 | ||||||||||
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2019 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2018 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 gen 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2017 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 gen 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mrs Kay Vickerage il 12 dic 2017 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da "Genesis" Snelsmore Common Newbury RG14 3BG England a Odyssey Westridge Highclere Newbury RG20 9PX in data 12 dic 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2016 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 gen 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 30 set 2015 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mrs Kay Vickerage come amministratore in data 01 apr 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 30 set 2014 | 35 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 gen 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 lug 2014 al 30 set 2014 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 12 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome e ri-registrazione da Società Pubblica a Responsabilità Limitata a Privata | 1 pagine | CERT11 | ||||||||||
Riregistrazione del Memorandum e dello Statuto | 44 pagine | MAR | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Riregistrazione da società pubblica a società a responsabilità limitata privata | 1 pagine | RR02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di IMAGO 2014 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICKERAGE, Kay | Segretario | Westridge Highclere RG20 9PX Newbury Odyssey England | British | 12466950002 | ||||||
| GEORGE, Andrew | Amministratore | 54 Wentworth Gardens GU34 2BJ Alton Hampshire | England | British | 115104730001 | |||||
| VICKERAGE, Ian Geoffrey | Amministratore | Snelsmore Common RG14 3BG Newbury "Genesis" Berkshire England | England | British | 24979700003 | |||||
| VICKERAGE, Kay | Amministratore | Westridge Highclere RG20 9PX Newbury Odyssey England | England | British | 207223290001 | |||||
| WEBSTER, Martin | Segretario nominato | 10 St Peters Place W9 2EE London | British | 900005040001 | ||||||
| JONES, Kevin Gareth Brown | Amministratore | 52 Cartmel Drive Woodley RG5 3NG Reading | British | 62807710002 | ||||||
| REARDON, Jonathan Andrew | Amministratore delegato nominato | Westfield Latchmore Bank Little Hallingbury CM22 7PH Bishop's Stortford Hertfordshire | British | 900005030001 | ||||||
| WEBSTER, Martin | Amministratore delegato nominato | 10 St Peters Place W9 2EE London | British | 900005040001 | ||||||
| WRIGHT, Andrew John | Amministratore | Acre Edge Longton By Passage, Walmer Bridge PR4 5RE Preston Lancashire | England | British | 70446280001 | |||||
| ZABOURA, Margaret | Amministratore | 15 Whiteknights Road RG6 7BY Reading Berkshire | British | 60020330001 | ||||||
| ZARAIAH, Ralph | Amministratore | 31 Sycamore Close Garston WD2 6DF Watford Hertfordshire | British | 45893470001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di IMAGO 2014 LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mr Ian Geoffrey Vickerage | 14 apr 2016 | Westridge Highclere RG20 9PX Newbury Odyssey England | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
| |||
| Mrs Kay Vickerage | 14 apr 2016 | Westridge Highclere RG20 9PX Newbury Odyssey England | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
| |||
IMAGO 2014 LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| All assets debenture | Creato il 31 gen 2012 Consegnato il 02 feb 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 10 ago 2004 Consegnato il 28 ago 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 02 ott 2003 Consegnato il 18 ott 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 16 lug 2003 Consegnato il 19 lug 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deposit agreement to secure own liabilities | Creato il 21 nov 2000 Consegnato il 30 nov 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The account with the bank denominated in sterlimg designated lloyds tsb PLC re imago micro limited and now numbered 7559424, all deposits with the bank's treasury division in the name of the bank re the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 02 ott 2000 Consegnato il 04 ott 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 28 september 2000 (as defined) | |
Brevi particolari Fixed charge upon all book and other debts present and future and all things in action, floating charge the stock in trade and the whole of the charged assets described above. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deposit deed | Creato il 02 dic 1999 Consegnato il 11 dic 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and lease of even date | |
Brevi particolari All the companys right title benefit and interest in and to the account in which the deposit of £11,940.35 is held together with a sum equivalent to vat thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deposit deed | Creato il 02 dic 1999 Consegnato il 09 dic 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 2 december 1999 | |
Brevi particolari £11,940 due or to become due from the company to the chargee. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge by way of debenture | Creato il 10 feb 1998 Consegnato il 14 feb 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 28 apr 1994 Consegnato il 11 mag 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a financing agreement or on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge over all book debts and other debts other than such debts as the factor may have specifically agreed in writing to exclude from such charge. Floating charge on all book debts and other debts of the company which are not charged by way of fixed charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Single debenture | Creato il 17 mar 1994 Consegnato il 23 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 04 ago 1991 Consegnato il 15 ago 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Including trade fixtures) (see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0