D P ROGERS INSURANCE HOLDINGS LIMITED.

D P ROGERS INSURANCE HOLDINGS LIMITED.

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàD P ROGERS INSURANCE HOLDINGS LIMITED.
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02577025
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di D P ROGERS INSURANCE HOLDINGS LIMITED.?

    • (6603) /
    • (7415) /

    Dove si trova D P ROGERS INSURANCE HOLDINGS LIMITED.?

    Indirizzo della sede legale
    Towergate House Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Kent
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di D P ROGERS INSURANCE HOLDINGS LIMITED.?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FIJI LIMITED28 gen 199128 gen 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di D P ROGERS INSURANCE HOLDINGS LIMITED.?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per D P ROGERS INSURANCE HOLDINGS LIMITED.?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagine4.71

    Cessazione della carica di Timothy Duncan Philip come amministratore in data 30 giu 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Scott Egan come amministratore in data 19 apr 2012

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Scott Egan come amministratore in data 19 apr 2012

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 12 dic 2011

    LRESSP

    Cessazione della carica di Andrew Hunter come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Samuel Thomas Budgen Clark come segretario

    1 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 28 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 feb 2011

    Stato del capitale al 15 feb 2011

    • Capitale: GBP 500,000
    SH01

    Nomina di Mr Andrew Stewart Hunter come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Darryl Clark come segretario

    1 pagineTM02

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Nomina di Mr Darryl Clark come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Timothy Craton come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 28 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Timothy Charles Craton il 28 gen 2010

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter Geoffrey Cullum il 28 gen 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Charles Homer il 28 gen 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy Duncan Philip il 28 gen 2010

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    6 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di D P ROGERS INSURANCE HOLDINGS LIMITED.?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Segretario
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    161862620001
    CULLUM, Peter Geoffrey
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    Amministratore
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    EnglandBritish59873490009
    HOMER, Andrew Charles
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    Amministratore
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    United KingdomBritish13483140003
    CLARK, Darryl
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Segretario
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    152464130001
    CRATON, Timothy Charles
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    Segretario
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    British76055420004
    HUNTER, Andrew Stewart
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Segretario
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    156181670001
    MILLER, Gordon Douglas
    Foxdene Dry Arch Road
    Sunningdale
    SL5 0DB Ascot
    Berkshire
    Segretario
    Foxdene Dry Arch Road
    Sunningdale
    SL5 0DB Ascot
    Berkshire
    British1161870001
    ZANT BOER, Ian
    Garden Cottage
    Little Court
    NN12 8HE Farthingstone
    Northamptonshire
    Segretario
    Garden Cottage
    Little Court
    NN12 8HE Farthingstone
    Northamptonshire
    British80009300004
    ZANT BOER, Ian
    Grange Meadow
    Duncote
    NN12 8AH Towcester
    Northamptonshire
    Segretario
    Grange Meadow
    Duncote
    NN12 8AH Towcester
    Northamptonshire
    British80009300001
    FOXDENE MANAGEMENT LIMITED
    Foxdene Dry Arch Road
    Sunningdale
    SL5 0DB Ascot
    Berkshire
    Segretario
    Foxdene Dry Arch Road
    Sunningdale
    SL5 0DB Ascot
    Berkshire
    1255610001
    HP DIRECTORS LIMITED
    Oxford House
    Cliftonville
    NN1 5PN Northampton
    Northamptonshire
    Segretario nominato
    Oxford House
    Cliftonville
    NN1 5PN Northampton
    Northamptonshire
    900002660001
    DALZELL, William Roger
    Weston Green Barn
    Weston Colville
    CB1 5NS Cambridge
    Amministratore
    Weston Green Barn
    Weston Colville
    CB1 5NS Cambridge
    British37108600002
    DELVES, Maria Jane
    Mavericks
    Firtree Lane
    LE17 6BH Swinford
    Leicestershire
    Amministratore
    Mavericks
    Firtree Lane
    LE17 6BH Swinford
    Leicestershire
    British85856710001
    EGAN, Scott
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Amministratore
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    EnglandBritish170703910001
    FENNEMORE, Roger Arnold
    Yew Tree Farm
    Sherington
    MK16 Newport Pagnel
    Bucks
    Amministratore
    Yew Tree Farm
    Sherington
    MK16 Newport Pagnel
    Bucks
    British9399600001
    MACIVER, Kenneth
    The Poplars
    The Green
    TN12 8JS Horsmonden
    Kent
    Amministratore
    The Poplars
    The Green
    TN12 8JS Horsmonden
    Kent
    British70920700002
    MILLER, Gordon Douglas
    Foxdene Dry Arch Road
    Sunningdale
    SL5 0DB Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Foxdene Dry Arch Road
    Sunningdale
    SL5 0DB Ascot
    Berkshire
    EnglandBritish1161870001
    MILLER, Gordon Frederick
    Cosgrove Hall Stratford Road
    Cosgrove
    MK19 7JA Milton Keynes
    Northamptonshire
    Amministratore
    Cosgrove Hall Stratford Road
    Cosgrove
    MK19 7JA Milton Keynes
    Northamptonshire
    United KingdomBritish55876380001
    MILLER, Gordon Douglas
    Foxdene Dry Arch Road
    Sunningdale
    SL5 0DB Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Foxdene Dry Arch Road
    Sunningdale
    SL5 0DB Ascot
    Berkshire
    EnglandBritish1161870001
    PHILIP, Timothy Duncan
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    Amministratore
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    United KingdomBritish99066410001
    POTTER, Raymond
    22 Laburnham Grove
    Chiswell Green
    St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    22 Laburnham Grove
    Chiswell Green
    St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish32080400002
    RIDDING, David Stanley
    2 Elm Drive
    NN13 6ES Brackley
    Northamptonshire
    Amministratore
    2 Elm Drive
    NN13 6ES Brackley
    Northamptonshire
    EnglandBritish29361510001
    ROGERS, Derek Prior
    Apartment 25 Gayhurst House
    Gayhurst
    MK16 8LG Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Apartment 25 Gayhurst House
    Gayhurst
    MK16 8LG Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    EnglandBritish70967570003
    SHARP, William Stanley
    4 Murcott Close
    Murcott Long Buckby
    NN6 7QR Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    4 Murcott Close
    Murcott Long Buckby
    NN6 7QR Northampton
    Northamptonshire
    British64491570001
    SHAW, Graham Peter
    158 Uxbridge Road
    Harrow Weald
    HA3 6TY Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    158 Uxbridge Road
    Harrow Weald
    HA3 6TY Harrow
    Middlesex
    British11019500001
    FOXDENE MANAGEMENT LIMITED
    Foxdene Dry Arch Road
    Sunningdale
    SL5 0DB Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Foxdene Dry Arch Road
    Sunningdale
    SL5 0DB Ascot
    Berkshire
    1255610001
    HP DIRECTORS LIMITED
    Oxford House
    Cliftonville
    NN1 5PN Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore delegato nominato
    Oxford House
    Cliftonville
    NN1 5PN Northampton
    Northamptonshire
    900002660001

    D P ROGERS INSURANCE HOLDINGS LIMITED. ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and debenture
    Creato il 22 apr 2003
    Consegnato il 29 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the security trustee, the lender, the mezzanine lender, the overdraft bank and the hedging bank, and to any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland as the Security Trustee
    Transazioni
    • 29 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 21 dic 2001
    Consegnato il 05 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 21 and 23 sheaf street daventry northamptonshire. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 dic 2001
    Consegnato il 05 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 06 apr 2001
    Consegnato il 11 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    21-23 sheaf street daventry northamptonshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 05 nov 1993
    Consegnato il 17 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 apr 1991
    Consegnato il 14 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    By legal mortgage all f/h and l/h property now rested in the company see form 395 for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Gordon Miller
    • Roger Fennemore and Foxdene Management Limited
    • John Taylor Williams
    • Willis Dawson Holdings Limited
    Transazioni
    • 14 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 21 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    D P ROGERS INSURANCE HOLDINGS LIMITED. ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    12 dic 2011Inizio della liquidazione
    02 feb 2013Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ruth Ellen Duncan
    Atherton Bailey
    Kent House
    ME15 6LH Romney Place
    Maidstone Kent
    Praticante
    Atherton Bailey
    Kent House
    ME15 6LH Romney Place
    Maidstone Kent

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0