NEAL'S YARD WHOLEFOODS LIMITED

NEAL'S YARD WHOLEFOODS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNEAL'S YARD WHOLEFOODS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02577877
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NEAL'S YARD WHOLEFOODS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova NEAL'S YARD WHOLEFOODS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Samuel Ryder House Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Warwickshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NEAL'S YARD WHOLEFOODS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DESERT SHIELD LIMITED29 gen 199129 gen 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di NEAL'S YARD WHOLEFOODS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per NEAL'S YARD WHOLEFOODS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 gen 2021 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Mr Matthew Giles Thomas Smith come segretario in data 01 gen 2021

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Lisa Mary Garley-Evans come amministratore in data 31 dic 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Lisa Mary Garley-Evans come segretario in data 31 dic 2020

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Matthew Giles Thomas Smith come amministratore in data 01 gen 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Anthony David Buffin come amministratore in data 02 ott 2020

    1 pagineTM01

    Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni

    2 pagineSH10

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 28 set 2020

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Nomina di Mr Robbie Ian Bell come amministratore in data 01 lug 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Gregory Alexander Watts come amministratore in data 01 lug 2020

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2019

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 gen 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Gregory Alexander Watts come amministratore in data 23 ott 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christian Keen come amministratore in data 23 ott 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Anthony David Buffin come amministratore in data 23 ott 2019

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017

    9 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di NEAL'S YARD WHOLEFOODS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMITH, Matthew Giles Thomas
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    Segretario
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    278473650001
    BELL, Robbie Ian
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    EnglandBritish97384120002
    SMITH, Matthew Giles Thomas
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United KingdomBritish154170600002
    BROOKER, Wendy
    44 Merlin Grove
    BR3 3HU Beckenham
    Kent
    Segretario
    44 Merlin Grove
    BR3 3HU Beckenham
    Kent
    British22526050001
    BUCKELL, Stephen William
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    Segretario
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    British20341960001
    CRADDOCK, Roger
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Segretario
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    British20091330002
    DAVIES, John Richard Bridge
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    Segretario
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    British51554100001
    GARLEY-EVANS, Lisa Mary
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    Segretario
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    216301040001
    GOODYEAR, Terry
    22 Stamford Close
    EN6 5NW Potters Bar
    Hertfordshire
    Segretario
    22 Stamford Close
    EN6 5NW Potters Bar
    Hertfordshire
    British39284800001
    MONRO, Angus
    84 Macclesfield Road
    SK10 4AG Prestbury
    Cheshire
    Segretario
    84 Macclesfield Road
    SK10 4AG Prestbury
    Cheshire
    British79054360001
    NASH, Andrew
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    Segretario
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    British48592890001
    SADLER, John Michael
    12 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midland
    Segretario
    12 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midland
    British44018260001
    L & A SECRETARIAL LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Segretario nominato
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001450001
    ALDIS, Peter Howard
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Chief Executive OfficerIrish55735210005
    BUCKELL, Stephen William
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    Amministratore
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    British20341960001
    BUFFIN, Anthony David
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    EnglandBritish178011680002
    CRADDOCK, Roger
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    EnglandBritish20091330013
    DAY, Gillian Margaret
    Our House
    1 Meadow Brook Court
    DE12 7AX Appleby Magna
    Derbyshire
    Amministratore
    Our House
    1 Meadow Brook Court
    DE12 7AX Appleby Magna
    Derbyshire
    British55013960005
    FELLOWS, Jonathan
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish118296490001
    GARDINER, Linda Barbara Elizabeth
    Flat D 63 Winchester Street
    SW1V 4NU London
    Amministratore
    Flat D 63 Winchester Street
    SW1V 4NU London
    British9692590001
    GARLEY-EVANS, Lisa Mary
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United KingdomBritish210802400001
    GOLECHHA, Dipak
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    UsaBritish195451690001
    HARDY, Lysa Maria
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish165408450002
    KAMIL, Harvey
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican54421630001
    KEEN, Christian
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    EnglandBritish54544790004
    KENDRICK, Mark
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish133928070002
    KERSHAW, Graham Anthony
    24 Oakfield Road
    HD2 2XF Huddersfield
    Yorkshire
    Amministratore
    24 Oakfield Road
    HD2 2XF Huddersfield
    Yorkshire
    British8991780009
    LEVY, Daniel Philip
    67 Fountain House
    Park Street
    W1K 6HG London
    Amministratore
    67 Fountain House
    Park Street
    W1K 6HG London
    British85549940001
    LLOYD, Allen John
    Yew House
    Freasley
    B78 2EY Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    Yew House
    Freasley
    B78 2EY Tamworth
    Staffordshire
    British2270630001
    LLOYD, Peter Edward
    Southfield Coventry Road
    CV8 2FT Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    Southfield Coventry Road
    CV8 2FT Kenilworth
    Warwickshire
    British35546210001
    MCMENEMIE, Carolyn
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    EnglandBritish196411980001
    MEISTER, Stefan Mario
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Amministratore
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Swiss43550520003
    MONRO, Angus
    84 Macclesfield Road
    SK10 4AG Prestbury
    Cheshire
    Amministratore
    84 Macclesfield Road
    SK10 4AG Prestbury
    Cheshire
    EnglandBritish79054360001
    MORAN, Martin Philip
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    Northern IrelandIrish196412390001
    MORAN, Martin Philip
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    United KingdomIrish88328810002

    Chi sono le persone con controllo significativo di NEAL'S YARD WHOLEFOODS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Holland & Barrett Retail Limited
    Barling Way
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    England
    06 apr 2016
    Barling Way
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies Registry Of England & Wales
    Numero di registrazione02758955
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    NEAL'S YARD WHOLEFOODS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 06 giu 1994
    Consegnato il 14 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Pml Group Limited
    Transazioni
    • 14 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 gen 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 set 1991
    Consegnato il 11 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais Bank Nederland N.V.
    Transazioni
    • 11 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 30 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0