NEAL'S YARD WHOLEFOODS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | NEAL'S YARD WHOLEFOODS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02577877 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di NEAL'S YARD WHOLEFOODS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova NEAL'S YARD WHOLEFOODS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Samuel Ryder House Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Warwickshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di NEAL'S YARD WHOLEFOODS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| DESERT SHIELD LIMITED | 29 gen 1991 | 29 gen 1991 |
Quali sono gli ultimi bilanci di NEAL'S YARD WHOLEFOODS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per NEAL'S YARD WHOLEFOODS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 gen 2021 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Matthew Giles Thomas Smith come segretario in data 01 gen 2021 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lisa Mary Garley-Evans come amministratore in data 31 dic 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lisa Mary Garley-Evans come segretario in data 31 dic 2020 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Matthew Giles Thomas Smith come amministratore in data 01 gen 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anthony David Buffin come amministratore in data 02 ott 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni | 2 pagine | SH10 | ||||||||||
Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni | 2 pagine | SH08 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 28 set 2020
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Robbie Ian Bell come amministratore in data 01 lug 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gregory Alexander Watts come amministratore in data 01 lug 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2019 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 gen 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Gregory Alexander Watts come amministratore in data 23 ott 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christian Keen come amministratore in data 23 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Anthony David Buffin come amministratore in data 23 ott 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 gen 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di NEAL'S YARD WHOLEFOODS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITH, Matthew Giles Thomas | Segretario | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire | 278473650001 | |||||||
| BELL, Robbie Ian | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire | England | British | 97384120002 | |||||
| SMITH, Matthew Giles Thomas | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire | United Kingdom | British | 154170600002 | |||||
| BROOKER, Wendy | Segretario | 44 Merlin Grove BR3 3HU Beckenham Kent | British | 22526050001 | ||||||
| BUCKELL, Stephen William | Segretario | Wykin House Wykin LE10 3PN Hinckley Leicestershire | British | 20341960001 | ||||||
| CRADDOCK, Roger | Segretario | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire United Kingdom | British | 20091330002 | ||||||
| DAVIES, John Richard Bridge | Segretario | Amberley 5 Primrose Hill Waste Lane CW6 0PE Kelsall Cheshire | British | 51554100001 | ||||||
| GARLEY-EVANS, Lisa Mary | Segretario | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire | 216301040001 | |||||||
| GOODYEAR, Terry | Segretario | 22 Stamford Close EN6 5NW Potters Bar Hertfordshire | British | 39284800001 | ||||||
| MONRO, Angus | Segretario | 84 Macclesfield Road SK10 4AG Prestbury Cheshire | British | 79054360001 | ||||||
| NASH, Andrew | Segretario | Lych Gates Angel Street Upper Bentley B97 5TA Redditch Worcestershire | British | 48592890001 | ||||||
| SADLER, John Michael | Segretario | 12 Cransley Grove B91 3ZA Solihull West Midland | British | 44018260001 | ||||||
| L & A SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 31 Corsham Street N1 6DR London | 900001450001 | |||||||
| ALDIS, Peter Howard | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire United Kingdom | Chief Executive Officer | Irish | 55735210005 | |||||
| BUCKELL, Stephen William | Amministratore | Wykin House Wykin LE10 3PN Hinckley Leicestershire | British | 20341960001 | ||||||
| BUFFIN, Anthony David | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire | England | British | 178011680002 | |||||
| CRADDOCK, Roger | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire United Kingdom | England | British | 20091330013 | |||||
| DAY, Gillian Margaret | Amministratore | Our House 1 Meadow Brook Court DE12 7AX Appleby Magna Derbyshire | British | 55013960005 | ||||||
| FELLOWS, Jonathan | Amministratore | 26 Ladywood Road Four Oaks B74 2QN Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 118296490001 | |||||
| GARDINER, Linda Barbara Elizabeth | Amministratore | Flat D 63 Winchester Street SW1V 4NU London | British | 9692590001 | ||||||
| GARLEY-EVANS, Lisa Mary | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire | United Kingdom | British | 210802400001 | |||||
| GOLECHHA, Dipak | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire | Usa | British | 195451690001 | |||||
| HARDY, Lysa Maria | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire United Kingdom | United Kingdom | British | 165408450002 | |||||
| KAMIL, Harvey | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire United Kingdom | United States | American | 54421630001 | |||||
| KEEN, Christian | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire United Kingdom | England | British | 54544790004 | |||||
| KENDRICK, Mark | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire United Kingdom | United Kingdom | British | 133928070002 | |||||
| KERSHAW, Graham Anthony | Amministratore | 24 Oakfield Road HD2 2XF Huddersfield Yorkshire | British | 8991780009 | ||||||
| LEVY, Daniel Philip | Amministratore | 67 Fountain House Park Street W1K 6HG London | British | 85549940001 | ||||||
| LLOYD, Allen John | Amministratore | Yew House Freasley B78 2EY Tamworth Staffordshire | British | 2270630001 | ||||||
| LLOYD, Peter Edward | Amministratore | Southfield Coventry Road CV8 2FT Kenilworth Warwickshire | British | 35546210001 | ||||||
| MCMENEMIE, Carolyn | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire | England | British | 196411980001 | |||||
| MEISTER, Stefan Mario | Amministratore | Rosengartenstrasse 19 70184 Stuttgart Germany | Swiss | 43550520003 | ||||||
| MONRO, Angus | Amministratore | 84 Macclesfield Road SK10 4AG Prestbury Cheshire | England | British | 79054360001 | |||||
| MORAN, Martin Philip | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire | Northern Ireland | Irish | 196412390001 | |||||
| MORAN, Martin Philip | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire United Kingdom | United Kingdom | Irish | 88328810002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di NEAL'S YARD WHOLEFOODS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland & Barrett Retail Limited | 06 apr 2016 | Barling Way CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
NEAL'S YARD WHOLEFOODS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 06 giu 1994 Consegnato il 14 giu 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 03 set 1991 Consegnato il 11 set 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0