RESPOND SOFTWARE LIMITED

RESPOND SOFTWARE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRESPOND SOFTWARE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02579049
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RESPOND SOFTWARE LIMITED?

    • (7260) /

    Dove si trova RESPOND SOFTWARE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Pioneer House
    7 Rushmills
    NN4 7YB Northampton
    Northamptonshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RESPOND SOFTWARE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RESPOND GROUP LIMITED14 mar 200214 mar 2002
    INITIATIVE SOFTWARE APPLICATIONS LIMITED01 feb 199101 feb 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di RESPOND SOFTWARE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per RESPOND SOFTWARE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 gen 2008

    2 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    9 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di RESPOND SOFTWARE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KANTELIP, Raphael
    Duke Street
    SL4 1SJ Windsor
    57
    Berkshire
    Uk
    Segretario
    Duke Street
    SL4 1SJ Windsor
    57
    Berkshire
    Uk
    FrenchFinancial Controller140548460001
    KANTELIP, Raphael
    Duke Street
    SL4 1SJ Windsor
    57
    Berkshire
    Uk
    Amministratore
    Duke Street
    SL4 1SJ Windsor
    57
    Berkshire
    Uk
    United KingdomFrenchFinancial Controller140548460001
    LAVELLE, Matthew
    Concord Creek Trail
    GA 30041 Cumming
    2430
    Goergia
    Amministratore
    Concord Creek Trail
    GA 30041 Cumming
    2430
    Goergia
    United StatesAmericanVp, Finance137900080001
    BLACKMORE, William Nelson Lindsay
    14 St Georges Square
    PE9 2BN Stamford
    Lincolnshire
    Segretario
    14 St Georges Square
    PE9 2BN Stamford
    Lincolnshire
    British5554130002
    COEN, Timothy Fredericks
    Davis Drive
    GA 30327 Atlanta
    1000
    Georgia
    Usa
    Segretario
    Davis Drive
    GA 30327 Atlanta
    1000
    Georgia
    Usa
    AmericanSenior Vp & General Counsel133948260001
    MASSEUR, Franciscus Leonardus Lodewijk Arthur
    Divertimentostraat 4
    EC 1312 Almere
    Holland
    Segretario
    Divertimentostraat 4
    EC 1312 Almere
    Holland
    DutchVp Finance Emea117533800001
    NAUGHTON, Cathal Padraig
    20 Bridge Walk
    Beechwood Gardens
    MK19 6LD Deanshanger
    Northants
    Segretario
    20 Bridge Walk
    Beechwood Gardens
    MK19 6LD Deanshanger
    Northants
    IrishFinance Director83308370004
    TAYLOR, Robert William
    24 Pooley Green Road
    TW20 8AF Egham
    Surrey
    Segretario
    24 Pooley Green Road
    TW20 8AF Egham
    Surrey
    BritishSenior Counsel Emea115640040001
    ANDERSON, Jim
    125 Brushy Hill Road
    Newtown
    Ct 06470
    Usa
    Amministratore
    125 Brushy Hill Road
    Newtown
    Ct 06470
    Usa
    AmericanCompany Director73702300001
    BLACKMORE, William Nelson Lindsay
    14 St Georges Square
    PE9 2BN Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    14 St Georges Square
    PE9 2BN Stamford
    Lincolnshire
    BritishManagement Consultant5554130002
    BREARE, Michael
    10 Bedford Road
    MK43 9JT Wootton
    Bedfordshire
    Amministratore
    10 Bedford Road
    MK43 9JT Wootton
    Bedfordshire
    BritishDevelopment92144430001
    BUDENBERG, David Christian
    50 Main Street
    Medbourne
    LE16 8DT Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    50 Main Street
    Medbourne
    LE16 8DT Market Harborough
    Leicestershire
    BritishManagement Consultant84427000001
    CAMERON, Bruce Warren
    Oxmoor Court
    IL 60175 St Charles
    502
    Usa
    Amministratore
    Oxmoor Court
    IL 60175 St Charles
    502
    Usa
    OtherSvp129536790001
    COEN, Timothy Fredericks
    Davis Drive
    GA 30327 Atlanta
    1000
    Georgia
    Usa
    Amministratore
    Davis Drive
    GA 30327 Atlanta
    1000
    Georgia
    Usa
    AmericanSenior Vp & General Counsel133948260001
    FISH, Michael
    The Orchard
    Warnes Lane Burley
    BH24 4EQ Ringwood
    Hampshire
    Amministratore
    The Orchard
    Warnes Lane Burley
    BH24 4EQ Ringwood
    Hampshire
    BritishVenture Capital41058930001
    HEAVEY, James Fredrick
    21 Brockwell
    Oakley
    MK43 7TD Bedford
    Amministratore
    21 Brockwell
    Oakley
    MK43 7TD Bedford
    IrishManaging Director61332190001
    HOWARTH, Jonathan Mark
    The Boat House
    Cross Hill, Brixworth
    NN6 9DB Northampton
    Amministratore
    The Boat House
    Cross Hill, Brixworth
    NN6 9DB Northampton
    BritishSales And Marketing Director61832070002
    JEYNES, Roger David
    7 Tekels Avenue
    GU15 2LA Camberley
    Surrey
    Amministratore
    7 Tekels Avenue
    GU15 2LA Camberley
    Surrey
    EnglandBritishDirector54514460001
    MASSEUR, Franciscus Leonardus Lodewijk Arthur
    Divertimentostraat 4
    EC 1312 Almere
    Holland
    Amministratore
    Divertimentostraat 4
    EC 1312 Almere
    Holland
    DutchVp Finance Emea117533800001
    MERRYMAN, Adrian Iver
    Woodhaven
    Ivy Lane
    GU22 7BY Woking
    Surrey
    Amministratore
    Woodhaven
    Ivy Lane
    GU22 7BY Woking
    Surrey
    UsaVenture Capitalist68777750002
    MUSSER, Eric Wayne
    Sunset Drive
    GA 30071 Norcross
    727
    Usa
    Amministratore
    Sunset Drive
    GA 30071 Norcross
    727
    Usa
    UsaUnited StatesCeo129538330001
    NAUGHTON, Cathal Padraig
    20 Bridge Walk
    Beechwood Gardens
    MK19 6LD Deanshanger
    Northants
    Amministratore
    20 Bridge Walk
    Beechwood Gardens
    MK19 6LD Deanshanger
    Northants
    EnglandIrishFinance Director83308370004
    PASSMORE, Walter William
    Gardenside
    Higher Metcombe
    EX11 1SR Ottery St Mary
    Devon
    Amministratore
    Gardenside
    Higher Metcombe
    EX11 1SR Ottery St Mary
    Devon
    BritishDirector Consultant53532920001
    RANSOM, Graham Richard
    8 Fairacre
    Woolton Hill
    RG20 9UF Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    8 Fairacre
    Woolton Hill
    RG20 9UF Newbury
    Berkshire
    UkBritishCompany Director34690210001
    TAYLOR, Robert William
    24 Pooley Green Road
    TW20 8AF Egham
    Surrey
    Amministratore
    24 Pooley Green Road
    TW20 8AF Egham
    Surrey
    United KingdomBritishSenior Counsel Emea115640040001
    WILLIAMS, Peter Ronald Tudor
    30 Lydon Road
    Clapham
    SW4 0HW London
    Amministratore
    30 Lydon Road
    Clapham
    SW4 0HW London
    United KingdomBritishConsultant4707610001

    RESPOND SOFTWARE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 08 feb 2005
    Consegnato il 18 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Investments PLC (Security Trustee) for Itself and as Trustee on Behalf of the Lenders
    Transazioni
    • 18 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 feb 2005
    Consegnato il 17 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 17 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 mar 2002
    Consegnato il 19 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as initiative software applications limited) to the loan note holders and/or the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC (The Security Trustee), for Itself and as Trustee for Interregnum PLC
    Transazioni
    • 19 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 13 gen 1999
    Consegnato il 02 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The sum of £50,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 10021868 and earmarked or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 06 giu 1997
    Consegnato il 16 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0