TUMBUS THREE LIMITED

TUMBUS THREE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTUMBUS THREE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02580154
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TUMBUS THREE LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova TUMBUS THREE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o ERNST & YOUNG LLP
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TUMBUS THREE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ARRAN ISLE 2010 LIMITED13 lug 201013 lug 2010
    DOOR PANELS LIMITED16 nov 200916 nov 2009
    DOOR PANELS PLC28 mar 199128 mar 1991
    CLINTONWISH LIMITED05 feb 199105 feb 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di TUMBUS THREE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per TUMBUS THREE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    5 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Indirizzo della sede legale modificato da Premier Way Lowfields Business Park Elland West Yorkshire HX5 9HF in data 22 dic 2011

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 15 dic 2011

    LRESSP

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed arran isle 2010 LIMITED\certificate issued on 12/10/11
    2 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 10 ott 2011

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Dettagli del segretario cambiati per Mark Steven Wild il 08 ago 2011

    3 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mark Steven Wild il 08 ago 2011

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Michael James Russell Richards il 05 ago 2011

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert George Anthony Barr il 08 ago 2011

    3 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 feb 2011

    Stato del capitale al 09 feb 2011

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 06 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 02 lug 2010

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Cessazione della carica di Dean Rinaldi come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 06 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mark Steven Wild il 12 gen 2010

    3 pagineCH01

    legacy

    10 pagineMG01

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Financial doc 16/11/2009
    RES13

    legacy

    12 pagineMG01

    Certificato di ri-registrazione da Società Pubblica a Responsabilità Limitata a Privata

    1 pagineCERT10

    Chi sono gli amministratori di TUMBUS THREE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILD, Mark Steven
    Apartment 10
    Maple Gardens Birkby Road
    HD2 2DW Huddersfield
    Segretario
    Apartment 10
    Maple Gardens Birkby Road
    HD2 2DW Huddersfield
    British76447520003
    BARR, Robert George Anthony
    Main Street
    Linton
    LS22 4HT Wetherby
    Granary Cottage
    West Yorkshire
    Amministratore
    Main Street
    Linton
    LS22 4HT Wetherby
    Granary Cottage
    West Yorkshire
    United KingdomIrishDirector98335870004
    RICHARDS, Michael James Russell
    11 River View
    WF14 0HD Mirfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    11 River View
    WF14 0HD Mirfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector112600470001
    WILD, Mark Steven
    Apartment 10
    Maple Gardens Birkby Road
    HD2 2DW Huddersfield
    Amministratore
    Apartment 10
    Maple Gardens Birkby Road
    HD2 2DW Huddersfield
    United KingdomBritishAccountant76447520003
    BARRON, Ian
    28 Arkenley Lane
    Almondbury
    HD4 6SQ Huddersfield
    West Yorkshire
    Segretario
    28 Arkenley Lane
    Almondbury
    HD4 6SQ Huddersfield
    West Yorkshire
    British36470950002
    GEORGE, Christopher
    The Old Police House
    Hanley Swan
    WR8 0DN Worcester
    Worcestershire
    Segretario
    The Old Police House
    Hanley Swan
    WR8 0DN Worcester
    Worcestershire
    BritishManaging Director45367260001
    MARTIN, Terence John
    525 Holcombe Road
    Greenmount
    BL8 4EL Bury
    Lancashire
    Segretario
    525 Holcombe Road
    Greenmount
    BL8 4EL Bury
    Lancashire
    British802200001
    CCS SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900001720001
    ADAMS, John Stuart
    2 St Saviours Court Merick Road
    WR14 1DD Malvern
    Worcestershire
    Amministratore
    2 St Saviours Court Merick Road
    WR14 1DD Malvern
    Worcestershire
    BritishAccountant33172220002
    ADDAMS, Anthony Delaval
    14 Clarkes Way
    Welton
    NN11 5JJ Daventry
    Northamptonshire
    Amministratore
    14 Clarkes Way
    Welton
    NN11 5JJ Daventry
    Northamptonshire
    EnglandBritishDirector62658880001
    BEAUMONT, John Victor Robert
    Oakview 8 Baldenhall
    WR14 3RZ Malvern
    Worcestershire
    Amministratore
    Oakview 8 Baldenhall
    WR14 3RZ Malvern
    Worcestershire
    EnglandEnglishSales And Marketing Director45257620001
    BROADHEAD, Michael Robinson
    Broomhill
    Northgate Honley
    HD7 2QL Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Broomhill
    Northgate Honley
    HD7 2QL Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishManaging Director618330001
    CAMPBELL, Laurence James
    The Holt
    WF12 0PA Briestfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Holt
    WF12 0PA Briestfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director165808700001
    CHAMBERS, Sebastian George
    Park Farm
    Corsley
    BA12 7QH Warminster
    Wiltshire
    Amministratore
    Park Farm
    Corsley
    BA12 7QH Warminster
    Wiltshire
    United KingdomBritishDirector65142800001
    GEORGE, James Christopher Warrington
    Argus Farm
    Dymock Road
    HR8 2HU Ledbury
    Herefordshire
    Amministratore
    Argus Farm
    Dymock Road
    HR8 2HU Ledbury
    Herefordshire
    BritishMarketing Director34974320001
    GEORGE, Richard Warrington
    Ingleside Brotheridge Green Lane
    Hanley Castle
    WR8 0AU Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Ingleside Brotheridge Green Lane
    Hanley Castle
    WR8 0AU Worcester
    Worcestershire
    BritishProduction Director1777090001
    HATTON, John Leslie
    14 The Moorlands
    Malvern Wells
    WR14 4PS Malvern
    Worcestershire
    Amministratore
    14 The Moorlands
    Malvern Wells
    WR14 4PS Malvern
    Worcestershire
    BritishFinancial Director1777100001
    HINCHLIFFE, Ralph Eric
    Bank House
    New Mill
    HD7 7HU Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Bank House
    New Mill
    HD7 7HU Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishPublic Company Chairman8506150001
    HUNT, Kevin Robert Patrick
    37 Canons Gate
    CM20 1QG Harlow
    Essex
    Amministratore
    37 Canons Gate
    CM20 1QG Harlow
    Essex
    BritishMarketing Director44077240001
    MARTIN, Terence John
    525 Holcombe Road
    Greenmount
    BL8 4EL Bury
    Lancashire
    Amministratore
    525 Holcombe Road
    Greenmount
    BL8 4EL Bury
    Lancashire
    EnglandBritishChartered Accountant802200001
    MITCHELL, Graham John
    Sea Reach
    Kilhallon Woodlands
    PL24 2RJ Par
    Cornwall
    Amministratore
    Sea Reach
    Kilhallon Woodlands
    PL24 2RJ Par
    Cornwall
    United KingdomBritishDirector115652800001
    PARKER, Alan Thomas
    8 Loveday Drive
    CV32 6HZ Leamington Spa
    Amministratore
    8 Loveday Drive
    CV32 6HZ Leamington Spa
    EnglandUnited KingdomDirector2847310002
    PARKIN, Howard Leslie
    5 Silverwood Close
    Canford Magna
    BH21 1QZ Wimborne
    Dorset
    Amministratore
    5 Silverwood Close
    Canford Magna
    BH21 1QZ Wimborne
    Dorset
    BritishDirector16567180001
    PERKIN, Geoffrey Thomas
    4 Montpellier Drive
    GL50 1TX Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    4 Montpellier Drive
    GL50 1TX Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishProduction Director24094120001
    RINALDI, Dean
    3 Lyndley Chase
    Bishops Cleeve
    GL52 7YZ Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    3 Lyndley Chase
    Bishops Cleeve
    GL52 7YZ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishSales Director79741490002
    TONGUE, Nigel Charles Ellis
    The Moat House
    Britford
    SP5 4DX Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    The Moat House
    Britford
    SP5 4DX Salisbury
    Wiltshire
    BritishChartered Accountant15424070001
    CCS DIRECTORS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore delegato nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900001710001

    TUMBUS THREE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and trust debenture
    Creato il 18 nov 2009
    Consegnato il 27 nov 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Fountain Trustee Limited (As Trustee of the Heywood Williams Group PLC Pension and Life Assurance Plan) (the Pension Trustee))
    Transazioni
    • 27 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Composite guarantee and trust debenture
    Creato il 18 nov 2009
    Consegnato il 20 nov 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors or any of them to the chargee and/or the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Trustee)
    Transazioni
    • 20 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Composite guarantee and trust debenture
    Creato il 08 set 2006
    Consegnato il 19 set 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors or any of them to the chargee and/or the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Premier way lowfields business park elland west yorkshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (In Its Capacity as Trustee)
    Transazioni
    • 19 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 26 giu 2006
    Consegnato il 13 lug 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Trustees of the Heywood Williams Group Pension and Life Assurance Plan
    Transazioni
    • 13 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of accession to a composite guarantee and trust debenture dated 2 march 2004
    Creato il 30 apr 2004
    Consegnato il 05 mag 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the chargors to the trustee and/or the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC in Its Capacity as Agent and Trustee for the Beneficiaries (The Trustee)
    Transazioni
    • 05 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed and floating charge
    Creato il 28 ott 1991
    Consegnato il 08 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge on all book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 07 giu 1991
    Consegnato il 18 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    New welex plastic extrusion line (see form 395 relevant to this charge).
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited.
    Transazioni
    • 18 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 20 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TUMBUS THREE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 dic 2011Inizio della liquidazione
    27 giu 2013Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Charles Graham John King
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Praticante
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0