TUMBUS THREE LIMITED
Panoramica
Nome della società | TUMBUS THREE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02580154 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TUMBUS THREE LIMITED?
- (9999) /
Dove si trova TUMBUS THREE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | c/o ERNST & YOUNG LLP 1 Bridgewater Place Water Lane LS11 5QR Leeds West Yorkshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TUMBUS THREE LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ARRAN ISLE 2010 LIMITED | 13 lug 2010 | 13 lug 2010 |
DOOR PANELS LIMITED | 16 nov 2009 | 16 nov 2009 |
DOOR PANELS PLC | 28 mar 1991 | 28 mar 1991 |
CLINTONWISH LIMITED | 05 feb 1991 | 05 feb 1991 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TUMBUS THREE LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per TUMBUS THREE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 5 pagine | 4.71 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Premier Way Lowfields Business Park Elland West Yorkshire HX5 9HF in data 22 dic 2011 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed arran isle 2010 LIMITED\certificate issued on 12/10/11 | 2 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mark Steven Wild il 08 ago 2011 | 3 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mark Steven Wild il 08 ago 2011 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Michael James Russell Richards il 05 ago 2011 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert George Anthony Barr il 08 ago 2011 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 07 feb 2011 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 feb 2011 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 4 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Cessazione della carica di Dean Rinaldi come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 feb 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mark Steven Wild il 12 gen 2010 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
legacy | 10 pagine | MG01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 4 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 12 pagine | MG01 | ||||||||||
Certificato di ri-registrazione da Società Pubblica a Responsabilità Limitata a Privata | 1 pagine | CERT10 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di TUMBUS THREE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILD, Mark Steven | Segretario | Apartment 10 Maple Gardens Birkby Road HD2 2DW Huddersfield | British | 76447520003 | ||||||
BARR, Robert George Anthony | Amministratore | Main Street Linton LS22 4HT Wetherby Granary Cottage West Yorkshire | United Kingdom | Irish | Director | 98335870004 | ||||
RICHARDS, Michael James Russell | Amministratore | 11 River View WF14 0HD Mirfield West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 112600470001 | ||||
WILD, Mark Steven | Amministratore | Apartment 10 Maple Gardens Birkby Road HD2 2DW Huddersfield | United Kingdom | British | Accountant | 76447520003 | ||||
BARRON, Ian | Segretario | 28 Arkenley Lane Almondbury HD4 6SQ Huddersfield West Yorkshire | British | 36470950002 | ||||||
GEORGE, Christopher | Segretario | The Old Police House Hanley Swan WR8 0DN Worcester Worcestershire | British | Managing Director | 45367260001 | |||||
MARTIN, Terence John | Segretario | 525 Holcombe Road Greenmount BL8 4EL Bury Lancashire | British | 802200001 | ||||||
CCS SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 120 East Road N1 6AA London | 900001720001 | |||||||
ADAMS, John Stuart | Amministratore | 2 St Saviours Court Merick Road WR14 1DD Malvern Worcestershire | British | Accountant | 33172220002 | |||||
ADDAMS, Anthony Delaval | Amministratore | 14 Clarkes Way Welton NN11 5JJ Daventry Northamptonshire | England | British | Director | 62658880001 | ||||
BEAUMONT, John Victor Robert | Amministratore | Oakview 8 Baldenhall WR14 3RZ Malvern Worcestershire | England | English | Sales And Marketing Director | 45257620001 | ||||
BROADHEAD, Michael Robinson | Amministratore | Broomhill Northgate Honley HD7 2QL Huddersfield West Yorkshire | British | Managing Director | 618330001 | |||||
CAMPBELL, Laurence James | Amministratore | The Holt WF12 0PA Briestfield West Yorkshire | England | British | Company Director | 165808700001 | ||||
CHAMBERS, Sebastian George | Amministratore | Park Farm Corsley BA12 7QH Warminster Wiltshire | United Kingdom | British | Director | 65142800001 | ||||
GEORGE, James Christopher Warrington | Amministratore | Argus Farm Dymock Road HR8 2HU Ledbury Herefordshire | British | Marketing Director | 34974320001 | |||||
GEORGE, Richard Warrington | Amministratore | Ingleside Brotheridge Green Lane Hanley Castle WR8 0AU Worcester Worcestershire | British | Production Director | 1777090001 | |||||
HATTON, John Leslie | Amministratore | 14 The Moorlands Malvern Wells WR14 4PS Malvern Worcestershire | British | Financial Director | 1777100001 | |||||
HINCHLIFFE, Ralph Eric | Amministratore | Bank House New Mill HD7 7HU Huddersfield West Yorkshire | British | Public Company Chairman | 8506150001 | |||||
HUNT, Kevin Robert Patrick | Amministratore | 37 Canons Gate CM20 1QG Harlow Essex | British | Marketing Director | 44077240001 | |||||
MARTIN, Terence John | Amministratore | 525 Holcombe Road Greenmount BL8 4EL Bury Lancashire | England | British | Chartered Accountant | 802200001 | ||||
MITCHELL, Graham John | Amministratore | Sea Reach Kilhallon Woodlands PL24 2RJ Par Cornwall | United Kingdom | British | Director | 115652800001 | ||||
PARKER, Alan Thomas | Amministratore | 8 Loveday Drive CV32 6HZ Leamington Spa | England | United Kingdom | Director | 2847310002 | ||||
PARKIN, Howard Leslie | Amministratore | 5 Silverwood Close Canford Magna BH21 1QZ Wimborne Dorset | British | Director | 16567180001 | |||||
PERKIN, Geoffrey Thomas | Amministratore | 4 Montpellier Drive GL50 1TX Cheltenham Gloucestershire | British | Production Director | 24094120001 | |||||
RINALDI, Dean | Amministratore | 3 Lyndley Chase Bishops Cleeve GL52 7YZ Cheltenham Gloucestershire | British | Sales Director | 79741490002 | |||||
TONGUE, Nigel Charles Ellis | Amministratore | The Moat House Britford SP5 4DX Salisbury Wiltshire | British | Chartered Accountant | 15424070001 | |||||
CCS DIRECTORS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 120 East Road N1 6AA London | 900001710001 |
TUMBUS THREE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee and trust debenture | Creato il 18 nov 2009 Consegnato il 27 nov 2009 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee and trust debenture | Creato il 18 nov 2009 Consegnato il 20 nov 2009 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors or any of them to the chargee and/or the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee and trust debenture | Creato il 08 set 2006 Consegnato il 19 set 2006 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors or any of them to the chargee and/or the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Premier way lowfields business park elland west yorkshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 26 giu 2006 Consegnato il 13 lug 2006 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of accession to a composite guarantee and trust debenture dated 2 march 2004 | Creato il 30 apr 2004 Consegnato il 05 mag 2004 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company and the chargors to the trustee and/or the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating charge | Creato il 28 ott 1991 Consegnato il 08 nov 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari First fixed charge on all book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Chattels mortgage | Creato il 07 giu 1991 Consegnato il 18 giu 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari New welex plastic extrusion line (see form 395 relevant to this charge). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
TUMBUS THREE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0