QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02583461 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Synectics House 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SYNECTICS MANAGED SERVICES LIMITED | 17 apr 2010 | 17 apr 2010 |
| DIGITAL DIRECT LIMITED | 27 ago 1998 | 27 ago 1998 |
| ICM SECURITY PRODUCTS LIMITED | 10 ott 1995 | 10 ott 1995 |
| I C M DEVELOPMENTS LIMITED | 18 feb 1991 | 18 feb 1991 |
Quali sono gli ultimi bilanci di QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 nov 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2019 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 feb 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Michael Bedford come amministratore in data 06 gen 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Amanda Louise Larnder come amministratore in data 06 gen 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Synectics Plc Studley Point 88 Birmingham Road Studley Warwickshire B80 7AS a Synectics House 3-4 Broadfield Close Sheffield S8 0XN in data 02 dic 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2018 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mrs Amanda Louise Larnder come amministratore in data 18 apr 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Gerald Goodwin come amministratore in data 18 apr 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Beswick come amministratore in data 18 apr 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Claire Susan Stewart come segretario in data 04 mar 2019 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Beswick come segretario in data 04 mar 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 feb 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Simon Beswick come amministratore in data 30 nov 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Simon Beswick come segretario in data 30 nov 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael James Stilwell come amministratore in data 30 nov 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael James Stilwell come segretario in data 30 nov 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2017 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Mark Gerald Goodwin come amministratore in data 06 apr 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Paul Brierley come amministratore in data 06 apr 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Michael James Stilwell come segretario in data 06 apr 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEWART, Claire Susan | Segretario | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | 255934560001 | |||||||
| BEDFORD, David Michael | Amministratore | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | England | British | 302295360001 | |||||
| BESWICK, Simon | Segretario | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | 253087930001 | |||||||
| BRIERLEY, Richard Paul | Segretario | c/o Synectics Plc 88 Birmingham Road B80 7AS Studley Studley Point Warwickshire United Kingdom | 209176920001 | |||||||
| GERAGHTY, Paul Kevin Ian | Segretario | Monkwood Cottage Whitakers Way IG10 1SQ Loughton Essex | British | 86029660001 | ||||||
| GOSS, Mark William | Segretario | 57 Highfield Drive Royton OL2 6AF Oldham Lancashire | British | 3859880002 | ||||||
| HISCOCK, Bruce Edward Heath | Segretario | 2 Webbs Cottages The Green RG29 1HF North Warnborough Hampshire | British | 74922870001 | ||||||
| MIGHELL, Howard Stanley | Segretario | 25 Goldings Close Kings Hill ME19 4BE West Malling Kent | British | 60739240001 | ||||||
| POULTNEY, Nigel Charles | Segretario | 4 Holt Road B80 7NX Studley Warwickshire | British | 8488600002 | ||||||
| STILWELL, Michael James | Segretario | c/o Synectics Plc 88 Birmingham Road B80 7AS Studley Studley Point Warwickshire | 245091810001 | |||||||
| BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001550001 | |||||||
| BAKER, Terence Ernest | Amministratore | Pentewan Gravesend Road Wrotham TN15 7JS Sevenoaks Kent | British | 20512740001 | ||||||
| BENTLEY, Christopher John | Amministratore | 6 Cornwall Crescent Diggle OL3 5PW Oldham Lancashire | England | British | 49363770001 | |||||
| BESWICK, Simon | Amministratore | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | Scotland | British | 133770010001 | |||||
| BRIERLEY, Richard Paul | Amministratore | c/o Synectics Plc 88 Birmingham Road B80 7AS Studley Studley Point Warwickshire United Kingdom | United Kingdom | British | 209175910001 | |||||
| GERAGHTY, Paul Kevin Ian | Amministratore | Monkwood Cottage Whitakers Way IG10 1SQ Loughton Essex | United Kingdom | British | 86029660001 | |||||
| GOODWIN, Mark Gerald | Amministratore | c/o Synectics Plc 88 Birmingham Road B80 7AS Studley Studley Point Warwickshire | England | British | 233845210001 | |||||
| GOSS, Mark William | Amministratore | 57 Highfield Drive Royton OL2 6AF Oldham Lancashire | England | British | 3859880002 | |||||
| HISCOCK, Bruce Edward Heath | Amministratore | 2 Webbs Cottages The Green RG29 1HF North Warnborough Hampshire | United Kingdom | British | 74922870001 | |||||
| KENWAY, Ian David | Amministratore | 5 Duncote Grove Royton OL2 6LL Oldham Lancashire | British | 3859890003 | ||||||
| LARNDER, Amanda Louise | Amministratore | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | England | British | 257818550001 | |||||
| MIGHELL, Howard Stanley | Amministratore | 25 Goldings Close Kings Hill ME19 4BE West Malling Kent | United Kingdom | British | 60739240001 | |||||
| MOIR, William John Wallace | Amministratore | Shrublands Lockhampton Hill GL53 9QJ Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 394130001 | |||||
| MOIR, William John Wallace | Amministratore | Shrublands Lockhampton Hill GL53 9QJ Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 394130001 | |||||
| PARKER, Philip Hull | Amministratore | 1 Quarry Lane Lower Shiplake RG9 3JW Henley Oxfordshire | British | 99496350001 | ||||||
| POULTNEY, Nigel Charles | Amministratore | 4 Holt Road B80 7NX Studley Warwickshire | England | British | 8488600002 | |||||
| RICKS, Roy William | Amministratore | 87 St Marys Drive SS7 1LH Benfleet Essex | British | 68026600001 | ||||||
| SHEPHERD, John, Mr. | Amministratore | c/o Synectics Plc 88 Birmingham Road B80 7AS Studley Studley Point Warwickshire United Kingdom | United Kingdom | British | 151588320001 | |||||
| SINGLETON, Russell Craig | Amministratore | 417 Whirlowdale Road S11 9NG Sheffield South Yorkshire | England | British | 3492940001 | |||||
| SMITH, Clive Alan | Amministratore | The Spinney Devenish Lane SL5 9QU Ascot Berkshire | British | 62182450003 | ||||||
| STILWELL, Michael James | Amministratore | c/o Synectics Plc 88 Birmingham Road B80 7AS Studley Studley Point Warwickshire | England | British | 194783340001 | |||||
| TAYLOR, Roger | Amministratore | St Georges House St Georges Place GY1 2BH St Peter Port Guernsey | Channel Islands | British | 109462320001 | |||||
| UNWIN, Michael Richard | Amministratore | Beechcomber Station Road RH19 4NY Sharpethorne West Sussex | West Sussex | British | 43396130001 | |||||
| DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED | Amministratore delegato nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001540001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protec Plc | 06 apr 2016 | 88 Birmingham Road B80 7AS Studley Studley Point England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Creato il 29 mag 1996 Consegnato il 05 giu 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0