HERON HOLDINGS LIMITED

HERON HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHERON HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02585408
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HERON HOLDINGS LIMITED?

    • Vendita al dettaglio di autovetture usate (45112) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova HERON HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Barclays Bank Chambers
    Market Street
    HX7 6AD Hebden Bridge
    West Yorkshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HERON HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HERON GRANTHAM LIMITED02 dic 199302 dic 1993
    KEY WEST (GRANTHAM) LIMITED10 mag 199110 mag 1991
    LEONAWAY ENTERPRISES LIMITED25 feb 199125 feb 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di HERON HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per HERON HOLDINGS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per HERON HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Indirizzo della sede legale modificato da The Birches 2a Marlowe Drive Balderton Newark Nottinghamshire NG24 3QZ England a Barclays Bank Chambers Market Street Hebden Bridge West Yorkshire HX7 6AD in data 14 feb 2015

    1 pagineAD01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Veronica Jane Knill Theobald il 19 mar 2014

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Veronica Jane Knill Theobald il 19 mar 2014

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 18 the Lawns Collingham Newark Nottinghamshire NG23 7NT in data 19 mar 2014

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael David Theobald il 19 mar 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 25 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 feb 2014

    Stato del capitale al 26 feb 2014

    • Capitale: GBP 361,950
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2013

    6 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 25 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2011

    9 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    accounts-with-accounts-type-

    7 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2010 al 30 set 2010

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 25 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da Northern Road Newark Nottinghamshire NG24 2ET in data 01 mar 2011

    2 pagineAD01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2009

    21 pagineAA

    Nomina di Mrs Veronica Jane Knill Theobald come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di David Hodgson come segretario

    2 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di HERON HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    THEOBALD, Veronica Jane Knill
    2a Marlowe Drive
    Balderton
    NG24 3QZ Newark
    The Birches
    Nottinghamshire
    England
    Segretario
    2a Marlowe Drive
    Balderton
    NG24 3QZ Newark
    The Birches
    Nottinghamshire
    England
    154350610001
    THEOBALD, Michael David
    2a Marlowe Drive
    Balderton
    NG24 3QZ Newark
    The Birches
    Nottinghamshire
    England
    Amministratore
    2a Marlowe Drive
    Balderton
    NG24 3QZ Newark
    The Birches
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish26464880003
    THEOBALD, Veronica Jane Knill
    2a Marlowe Drive
    Balderton
    NG24 3QZ Newark
    The Birches
    Nottinghamshire
    England
    Amministratore
    2a Marlowe Drive
    Balderton
    NG24 3QZ Newark
    The Birches
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish29141950002
    HODGSON, David William
    23 Washingborough Road
    Heighington
    LN4 1QW Lincoln
    Lincolnshire
    Segretario
    23 Washingborough Road
    Heighington
    LN4 1QW Lincoln
    Lincolnshire
    British47003620002
    THEOBALD, Veronica Jane Knill
    18 The Lawns
    Collingham
    NG23 7NT Newark
    Nottinghamshire
    Segretario
    18 The Lawns
    Collingham
    NG23 7NT Newark
    Nottinghamshire
    British29141950001
    WAYGOOD WEST, Caroline Ann
    Swanage Farm
    Washpond Lane
    BH19 1QA Swanage
    Dorset
    Segretario
    Swanage Farm
    Washpond Lane
    BH19 1QA Swanage
    Dorset
    British75388970001
    WAYGOOD-WEST, Kevin
    14 Chedburgh Close
    Doddington Park
    LN6 0SU Lincoln
    Lincolnshire
    Segretario
    14 Chedburgh Close
    Doddington Park
    LN6 0SU Lincoln
    Lincolnshire
    British32923670001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Segretario nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    CLIFFORD, Stephen John
    67 Olney Road
    Emberton
    MK46 5BU Olney
    Buckinghamshire
    Amministratore
    67 Olney Road
    Emberton
    MK46 5BU Olney
    Buckinghamshire
    British43921070001
    FELL, John Michael
    59 Cliffe Road
    Ryhope Village
    SR2 0NW Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    59 Cliffe Road
    Ryhope Village
    SR2 0NW Sunderland
    Tyne & Wear
    British56249460001
    GREGORY, Robert
    48 Holmefield
    Farndon
    NG24 3TZ Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    48 Holmefield
    Farndon
    NG24 3TZ Newark
    Nottinghamshire
    British47003560001
    HEATHER, Philip William
    2 Spring Close
    Colwall
    WR13 6RE Malvern
    Worcestershire
    Amministratore
    2 Spring Close
    Colwall
    WR13 6RE Malvern
    Worcestershire
    English35271660001
    HODGSON, David William
    23 Washingborough Road
    Heighington
    LN4 1QW Lincoln
    Lincolnshire
    Amministratore
    23 Washingborough Road
    Heighington
    LN4 1QW Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritish47003620002
    ICETON, Ian Gordon
    7 Wharf View
    MK18 1XF Buckingham
    Amministratore
    7 Wharf View
    MK18 1XF Buckingham
    British53359540001
    WAYGOOD-WEST, Kevin
    14 Chedburgh Close
    Doddington Park
    LN6 0SU Lincoln
    Lincolnshire
    Amministratore
    14 Chedburgh Close
    Doddington Park
    LN6 0SU Lincoln
    Lincolnshire
    British32923670001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    HERON HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    General charge
    Creato il 03 ago 1994
    Consegnato il 05 ago 1994
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the companys assets present & future (including uncalled capital).
    Persone aventi diritto
    • Volkswagen Financial Services (UK) Limited
    Transazioni
    • 05 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 24 mar 1994
    Consegnato il 26 mar 1994
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All monies owing to the company by V.A.G. (united kingdom) limited in respect of refunds of monies paid by or by the direction of the company to V.A.G. (united kingdom) limited by way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis.
    Persone aventi diritto
    • Volkswagen Financial Services (UK) Limited
    Transazioni
    • 26 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    General charge
    Creato il 09 set 1993
    Consegnato il 10 set 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's assets present and future (including uncalled capital).
    Persone aventi diritto
    • V.A.G. Finance Limited
    Transazioni
    • 10 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    General charge
    Creato il 09 set 1993
    Consegnato il 10 set 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's assets present and future (including uncalled capital).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 10 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 19 ago 1992
    Consegnato il 21 ago 1992
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an offer letter dated 30TH may 1991
    Brevi particolari
    L/H land and premises situate at spittlegate level, grantham, lincs. As described in a lease dated 13.6.91. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • V.A.G. (United Kingdom) Limited
    Transazioni
    • 21 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 15 nov 1991
    Consegnato il 04 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & premises k/a keywest (grantham) limited,spittlegate level,grantham,lincolnshire and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 02 set 1991
    Consegnato il 05 set 1991
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies owing to the company in respect of refunds of monies paid by the company to V.A.G. (united kingdom) LTD. See 395 for details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 05 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 13 giu 1991
    Consegnato il 03 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 01 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0