ACRON LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ACRON LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02587656 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ACRON LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova ACRON LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | . Turnpike Road RG14 2NX Newbury Berkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di ACRON LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per ACRON LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 025876560003 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 025876560004 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 025876560004, creata il 26 ago 2016 | 50 pagine | MR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jacqueline Mary Marsh come amministratore in data 02 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Paul John Horton come amministratore in data 29 feb 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Guy Frederick St John Eaton come amministratore in data 18 mag 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Jacqueline Mary Marsh il 18 mag 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Jacqueline Mary Marsh come amministratore in data 18 mag 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Timothy Banks come amministratore in data 18 mag 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian Graham Cooper come amministratore in data 06 mag 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Guy Frederick St John Eaton come amministratore in data 23 mar 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Martin Mulligan come amministratore in data 23 mar 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ray John Cross come amministratore in data 12 mar 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 gen 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 28 dic 2013 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Fredericks come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Hartman House Danehill Lower Earley Reading Berkshire RG6 4PB* in data 09 mag 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Nomina di Mr Martin Mulligan come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ACRON LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANKS, Timothy | Amministratore | Turnpike Road RG14 2NX Newbury . Berkshire | United Kingdom | British | 177269610001 | |||||
| HORTON, Paul John | Amministratore | Turnpike Road RG14 2NX Newbury . Berkshire | United Kingdom | British | 169898500001 | |||||
| EELES, Eric John, Doctor | Segretario | 23 Mutton Oaks Binfield RG12 8LZ Bracknell Berkshire | British | 19130790002 | ||||||
| FAGAN, Michael Laurence | Segretario | Cin-Cin 32 Martins Drive RG11 1NY Wokingham Berks | British | 11730200001 | ||||||
| PROUDLOCK, Nicola Marie | Segretario | Garden Cottage West Meon GU32 1JL Petersfield Hampshire | British | 88234480003 | ||||||
| ALPHA SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 2nd Floor 83 Clerkenwell Road EC1R 5AR London | 900004510001 | |||||||
| BANKS, Michael Lawrence | Amministratore | St Mary Magdalene Church House AL7 4JS Welwyn Garden City Hertfordshire | British | 56963530003 | ||||||
| BIRD, Colin | Amministratore | Wheelwrights Forestside PO9 6ED Rowlands Castle Hampshire | British | 41129530002 | ||||||
| COOPER, Ian Graham | Amministratore | Bunces Lane RG8 7RH Collins End Westholme Barn United Kingdom | United Kingdom | British | 186068780001 | |||||
| CRAWFORD, David | Amministratore | Beechwood Red Rose Close IP12 3DG Alderton Woodbridge Suffolk | British | 25730440001 | ||||||
| CROSS, Ray John | Amministratore | Wormsley HR4 8LU Hereford Deerhaven United Kingdom | United Kingdom | British | 186071160001 | |||||
| DERRY, Simon John | Amministratore | Trevona Ashtead Woods Road KT21 2EX Ashtead Surrey | England | British | 89703280001 | |||||
| EATON, Guy Frederick St John | Amministratore | Turnpike Road RG14 2NX Newbury . Berkshire | England | British | 150889170002 | |||||
| EELES, Eric John, Doctor | Amministratore | 23 Mutton Oaks Binfield RG12 8LZ Bracknell Berkshire | British | 19130790002 | ||||||
| FREDERICKS, Peter George | Amministratore | Danehill Lower Earley RG6 4PB Reading Hartman House Berkshire England | England | British | 95853260003 | |||||
| LYON, David | Amministratore | Alison Cottage The Reeds Road, Frensham GU10 3DQ Farnham Surrey | United Kingdom | British | 126838980001 | |||||
| MARSH, Jacqueline Mary | Amministratore | Turnpike Road RG14 2NX Newbury . Berkshire | England | British | 198956590001 | |||||
| MULLIGAN, Martin | Amministratore | Wadham Close Southrop GL7 3NR Lechlade 3 United Kingdom | England | British | 66989250001 | |||||
| PITMAN, Graham Michael | Amministratore | Chiltern Cottage Christmas Common OX49 5HL Watlington Oxon | England | British | 13368750002 | |||||
| SCHOU-PEDERSON, Poul Erik | Amministratore | 31 Pinehill Road RG11 7JE Crowthorne Berkshire | Danish | 13691000001 | ||||||
| SNELL, Roderick Saxon | Amministratore | Island House Steep GU32 1AE Petersfield Hampshire | United Kingdom | British | 23873760001 | |||||
| SOMMERVILLE, Stuart Mckenzie | Amministratore | 15 Blackcap Close Rowlands Castle PO9 6HD Portsmouth Hampshire | British | 40950060001 | ||||||
| SPENCER, John Strathmore | Amministratore | Scairbhin Reen IRISH Union Hall County Cork Ireland | British | 69179790001 | ||||||
| SUBHERWAL, Naresh | Amministratore | 97 Park Crescent TW2 6NS Twickenham Middlesex | British | 62804520001 | ||||||
| YOULTON, David Alfred, Dr | Amministratore | Island West Steep GU32 1AE Petersfield Hampshire | United Kingdom | British | 6155150002 | |||||
| ALPHA DIRECT LIMITED | Amministratore delegato nominato | 2nd Floor 83 Clerkenwell Road EC1R 5AR London | 900001400001 |
ACRON LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 26 ago 2016 Consegnato il 05 set 2016 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 11 mar 2014 Consegnato il 27 mar 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Land on the north west side of cutbush close, lower earley, reading t/no BK262688. Land on the north west side of cutbush close, lower earley, reading t/no BK222477. Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 26 giu 2009 Consegnato il 03 lug 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each borrower and each other obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 24 feb 1995 Consegnato il 07 mar 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0