OLDNAME NO. 397 LIMITED

OLDNAME NO. 397 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOLDNAME NO. 397 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02589210
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OLDNAME NO. 397 LIMITED?

    • (3002) /

    Dove si trova OLDNAME NO. 397 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OLDNAME NO. 397 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DIAGNOSYS LIMITED11 giu 199111 giu 1991
    D.C.A.-I.L. SYSTEMS LIMITED20 mag 199120 mag 1991
    LETTERDETAIL LIMITED07 mar 199107 mar 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di OLDNAME NO. 397 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per OLDNAME NO. 397 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    20 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 gen 2019

    19 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da 10 Furnival Street London EC4A 1YH a 2nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EU in data 08 mar 2018

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    pagine2.34B

    Ripristino per ordine del tribunale

    2 pagineAC92

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    3 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 apr 2012

    10 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 apr 2011

    13 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da * 66 Wigmore Street London W1A 3RT* in data 04 mar 2011

    2 pagineAD01

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    9 pagine2.34B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    7 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 12 nov 2009

    6 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 12 nov 2009

    6 pagine2.24B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    15 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    30 pagine2.17B

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed diagnosys LIMITED\certificate issued on 26/06/09
    2 pagineCERTNM

    legacy

    1 pagine287

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di OLDNAME NO. 397 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GOULIMIS, Denise
    Lyford Cay Drive
    Lyford Cay
    Nassau
    Shuttlecock Cottage
    PO BOX N7776
    Bahamas
    Amministratore
    Lyford Cay Drive
    Lyford Cay
    Nassau
    Shuttlecock Cottage
    PO BOX N7776
    Bahamas
    Greek133964450001
    HARRISON, John Trevor
    Woodcote
    1b Harmer Dell
    AL6 0BE Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    Woodcote
    1b Harmer Dell
    AL6 0BE Welwyn
    Hertfordshire
    EnglandBritish120531710001
    HEASMAN, Philip
    Upper Edgeborough Road
    GU1 2BD Guildford
    1 Chaucer House
    Surrey
    Amministratore
    Upper Edgeborough Road
    GU1 2BD Guildford
    1 Chaucer House
    Surrey
    United KingdomAustralian63852560002
    MCINTOSH, Charles William Allistair
    Glenluce Road
    Blackheath
    SE3 7SD London
    37
    Amministratore
    Glenluce Road
    Blackheath
    SE3 7SD London
    37
    British133364010001
    MCINTOSH, Ian Alexander Neville
    83 Crown Lodge
    Elystan Street
    SW3 3PR London
    Amministratore
    83 Crown Lodge
    Elystan Street
    SW3 3PR London
    United KingdomBritish60901880002
    SMITH, Robert Louis
    Dragon Street
    GU31 4JJ Petersfield
    24-26
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Dragon Street
    GU31 4JJ Petersfield
    24-26
    Hampshire
    United Kingdom
    British131286830001
    WOODING, Jeremy Michael
    Maunsel Street
    Westminster
    SW1P 2QN London
    25
    Amministratore
    Maunsel Street
    Westminster
    SW1P 2QN London
    25
    EnglandBritish54883990002
    CHANT, John
    Comyn
    Upper Anstey Lane
    GU34 4BP Alton
    Hampshire
    Segretario
    Comyn
    Upper Anstey Lane
    GU34 4BP Alton
    Hampshire
    British34373580001
    WAKE, Nicholas
    Downlands, Wood Lane
    Seale
    GU10 1HB Farnham
    Surrey
    Segretario
    Downlands, Wood Lane
    Seale
    GU10 1HB Farnham
    Surrey
    British42620390002
    JORDAN COMPANY SECRETARIES LIMITED
    21 St Thomas Street
    BS1 6JS Bristol
    Avon
    Segretario nominato
    21 St Thomas Street
    BS1 6JS Bristol
    Avon
    900008790001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARNARD, Adam
    30 Burdenshott Avenue
    TW10 5ED Richmond
    Surrey
    Amministratore
    30 Burdenshott Avenue
    TW10 5ED Richmond
    Surrey
    South African65525620002
    BRIDLE, Mark Leslie
    15 Willow Way
    RH20 3BG Ashington
    West Sussex
    Amministratore
    15 Willow Way
    RH20 3BG Ashington
    West Sussex
    British8862860001
    CAWKELL, David
    Ford Arun Snailing Lane
    Greatham
    GU33 6HQ Liss
    Hampshire
    Amministratore
    Ford Arun Snailing Lane
    Greatham
    GU33 6HQ Liss
    Hampshire
    EnglandBritish29634190002
    LOCK, Maureen
    22 Orchard Mains
    GU22 0ET Woking
    Surrey
    Amministratore
    22 Orchard Mains
    GU22 0ET Woking
    Surrey
    South African78409990001
    TIPLIN, David Robert
    54 Newbolt Avenue
    SM3 8EE Cheam
    Surrey
    Amministratore
    54 Newbolt Avenue
    SM3 8EE Cheam
    Surrey
    EnglandBritish82007290001
    WAKE, Nicholas
    The Old Mill
    Kitts Lane
    DU10 2PJ Churt
    Surrey
    Amministratore
    The Old Mill
    Kitts Lane
    DU10 2PJ Churt
    Surrey
    British42620390003
    WELLAND, Paul Stephen
    116 Stakes Road
    Purbrook
    PO7 5PW Waterlooville
    Hampshire
    Amministratore
    116 Stakes Road
    Purbrook
    PO7 5PW Waterlooville
    Hampshire
    British13174060002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    OLDNAME NO. 397 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 22 ago 2008
    Consegnato il 28 ago 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 06 nov 2003
    Consegnato il 15 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 ott 2002
    Consegnato il 08 nov 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold properties units 2 and 3 petersfield business park, bedford road, petersfield, hampshire. Unit 15 petersfield business park, bedford road, petersfield, hampshire and unit 4 viceroy court, bedford road, petersfield, hampshire.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Grenadier Development Capital Fund 1 Limited Partnership Acting by Its General Partnergrenadier Capital General Partner Limited
    Transazioni
    • 08 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Instrument creating secured loan stock 2005 of the company
    Creato il 25 ott 2002
    Consegnato il 08 nov 2002
    In corso
    Importo garantito
    By way of continuing security in favour of the stockholder for the payment and discharge of secured loabn stock 2005 constituted by the secured loan stock instrument with a principal amount of £1,000,000 plus interest and costs
    Brevi particolari
    By way of a fixed charge all estate or interest in any freehold and leasehold property and any proceeds of sale now and in the future vested in the company. By way of a fixed charge all its right, title, interest and benefit present and future in and to the plant, machinery and fixtures and fittings at the property, the furniture, furnishings, equipment, tools and other chattels, the goodwill and uncalled capital, the book debts and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Grenadier Development Capital Fund 1 Limited Partnership Acting by Its General Partnergrenadier Capital General Partner Limited
    Transazioni
    • 08 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 30 giu 1999
    Consegnato il 09 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a plot e vision park petersfield hants. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 29 gen 1996
    Consegnato il 05 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    OLDNAME NO. 397 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    13 mag 2009Inizio dell'amministrazione
    07 apr 2010Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Philip Lewis Armstrong
    66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Praticante
    66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Nicholas H O'Reilly
    Po Box 2653, 66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Praticante
    Po Box 2653, 66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    2
    DataTipo
    07 apr 2010Inizio della liquidazione
    17 ott 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Philip Lewis Armstrong
    66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Praticante
    66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Nicholas H O'Reilly
    Po Box 2653, 66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Praticante
    Po Box 2653, 66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Geoffrey Paul Rowley
    10 Furnival Street
    EC4A 1YH London
    Praticante
    10 Furnival Street
    EC4A 1YH London
    Geoffrey Paul Rowley
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Praticante
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Philip Lewis Armstrong
    Frp Advisory Llp 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Praticante
    Frp Advisory Llp 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0