OLD LML LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOLD LML LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02595154
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OLD LML LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova OLD LML LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 2 Atworth Business Park
    Bath Road
    SN12 8SB Atworth, Melksham
    Wiltshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OLD LML LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LEAFIELD MARINE LIMITED23 giu 199923 giu 1999
    LEAFIELD SEABASS LIMITED28 giu 199128 giu 1991
    OVAL (704) LIMITED25 mar 199125 mar 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di OLD LML LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per OLD LML LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ott 2011

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 mar 2012

    Stato del capitale al 26 mar 2012

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 25 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ott 2010

    4 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2009

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per David Louis Dickins il 25 mar 2010

    2 pagineCH01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed leafield marine LIMITED\certificate issued on 28/10/09
    2 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 16 ott 2009

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2008

    12 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2007

    12 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 ott 2006

    18 pagineAA

    legacy

    6 pagine155(6)a

    legacy

    7 pagine395

    legacy

    1 pagine287

    Chi sono gli amministratori di OLD LML LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CHAPPLE, Timothy Jonathan
    10 St Mellion Close
    Monkton Park
    SN15 3XN Chippenham
    Wiltshire
    Segretario
    10 St Mellion Close
    Monkton Park
    SN15 3XN Chippenham
    Wiltshire
    BritishChartered Accountant & Co. Dir28933940004
    CHAPPLE, Timothy Jonathan
    10 St Mellion Close
    Monkton Park
    SN15 3XN Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    10 St Mellion Close
    Monkton Park
    SN15 3XN Chippenham
    Wiltshire
    United KingdomBritishChartered Accountant & Co. Dir28933940004
    DICKINS, David Louis
    6 Greenfield Road
    SN10 5BP Devizes
    Wiltshire
    Amministratore
    6 Greenfield Road
    SN10 5BP Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritishCompany Director65876450001
    CHAPPLE, Timothy Jonathan
    10 St Mellion Close
    Monkton Park
    SN15 3XN Chippenham
    Wiltshire
    Segretario
    10 St Mellion Close
    Monkton Park
    SN15 3XN Chippenham
    Wiltshire
    BritishFinancial Director28933940004
    ELLARD, Sarah Louise
    7 Danehurst Place
    Locks Heath
    SO31 6PP Southampton
    Hampshire
    Segretario
    7 Danehurst Place
    Locks Heath
    SO31 6PP Southampton
    Hampshire
    British43855640011
    FORSYTH, Nigel John
    Park Farm Barn
    PO7 4SB Hambledon
    Hampshire
    Segretario
    Park Farm Barn
    PO7 4SB Hambledon
    Hampshire
    BritishCompany Director59380470002
    WHADCOCK, Stephen Arthur
    75 Nursteed Road
    SN10 3AJ Devizes
    Wiltshire
    Segretario
    75 Nursteed Road
    SN10 3AJ Devizes
    Wiltshire
    British6425330001
    BLOTT, James
    The Rest
    West Street
    PO7 4RW Hambledon
    Hampshire
    Amministratore
    The Rest
    West Street
    PO7 4RW Hambledon
    Hampshire
    BritishCompany Director59380580002
    CHAPPLE, Timothy Jonathan
    10 St Mellion Close
    Monkton Park
    SN15 3XN Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    10 St Mellion Close
    Monkton Park
    SN15 3XN Chippenham
    Wiltshire
    United KingdomBritishFinancial Director28933940004
    DYKE, Robert Alexander
    Grove Farm 156 Winsley Road
    BA15 1PA Bradford On Avon
    Wiltshire
    Amministratore
    Grove Farm 156 Winsley Road
    BA15 1PA Bradford On Avon
    Wiltshire
    EnglandBritishCompany Director51678350002
    FORSYTH, Nigel John
    Park Farm Barn
    PO7 4SB Hambledon
    Hampshire
    Amministratore
    Park Farm Barn
    PO7 4SB Hambledon
    Hampshire
    BritishCompany Director59380470002
    HELME, Michael John
    The Coach House
    Main Road, Lea
    DE4 5GJ Matlock
    Amministratore
    The Coach House
    Main Road, Lea
    DE4 5GJ Matlock
    EnglandBritishProfessional Engineer91910030001
    JACOMB, Kenneth Edward
    Holly Tree Farm
    Sandy Lane
    SN12 2QB Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    Holly Tree Farm
    Sandy Lane
    SN12 2QB Chippenham
    Wiltshire
    BritishDirector6425340001
    MEREDITH, Brian Horace
    20a The Street
    Broughton Gifford
    SN12 8PW Melksham
    Wiltshire
    Amministratore
    20a The Street
    Broughton Gifford
    SN12 8PW Melksham
    Wiltshire
    BritishEngineering Director26601600001
    MUNRO, Peter Austin Dods
    Top Acres
    Chapmanslade
    BA13 4AP Westbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Top Acres
    Chapmanslade
    BA13 4AP Westbury
    Wiltshire
    BritishDirector67696410001
    PRICE, David John
    Ashe Hill
    Ashe
    RG25 3AE Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    Ashe Hill
    Ashe
    RG25 3AE Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritishChief Executive75259760004
    RAYNER, Paul Adrian
    48 Kilham Lane
    SO22 5QD Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    48 Kilham Lane
    SO22 5QD Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritishFinance Director45628680002
    TONGE, Richard Leslie
    4 Trimnells
    Colerne
    SN14 8EP Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    4 Trimnells
    Colerne
    SN14 8EP Chippenham
    Wiltshire
    BritishDirector6425360001

    OLD LML LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 21 dic 2006
    Consegnato il 05 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 30 giu 2003
    Consegnato il 05 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture deed
    Creato il 29 set 1999
    Consegnato il 07 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0